ACTIONLEISURE PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéACTIONLEISURE PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00331803
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ACTIONLEISURE PLC ?

    • (7415) /

    Où se situe ACTIONLEISURE PLC ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    London
    SE1 2AF
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ACTIONLEISURE PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAVERDALE GROUP PLC10 juil. 199110 juil. 1991
    ROCK PUBLIC LIMITED COMPANY12 juil. 198312 juil. 1983
    ROCK DARHAM PUBLIC LIMITED COMPANY17 mai 198317 mai 1983
    ROCK DARHAM PUBLIC LIMITED COMPANY22 sept. 193722 sept. 1937

    Quels sont les derniers comptes de ACTIONLEISURE PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour ACTIONLEISURE PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur jusqu'au 21 avr. 2010

    2 pages2.15
    ASSRAKAP

    Avis de décharge de l'ordonnance d'administration

    4 pages2.19
    ASSRJKAY

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur jusqu'au 10 avr. 2010

    2 pages2.15
    A52CVJMT

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur jusqu'au 10 oct. 2009

    2 pages2.15
    AAZMJEUW

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur jusqu'au 10 avr. 2009

    2 pages2.15
    AAZMDEUQ

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur jusqu'au 10 oct. 2008

    3 pages2.15
    AHMY54RB

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur jusqu'au 10 oct. 2008

    3 pages2.15
    AQ7410O0

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    2 pages2.15

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    2 pages2.15

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    2 pages2.15

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    2 pages2.15

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    2 pages2.15

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    2 pages2.15

    legacy

    1 pages288b

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    3 pages2.15

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    3 pages2.15

    legacy

    1 pages287

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    2 pages2.15

    Divers

    C/O replacement of administrator
    14 pagesMISC

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    2 pages2.15

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    2 pages2.15

    legacy

    1 pages287

    Résumé des recettes et paiements de l'administrateur

    2 pages2.15

    Qui sont les dirigeants de ACTIONLEISURE PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EMPTAGE, Christopher
    Rose Hill Farm
    Haddlesey Road
    WF11 9LS Birkin
    West Yorkshire
    Administrateur
    Rose Hill Farm
    Haddlesey Road
    WF11 9LS Birkin
    West Yorkshire
    BritishDirector75702590002
    OUTRAM, Christopher David
    Yeoman's Row
    SW3 2AH London
    22
    Administrateur
    Yeoman's Row
    SW3 2AH London
    22
    United KingdomBritishManagement Consultant138306570001
    DANNHAUSER, David Stephen
    28 Carrington Square
    HA3 6TF Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    28 Carrington Square
    HA3 6TF Harrow
    Middlesex
    British55176170002
    ELLISON, Martin Edward
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector97753620001
    LINTOTT, Graham Gordon
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    British57169010001
    WARWICK, Michael
    65 Chalkwell Esplanade
    SS0 8JH Westcliff On Sea
    Essex
    Secrétaire
    65 Chalkwell Esplanade
    SS0 8JH Westcliff On Sea
    Essex
    BritishSolicitor2979790001
    ADLER, Alan William
    37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Administrateur
    37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Citizen Of UsaManagement Consultant3856820001
    AL ROSTAMANI, Abdullah Hassan
    PO BOX 261
    Dubai
    United Arab Emirates
    Administrateur
    PO BOX 261
    Dubai
    United Arab Emirates
    Uae NationalChairman Al Rostamani Group45928980001
    ANDREWS, Giles Edward Charles
    Flat 36 50 Narrow Street
    E14 8BP London
    Administrateur
    Flat 36 50 Narrow Street
    E14 8BP London
    BritishCompany Director37743280001
    ASPINALL, John Damian Androcles
    Hastings House
    Walton Street
    SW3 1SA London
    Administrateur
    Hastings House
    Walton Street
    SW3 1SA London
    EnglandBritishCompany Director87424600001
    BARBER, Richard Charles
    Dancer's End Lodge
    Dancers End
    HP23 6JY Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    Dancer's End Lodge
    Dancers End
    HP23 6JY Tring
    Hertfordshire
    BritishCompany Director34307140002
    BOLTE, Gunter
    Susenberg Str 158
    Ch 8044 Zurich
    FOREIGN 8044
    Zurich
    Switzerland
    Administrateur
    Susenberg Str 158
    Ch 8044 Zurich
    FOREIGN 8044
    Zurich
    Switzerland
    GermanConsultant67364340001
    DANNHAUSER, David Stephen
    28 Carrington Square
    HA3 6TF Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    28 Carrington Square
    HA3 6TF Harrow
    Middlesex
    BritishCompany Director55176170002
    DUDGEON, James Alexander
    Oban 106 Chene Walk
    SW10 0DC London
    Administrateur
    Oban 106 Chene Walk
    SW10 0DC London
    BritishCompany Director15503380001
    ELLISON, Martin Edward
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector97753620001
    HARTILL, Stanley James
    Old Moss
    Standalone Warren, Haynes
    MK45 3QG Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    Old Moss
    Standalone Warren, Haynes
    MK45 3QG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector126245170001
    LAKMAKER, Gerard
    Greenhill House
    41 Gayton Road
    HA1 2LT Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    Greenhill House
    41 Gayton Road
    HA1 2LT Harrow
    Middlesex
    United KingdomDutchCompany Director15503390001
    LEADLEY, Jeffrey John
    1 Pelham Crescent
    The Park
    NG7 1AR Nottingham
    Administrateur
    1 Pelham Crescent
    The Park
    NG7 1AR Nottingham
    BritishCompany Director45544170001
    LINTOTT, Graham Gordon
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    BritishChartered Accountant57169010001
    NERDRUM, Arild
    30 Carlton Hill
    NW8 0JY London
    Administrateur
    30 Carlton Hill
    NW8 0JY London
    NorwegianCompany Director4137560001
    PACKER, James Douglas
    76 Victoria Road
    Bellevue Hill Sydney Nsw 2023
    FOREIGN
    Australia
    Administrateur
    76 Victoria Road
    Bellevue Hill Sydney Nsw 2023
    FOREIGN
    Australia
    AustralianAssistant General Manager70730270001
    SMITH, Rodney Philip
    Lawling Place
    The Esplanade West
    CM3 6AW Mayland Sea
    Essex
    Administrateur
    Lawling Place
    The Esplanade West
    CM3 6AW Mayland Sea
    Essex
    BritishCompany Director34802220001

    ACTIONLEISURE PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture deed (the "debenture") dated 22ND november 2000 and made between the companies listed in schedule 1 to the debenture and the bank
    Créé le 22 nov. 2000
    Livré le 01 déc. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture deed (the "debenture") dated 22ND november 2000 and made between the companies listed in schedule 1 to the debenture and the bank
    Créé le 22 nov. 2000
    Livré le 30 nov. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of this deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage deed
    Créé le 22 janv. 1997
    Livré le 23 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a or being unit 2 hospital road garngoch industrial estate gorseinon llwchwr swansea with all buildings fixtures (inc, trade) fixed plant and machinery all book and other debts and a an assignment of the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 21 janv. 1997
    Livré le 24 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land and premises in hatfield road st. Albans hertfordshire t/n: HD174617 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery fixed charge on all present and future book and other debtsassigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 21 janv. 1997
    Livré le 24 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at 38 stamford road kettering northampton t/n: 143944 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon fixed charge on all present and future book and other debts assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 16 juin 1995
    Livré le 22 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    64 luton road dunstable beds and all buildings fixtures and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 16 juin 1995
    Livré le 22 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Former british telecom depot ashley road st albans herts and all buildings fixtures and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 avr. 1995
    Livré le 20 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transactions
    • 20 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 28 avr. 1994
    Livré le 03 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being 27 seymour road nuneaton warwickshire land cert no WK83322 with all buildings and fixtures thereon and by way of assignment the goodwill of the business carried on at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit agreement
    Créé le 12 janv. 1993
    Livré le 16 janv. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit with the bank at it's high wycombe branch account number 7306850 see form 395 M371C for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 16 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 28 avr. 1992
    Livré le 08 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being land and buildings on the north west side of seymour road nunneaton warwickshire by way of assignment the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 09 sept. 1991
    Livré le 16 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises k/a carrington works fulwich road dartford kent t/NK458788 together with all buildings & fixtures the goodwill of the company (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 13 déc. 1988
    Livré le 16 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £570,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a land at newman lane, alton, hants.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transactions
    • 16 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 26 févr. 1985
    Livré le 01 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1984
    Livré le 26 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £93,000
    Brèves mentions
    Land and buildings on the north side of gorton road, manchester T.N.:- gm 42827.
    Personnes ayant droit
    • City of Westminster Assurance Company Limited
    Transactions
    • 26 juin 1984Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 20 mars 1984
    Livré le 10 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H - truro works, matilda street, sheffield T.N. - ywe 47843.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 30 nov. 1982
    Livré le 14 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    32 parsonage road, englefield green, egham T.N. SY413161. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 30 nov. 1982
    Livré le 14 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £73,300 and all other moneis due or to become due from the company to the chargee.
    Brèves mentions
    32 parsonage road, englefied green, egham sy 413161.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transactions
    • 14 déc. 1982Enregistrement d'une charge

    ACTIONLEISURE PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 oct. 2001Administration started
    21 avr. 2010Administration discharged
    Administration order
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan David Lewis
    180 Strand
    London
    WC2R 2NT
    practitioner
    180 Strand
    London
    WC2R 2NT
    David Kenneth Duggins
    180 Strand
    London
    WC2R 2NT
    practitioner
    180 Strand
    London
    WC2R 2NT
    Martin Fishman
    Ernst & Young
    Becket House
    SE1 7EU 1 Lambeth Palace Road
    London
    practitioner
    Ernst & Young
    Becket House
    SE1 7EU 1 Lambeth Palace Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0