MERCHANT NOMINEES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MERCHANT NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00332984 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MERCHANT NOMINEES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 25 Savile Row London W1S 2ER |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MERCHANT NOMINEES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour MERCHANT NOMINEES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Andrew Lawler en tant que secrétaire le 02 oct. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy James Kite en tant que secrétaire le 02 oct. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 34 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2009 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Odom en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Damian Mark Alan Wisniewski en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MERCHANT NOMINEES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWLER, David Andrew | Secrétaire | 25 Savile Row London W1S 2ER | 238985260001 | |||||||
| BURNS, John David | Administrateur | Flat 3 33/36 Chester Square SW1W 9HT London | United Kingdom | British | 9820610002 | |||||
| WISNIEWSKI, Damian Mark Alan | Administrateur | Savile Row W1S 2ER London 25 | England | British | 148838200001 | |||||
| KITE, Timothy James | Secrétaire | Arisaig Reading Road North GU51 4HP Fleet Hampshire | British | 107553690001 | ||||||
| MITCHLEY, Simon Colin | Secrétaire | 34 Harris Lane Shenley WD7 9EG Radlett Hertfordshire | British | 53655170004 | ||||||
| WALDRON, Michael | Secrétaire | 14 Wimpole Mews W1G 8PE London | British | 8811160003 | ||||||
| DRIVER, Nicholas Gordon Ellis | Administrateur | Pullens Cottage 2 Leigh Hill Road KT11 2HX Cobham Surrey | England | British | 8811170002 | |||||
| FRIEDLOS, Nicholas Robert | Administrateur | 13 Alwyne Road N1 2HH London | England | British | 61183260002 | |||||
| GEORGE, Nigel Quentin | Administrateur | 32 Lancaster Gardens Wimbledon SW19 5DG London United Kingdom | England | British | 26640150004 | |||||
| JAYSON, Robert Siegbert | Administrateur | 14 Saxon Hall 16 Palace Court W2 4JA London | British | 86049600001 | ||||||
| LINDSAY-REA, Robert David | Administrateur | Flat 7 63-65 Myddelton Square EC1R 1XX London | British | 9746220003 | ||||||
| ODOM, Christopher James | Administrateur | 19 Embercourt Road KT7 0LH Thames Ditton Surrey | British | 20951000001 | ||||||
| PEXTON, Martin Andrew | Administrateur | Little Kensham Farm, Sandhurst Lane Rolvenden TN17 4PH Cranbrook Kent | England | British | 87643530001 | |||||
| RAYNE, Max, Lord | Administrateur | 33 Robert Adam Street W1U 3HR London | British | 35619240001 | ||||||
| RAYNE, Robert Anthony, The Honourable | Administrateur | 37 Brunswick Gardens W8 4AW London | England | British | 53009350001 | |||||
| SILVER, Simon Paul | Administrateur | 49 Hamilton Terrace NW8 9RG London | England | British | 35534690001 | |||||
| SPIER, Robert Fitzhardinge Jenner | Administrateur | The Barn High Street North Stewkley LU7 0EZ Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 8842440001 | ||||||
| WALDRON, Michael | Administrateur | 14 Wimpole Mews W1G 8PE London | British | 8811160003 | ||||||
| WILLIAMS, Paul Malcolm | Administrateur | 24 Kimpton Road Blackmore End Wheathampstead AL4 8LD St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 10072820003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MERCHANT NOMINEES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Merchant Securities Limited | 06 avr. 2016 | Savile Row W1S 2ER London 25 London England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MERCHANT NOMINEES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 29 mars 2006 Livré le 05 avr. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Triangle shopping centre bishopsbriggs glasgow t/no GLA51132. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 30 march 2006 and | Créé le 28 mars 2006 Livré le 19 avr. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from any charging company or any obligor to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The triangle shopping centre kirkintillock road bishopbriggs glasgow t/no GLA51132. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 10/08/04 and | Créé le 21 juil. 2004 Livré le 21 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All and whole the triangle shopping centre kirkintilloch road bishopsbriggs glasgow t/no GLA51132. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 21 juil. 2004 Livré le 31 juil. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The whole of the property, assets and undertaking (including uncalled capital). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A floating charge | Créé le 21 juil. 2004 Livré le 30 juil. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the chargor now and in the future wherever situate.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0