MERCHANT NOMINEES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMERCHANT NOMINEES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00332984
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MERCHANT NOMINEES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe MERCHANT NOMINEES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    25 Savile Row
    London
    W1S 2ER
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MERCHANT NOMINEES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour MERCHANT NOMINEES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr David Andrew Lawler en tant que secrétaire le 02 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Timothy James Kite en tant que secrétaire le 02 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 nov. 2015

    État du capital au 20 nov. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 oct. 2014

    État du capital au 03 oct. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 sept. 2013

    État du capital au 24 sept. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    34 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher Odom en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Damian Mark Alan Wisniewski en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de MERCHANT NOMINEES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAWLER, David Andrew
    25 Savile Row
    London
    W1S 2ER
    Secrétaire
    25 Savile Row
    London
    W1S 2ER
    238985260001
    BURNS, John David
    Flat 3 33/36 Chester Square
    SW1W 9HT London
    Administrateur
    Flat 3 33/36 Chester Square
    SW1W 9HT London
    United KingdomBritish9820610002
    WISNIEWSKI, Damian Mark Alan
    Savile Row
    W1S 2ER London
    25
    Administrateur
    Savile Row
    W1S 2ER London
    25
    EnglandBritish148838200001
    KITE, Timothy James
    Arisaig
    Reading Road North
    GU51 4HP Fleet
    Hampshire
    Secrétaire
    Arisaig
    Reading Road North
    GU51 4HP Fleet
    Hampshire
    British107553690001
    MITCHLEY, Simon Colin
    34 Harris Lane
    Shenley
    WD7 9EG Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    34 Harris Lane
    Shenley
    WD7 9EG Radlett
    Hertfordshire
    British53655170004
    WALDRON, Michael
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    Secrétaire
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    British8811160003
    DRIVER, Nicholas Gordon Ellis
    Pullens Cottage
    2 Leigh Hill Road
    KT11 2HX Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Pullens Cottage
    2 Leigh Hill Road
    KT11 2HX Cobham
    Surrey
    EnglandBritish8811170002
    FRIEDLOS, Nicholas Robert
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    Administrateur
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    EnglandBritish61183260002
    GEORGE, Nigel Quentin
    32 Lancaster Gardens
    Wimbledon
    SW19 5DG London
    United Kingdom
    Administrateur
    32 Lancaster Gardens
    Wimbledon
    SW19 5DG London
    United Kingdom
    EnglandBritish26640150004
    JAYSON, Robert Siegbert
    14 Saxon Hall
    16 Palace Court
    W2 4JA London
    Administrateur
    14 Saxon Hall
    16 Palace Court
    W2 4JA London
    British86049600001
    LINDSAY-REA, Robert David
    Flat 7
    63-65 Myddelton Square
    EC1R 1XX London
    Administrateur
    Flat 7
    63-65 Myddelton Square
    EC1R 1XX London
    British9746220003
    ODOM, Christopher James
    19 Embercourt Road
    KT7 0LH Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    19 Embercourt Road
    KT7 0LH Thames Ditton
    Surrey
    British20951000001
    PEXTON, Martin Andrew
    Little Kensham Farm, Sandhurst Lane
    Rolvenden
    TN17 4PH Cranbrook
    Kent
    Administrateur
    Little Kensham Farm, Sandhurst Lane
    Rolvenden
    TN17 4PH Cranbrook
    Kent
    EnglandBritish87643530001
    RAYNE, Max, Lord
    33 Robert Adam Street
    W1U 3HR London
    Administrateur
    33 Robert Adam Street
    W1U 3HR London
    British35619240001
    RAYNE, Robert Anthony, The Honourable
    37 Brunswick Gardens
    W8 4AW London
    Administrateur
    37 Brunswick Gardens
    W8 4AW London
    EnglandBritish53009350001
    SILVER, Simon Paul
    49 Hamilton Terrace
    NW8 9RG London
    Administrateur
    49 Hamilton Terrace
    NW8 9RG London
    EnglandBritish35534690001
    SPIER, Robert Fitzhardinge Jenner
    The Barn High Street North
    Stewkley
    LU7 0EZ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Barn High Street North
    Stewkley
    LU7 0EZ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British8842440001
    WALDRON, Michael
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    Administrateur
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    British8811160003
    WILLIAMS, Paul Malcolm
    24 Kimpton Road Blackmore End
    Wheathampstead
    AL4 8LD St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    24 Kimpton Road Blackmore End
    Wheathampstead
    AL4 8LD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10072820003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MERCHANT NOMINEES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Savile Row
    W1S 2ER London
    25
    London
    England
    06 avr. 2016
    Savile Row
    W1S 2ER London
    25
    London
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00007064
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    MERCHANT NOMINEES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 mars 2006
    Livré le 05 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Triangle shopping centre bishopsbriggs glasgow t/no GLA51132. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transactions
    • 05 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 30 march 2006 and
    Créé le 28 mars 2006
    Livré le 19 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any obligor to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The triangle shopping centre kirkintillock road bishopbriggs glasgow t/no GLA51132.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 10/08/04 and
    Créé le 21 juil. 2004
    Livré le 21 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the triangle shopping centre kirkintilloch road bishopsbriggs glasgow t/no GLA51132.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 21 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 juil. 2004
    Livré le 31 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The whole of the property, assets and undertaking (including uncalled capital).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 31 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A floating charge
    Créé le 21 juil. 2004
    Livré le 30 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the chargor now and in the future wherever situate.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0