CIM INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCIM INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00335867
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CIM INVESTMENTS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CIM INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CIM INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    S.ROBERTS (LEAD WASHERS) LIMITED15 janv. 193815 janv. 1938

    Quels sont les derniers comptes de CIM INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CIM INVESTMENTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CIM INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 31 mars 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    28 pagesMG01

    legacy

    28 pagesMG01

    Statuts

    39 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Andrew David Livingstone Donald le 12 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de CIM INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DONALD, Andrew David Livingstone
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    Secrétaire
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    BritishCompany Director41075700003
    DONALD, Andrew David Livingstone
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    Administrateur
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    EnglandBritishCompany Director41075700003
    TRAVERS, Richard Benjamin
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    Administrateur
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    EnglandBritishCompany Director103852650001
    HORROCKS, Raymond
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    Secrétaire
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    BritishCompany Director20302800001
    PAPWORTH, Gordon Stanley
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    British3464790001
    RISING, James Edward
    9 Stampley Close
    Winlaton
    NE21 6EW Blaydon
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    9 Stampley Close
    Winlaton
    NE21 6EW Blaydon
    Tyne & Wear
    British77518230001
    WALKER, Jeffrey Ian
    Old Barn
    Whittingslow
    SY6 6PZ Church Stretton
    Shropshire
    Secrétaire
    Old Barn
    Whittingslow
    SY6 6PZ Church Stretton
    Shropshire
    British59308250001
    WITHERS, John Granville
    36 Fern Avenue
    Jesmond
    NE2 2QX Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    36 Fern Avenue
    Jesmond
    NE2 2QX Newcastle Upon Tyne
    British43649100001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4JJ London
    Secrétaire
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4JJ London
    38508390002
    ALLENZA, Antonino
    40 Alderbrook Road
    B91 1NW Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    40 Alderbrook Road
    B91 1NW Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director39237330001
    COOPER, James
    7 Kirkstyle Avenue
    ML8 5AQ Carluke
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Kirkstyle Avenue
    ML8 5AQ Carluke
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director929150002
    DREW, Stephen
    2 The Oaks
    NE46 2PZ Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    2 The Oaks
    NE46 2PZ Hexham
    Northumberland
    BritishOperations Director40955050001
    HORROCKS, Raymond
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    BritishDirector20302800001
    HUDSON, David John
    Pear Tree Cottage Lower Norgrove
    Alfrick
    WR6 5EX Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Pear Tree Cottage Lower Norgrove
    Alfrick
    WR6 5EX Worcester
    Worcestershire
    BritishCompany Director10531420001
    HUDSON, John Lewis
    Inishfree Penn Lane
    Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Inishfree Penn Lane
    Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director12987100004
    LLEWELLYN, Andrew
    Cyfarthfa House
    Wroxton Lane Horley
    OX15 6BD Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Cyfarthfa House
    Wroxton Lane Horley
    OX15 6BD Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector96922350001
    MATHEVE, Jan (Josef Bertha Dymphna Alfons)
    Hermann Rede Machenstrasse 25
    17809 Krefeld
    Nrw
    Germany
    Administrateur
    Hermann Rede Machenstrasse 25
    17809 Krefeld
    Nrw
    Germany
    BelgianDirector57793530001
    NOLAN, John Barry, Dr
    5 Springfield Park
    DH1 4LS Durham
    County Durham
    Administrateur
    5 Springfield Park
    DH1 4LS Durham
    County Durham
    BritishGroup Health Safety & Environment Executive17465620001
    PAPWORTH, Gordon Stanley
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    Administrateur
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary3464790001
    THOMPSON, Alan Sydney
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    Administrateur
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    BritishAccountant111389010001
    THOMPSON, Alan Sydney
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    Administrateur
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    BritishAccountant111389010001
    WIGHTMAN, Timothy Redmayne
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director8610650001

    CIM INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 août 2012
    Livré le 28 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank International
    Transactions
    • 28 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 août 2012
    Livré le 14 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery.. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 14 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 12 mars 1994
    Livré le 29 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the lenders (as defined) under the terms of each or any of the senior finance documents(as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co. Limited (The "Security Agent")
    Transactions
    • 29 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0