R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéR.F.GIDDINGS & CO. LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00341525
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?

    • sciage et rabotage du bois (16100) / Industries manufacturières
    • fabrication d'emballages en bois (16240) / Industries manufacturières

    Où se situe R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o COFFIN MEW LLP
    1000 Lakeside Western Road
    PO6 3EN Portsmouth
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de R.F. Giddings Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC05

    Satisfaction de la charge 003415250012 en totalité

    1 pagesMR04

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 30 mars 2017

    • Capital: GBP 0.01
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancellation of capital redemption reserve 29/03/2017
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 003415250011 en totalité

    1 pagesMR04

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juil. 2015

    État du capital au 28 juil. 2015

    • Capital: GBP 314,600
    SH01

    Inscription de la charge 003415250012, créée le 01 juil. 2015

    8 pagesMR01

    Annulation d'actions. État du capital au 05 sept. 2014

    • Capital: GBP 314,600.00
    4 pagesSH06

    État du capital au 05 sept. 2014

    • Capital: GBP 314,600.00
    5 pagesSH02

    Changement d'adresse du siège social de Ringwood Road Sawmills Ringwood Road Bartley Southampton Hampshire SO40 7LT à C/O Coffin Mew Llp 1000 Lakeside Western Road Portsmouth Hampshire PO6 3EN le 18 août 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Lynda Anne Glover en tant que directeur le 31 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Giddings en tant que directeur le 31 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HACKNEY, Anthony Malcolm
    c/o Coffin Mew Llp
    Western Road
    PO6 3EN Portsmouth
    1000 Lakeside
    Hampshire
    England
    Administrateur
    c/o Coffin Mew Llp
    Western Road
    PO6 3EN Portsmouth
    1000 Lakeside
    Hampshire
    England
    United KingdomBritishDirector173495900001
    JONES, Howard Jeremy
    c/o Coffin Mew Llp
    Western Road
    PO6 3EN Portsmouth
    1000 Lakeside
    Hampshire
    England
    Administrateur
    c/o Coffin Mew Llp
    Western Road
    PO6 3EN Portsmouth
    1000 Lakeside
    Hampshire
    England
    WalesWelshAccountant60571610001
    GIDDINGS, Antony Ronald
    The Hollies Penn Common
    Bramshaw
    SO43 7JN Lyndhurst
    Hampshire
    Secrétaire
    The Hollies Penn Common
    Bramshaw
    SO43 7JN Lyndhurst
    Hampshire
    British15099880001
    GLOVER, Lynda Anne
    Pine View Westwood Road
    Pikes Hill
    SO43 7EH Lyndhurst
    Hampshire
    Secrétaire
    Pine View Westwood Road
    Pikes Hill
    SO43 7EH Lyndhurst
    Hampshire
    British51614890001
    GIDDINGS, Antony Ronald
    The Hollies Penn Common
    Bramshaw
    SO43 7JN Lyndhurst
    Hampshire
    Administrateur
    The Hollies Penn Common
    Bramshaw
    SO43 7JN Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Secretary15099880001
    GIDDINGS, Brian Anthony
    Vale Cottage
    Fritham
    SO43 7HJ Lyndhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Vale Cottage
    Fritham
    SO43 7HJ Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritishSawmill Manager15099910001
    GIDDINGS, Iris May
    Vale Cottage
    Fritham
    SO43 7HJ Lyndhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Vale Cottage
    Fritham
    SO43 7HJ Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritishMarried Woman35842230001
    GIDDINGS, Ivy May
    Cedarwood Ringwood Road
    Bartley
    SO40 7LA Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Cedarwood Ringwood Road
    Bartley
    SO40 7LA Southampton
    Hampshire
    BritishMarried Woman15099900001
    GIDDINGS, John
    Ivylea
    Fritham
    SO43 7HJ Lyndhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Ivylea
    Fritham
    SO43 7HJ Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritishEngineer15099930001
    GIDDINGS, Robert Anthony
    Kelston Ringwood Road
    Bartley
    SO40 7LA Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Kelston Ringwood Road
    Bartley
    SO40 7LA Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishWorks Director15099920001
    GIDDINGS, Ronald Frederick
    Cedarwood Ringwood Road
    Bartley
    SO40 7LA Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Cedarwood Ringwood Road
    Bartley
    SO40 7LA Southampton
    Hampshire
    BritishTimber Merchant15099890001
    GLOVER, Lynda Anne
    Pine View Westwood Road
    Pikes Hill
    SO43 7EH Lyndhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Pine View Westwood Road
    Pikes Hill
    SO43 7EH Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritishSecretary51614890001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    R.F. Giddings Holdings Limited
    1000 Lakeside
    Western Road
    PO6 3EN Portsmouth
    C/O Coffin Mew Llp
    England
    06 avr. 2016
    1000 Lakeside
    Western Road
    PO6 3EN Portsmouth
    C/O Coffin Mew Llp
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement04823017
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 juil. 2015
    Livré le 11 juil. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 11 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 31 juil. 2014
    Livré le 01 août 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The company's present and future patents, trade marks, service marks, trade names, designs, copyrights, inventions, topographical or similar rights, confidential information and know-how and any interest in any of these rights, whether or not registered, including all applications and rights to apply for registration and all fees, royalties and other rights derived from, or incidental to, these rights. All freehold and leasehold properties (whether registered or unregistered) and all commonhold properties, now or in the future (and from time to time) owned by the company, or in which the company holds an interest.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lynda Anne Glover
    • Antony Giddings
    • John Giddings
    Transactions
    • 01 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 janv. 2010
    Livré le 13 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 juin 2006
    Livré le 23 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge over chattels
    Créé le 14 oct. 2005
    Livré le 20 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The fixed assets the proceeds the products. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transactions
    • 20 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge over chattels
    Créé le 10 mai 2004
    Livré le 13 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The fixed assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transactions
    • 13 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture deed
    Créé le 02 déc. 2002
    Livré le 06 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge - book debts
    Créé le 29 avr. 1998
    Livré le 19 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts both present and future owing to the company and the proceeds thereof and the benefit of all rights relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over book debts
    Créé le 09 nov. 1995
    Livré le 16 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 12 juin 1995
    Livré le 23 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h proprety k/a cedarwood ringwood road bartley southampton hampshire t/NOHP497217 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 17 juin 1994
    Livré le 17 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule to form 395 including :- one new mem log unscrambler serial no D6041/93 and one new mem canter serial no C8001/93. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 17 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 14 août 1946
    Livré le 02 sept. 1946
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc
    Brèves mentions
    F/H land at the fording bridge to southampton road, bartley, harts. F/h land at bartley harts & bounded by the road from fording bridge to southamption. Together with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 1946Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0