R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00341525 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?
Adresse du siège social | c/o COFFIN MEW LLP 1000 Lakeside Western Road PO6 3EN Portsmouth Hampshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de R.F. Giddings Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 003415250012 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 30 mars 2017
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2016 | 23 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 8 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 003415250011 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2015 | 23 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Inscription de la charge 003415250012, créée le 01 juil. 2015 | 8 pages | MR01 | ||||||||||||||
Annulation d'actions. État du capital au 05 sept. 2014
| 4 pages | SH06 | ||||||||||||||
État du capital au 05 sept. 2014
| 5 pages | SH02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ringwood Road Sawmills Ringwood Road Bartley Southampton Hampshire SO40 7LT à C/O Coffin Mew Llp 1000 Lakeside Western Road Portsmouth Hampshire PO6 3EN le 18 août 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Lynda Anne Glover en tant que directeur le 31 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de John Giddings en tant que directeur le 31 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACKNEY, Anthony Malcolm | Administrateur | c/o Coffin Mew Llp Western Road PO6 3EN Portsmouth 1000 Lakeside Hampshire England | United Kingdom | British | Director | 173495900001 | ||||
JONES, Howard Jeremy | Administrateur | c/o Coffin Mew Llp Western Road PO6 3EN Portsmouth 1000 Lakeside Hampshire England | Wales | Welsh | Accountant | 60571610001 | ||||
GIDDINGS, Antony Ronald | Secrétaire | The Hollies Penn Common Bramshaw SO43 7JN Lyndhurst Hampshire | British | 15099880001 | ||||||
GLOVER, Lynda Anne | Secrétaire | Pine View Westwood Road Pikes Hill SO43 7EH Lyndhurst Hampshire | British | 51614890001 | ||||||
GIDDINGS, Antony Ronald | Administrateur | The Hollies Penn Common Bramshaw SO43 7JN Lyndhurst Hampshire | England | British | Company Secretary | 15099880001 | ||||
GIDDINGS, Brian Anthony | Administrateur | Vale Cottage Fritham SO43 7HJ Lyndhurst Hampshire | England | British | Sawmill Manager | 15099910001 | ||||
GIDDINGS, Iris May | Administrateur | Vale Cottage Fritham SO43 7HJ Lyndhurst Hampshire | England | British | Married Woman | 35842230001 | ||||
GIDDINGS, Ivy May | Administrateur | Cedarwood Ringwood Road Bartley SO40 7LA Southampton Hampshire | British | Married Woman | 15099900001 | |||||
GIDDINGS, John | Administrateur | Ivylea Fritham SO43 7HJ Lyndhurst Hampshire | England | British | Engineer | 15099930001 | ||||
GIDDINGS, Robert Anthony | Administrateur | Kelston Ringwood Road Bartley SO40 7LA Southampton Hampshire | England | British | Works Director | 15099920001 | ||||
GIDDINGS, Ronald Frederick | Administrateur | Cedarwood Ringwood Road Bartley SO40 7LA Southampton Hampshire | British | Timber Merchant | 15099890001 | |||||
GLOVER, Lynda Anne | Administrateur | Pine View Westwood Road Pikes Hill SO43 7EH Lyndhurst Hampshire | England | British | Secretary | 51614890001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.F. Giddings Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 1000 Lakeside Western Road PO6 3EN Portsmouth C/O Coffin Mew Llp England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
R.F.GIDDINGS & CO. LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 01 juil. 2015 Livré le 11 juil. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 31 juil. 2014 Livré le 01 août 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description The company's present and future patents, trade marks, service marks, trade names, designs, copyrights, inventions, topographical or similar rights, confidential information and know-how and any interest in any of these rights, whether or not registered, including all applications and rights to apply for registration and all fees, royalties and other rights derived from, or incidental to, these rights. All freehold and leasehold properties (whether registered or unregistered) and all commonhold properties, now or in the future (and from time to time) owned by the company, or in which the company holds an interest. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 janv. 2010 Livré le 13 janv. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 15 juin 2006 Livré le 23 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge over chattels | Créé le 14 oct. 2005 Livré le 20 oct. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The fixed assets the proceeds the products. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge over chattels | Créé le 10 mai 2004 Livré le 13 mai 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The fixed assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture deed | Créé le 02 déc. 2002 Livré le 06 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge - book debts | Créé le 29 avr. 1998 Livré le 19 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book debts both present and future owing to the company and the proceeds thereof and the benefit of all rights relating thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over book debts | Créé le 09 nov. 1995 Livré le 16 nov. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 juin 1995 Livré le 23 juin 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h proprety k/a cedarwood ringwood road bartley southampton hampshire t/NOHP497217 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattels mortgage | Créé le 17 juin 1994 Livré le 17 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule to form 395 including :- one new mem log unscrambler serial no D6041/93 and one new mem canter serial no C8001/93. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 14 août 1946 Livré le 02 sept. 1946 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due etc | |
Brèves mentions F/H land at the fording bridge to southampton road, bartley, harts. F/h land at bartley harts & bounded by the road from fording bridge to southamption. Together with all fixtures. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0