TKR INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTKR INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00341757
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TKR INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TKR INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Aeromet Building
    Cosgrove Close
    WR3 8UA Worcester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TKR INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TECHNICAL COMPONENTS (AEROSPACE) LIMITED04 mars 199204 mars 1992
    DRUMOWEN (1988) LIMITED01 janv. 198801 janv. 1988
    TRUFLO LIMITED24 juin 193824 juin 1938

    Quels sont les derniers comptes de TKR INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour TKR INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 mai 2016

    État du capital au 29 mai 2016

    • Capital: GBP 2,384,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 avr. 2016

    État du capital au 19 avr. 2016

    • Capital: GBP 2,384,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Darren Armour en tant que directeur le 27 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Stephen Charles Keating en tant qu'administrateur le 23 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 10 Norwich Street London EC4A 1BD à Aeromet Building Cosgrove Close Worcester WR3 8UA le 08 août 2015

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Peter J Statile en tant que directeur le 23 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jeffrey Howard Smith en tant que directeur le 23 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Bibi Rahima Ally en tant que secrétaire le 23 juil. 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 avr. 2015

    État du capital au 21 avr. 2015

    • Capital: GBP 2,384,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 avr. 2014

    État du capital au 09 avr. 2014

    • Capital: GBP 2,384,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TKR INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KEATING, Stephen Charles
    Cosgrove Close
    WR3 8UA Worcester
    Aeromet Building
    England
    Administrateur
    Cosgrove Close
    WR3 8UA Worcester
    Aeromet Building
    England
    United KingdomBritish152085790008
    ALLY, Bibi Rahima
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    Secrétaire
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    British38963210007
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Secrétaire
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British32267100002
    GILROY, Brian Hugh
    2 Addington Close
    SG16 6LX Henlow
    Bedfordshire
    Secrétaire
    2 Addington Close
    SG16 6LX Henlow
    Bedfordshire
    British15268260001
    LAWTON, Kirsten
    31 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    31 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    British50045660001
    PRICE, Edmund John
    Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road
    GU18 5UJ Lightwater
    Surrey
    Secrétaire
    Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road
    GU18 5UJ Lightwater
    Surrey
    British45119510001
    STEVEN, Brian Joseph Bonthrone
    1 Chancellors Mews
    Mount Ephraim
    CT6 7LB Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    1 Chancellors Mews
    Mount Ephraim
    CT6 7LB Tunbridge Wells
    Kent
    British59294120002
    SYMONDS, Sheryl A
    9007 Olympic View Drive
    Edmonds
    Washington 98026
    Usa
    Secrétaire
    9007 Olympic View Drive
    Edmonds
    Washington 98026
    Usa
    American59952540001
    ARMOUR, Darren
    Eurolink Way
    ME10 3HH Sittingbourne
    Unit 12c
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Eurolink Way
    ME10 3HH Sittingbourne
    Unit 12c
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish164519510001
    CHIESE, Ross Anthony Norman
    14 Bishops Avenue
    HA6 3DG Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    14 Bishops Avenue
    HA6 3DG Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish78101050001
    CROPLEY, Colin
    New Ash
    Holwell Road
    SG5 3SL Holwell
    Hertfordshire
    Administrateur
    New Ash
    Holwell Road
    SG5 3SL Holwell
    Hertfordshire
    British87040350001
    DANSON, Ronald Victor
    46 Common Road
    Stotfold
    SG5 4DB Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    46 Common Road
    Stotfold
    SG5 4DB Hitchin
    Hertfordshire
    British14011610001
    DORVAL, Alan D
    28 Cook Mtn Road
    Vassalboro
    Maine 04989
    Usa
    Administrateur
    28 Cook Mtn Road
    Vassalboro
    Maine 04989
    Usa
    Us Citizen105076580001
    GERDE, Nick A
    1906 Rocklund Drive
    Wenatchee Washington 98801
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    1906 Rocklund Drive
    Wenatchee Washington 98801
    FOREIGN Usa
    American59687680001
    GILROY, Brian Hugh
    2 Addington Close
    SG16 6LX Henlow
    Bedfordshire
    Administrateur
    2 Addington Close
    SG16 6LX Henlow
    Bedfordshire
    British15268260001
    GRINDY, Roger Sydney
    2 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    Administrateur
    2 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    British8369140001
    MCCONNELL, John
    11 St Johns Road
    GU9 8NT Farnham
    Surrey
    Administrateur
    11 St Johns Road
    GU9 8NT Farnham
    Surrey
    British52229730002
    MCINNES, Bruce Gordon, Doctor
    5 Paget Place
    Warren Road
    KT2 7HZ Coombe Hill
    Surrey
    Administrateur
    5 Paget Place
    Warren Road
    KT2 7HZ Coombe Hill
    Surrey
    British2311870001
    MERRITT, John Brian
    The Bungalow North Lane
    Nomansland
    SP5 2BU Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    The Bungalow North Lane
    Nomansland
    SP5 2BU Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish46339220001
    MIRACLE, Charles Amos
    1920 Pensione Place
    Wenatchee
    Wa 98801
    Usa
    Administrateur
    1920 Pensione Place
    Wenatchee
    Wa 98801
    Usa
    American81570230001
    NOBLE, Trevor Thomas
    15 The Sycamores
    Scawthorpe
    DN5 7UH Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    15 The Sycamores
    Scawthorpe
    DN5 7UH Doncaster
    South Yorkshire
    British44716970001
    PERKINS, John Anthony
    Southbroom 22 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    Southbroom 22 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    Irish1809090006
    PRICE, Edmund John
    Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road
    GU18 5UJ Lightwater
    Surrey
    Administrateur
    Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road
    GU18 5UJ Lightwater
    Surrey
    British45119510001
    SMITH, Jeffrey Howard
    Eurolink Way
    ME10 3RN Sittingbourne
    Unit 12c
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Eurolink Way
    ME10 3RN Sittingbourne
    Unit 12c
    Kent
    United Kingdom
    British85037540001
    STATILE, Peter J
    37 Belfast Avenue
    Staten Island
    New York
    Ny-10306
    Usa
    Administrateur
    37 Belfast Avenue
    Staten Island
    New York
    Ny-10306
    Usa
    Us Citizen105076980001
    SWALE, William
    2 Springfield
    Dunton
    SG18 8RG Biggleswade
    Bedfordshire
    Administrateur
    2 Springfield
    Dunton
    SG18 8RG Biggleswade
    Bedfordshire
    British18925950001
    WRIGHT, Donald A
    430 Olds Station Road
    Wenatchee
    Washington 98801
    Usa
    Administrateur
    430 Olds Station Road
    Wenatchee
    Washington 98801
    Usa
    American59687210003
    BAKER STREET CORPORATE SERVICES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    50433100001
    COACH HOUSE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    43767230002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TKR INTERNATIONAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Aeromet International Limited
    Cosgrove Close
    WR3 8UA Worcester
    Aeromet Building
    England
    06 avr. 2016
    Cosgrove Close
    WR3 8UA Worcester
    Aeromet Building
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement01626585
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    TKR INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 29 sept. 1986
    Livré le 08 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situate at tipton, west midlands containing an area of 3 acres 1 rood and twenty perches. Strip of land adjoining the premises described above containing 316 sq yds together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC.
    Transactions
    • 08 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 06 août 1985
    Livré le 12 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 août 1985Enregistrement d'une charge
    Letter of offset
    Créé le 06 août 1985
    Livré le 12 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or hereafter to become due from time to time from west park limited and drumowen LTD. To the governor and company of the bank of scotland in any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All monies now or any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 août 1985Enregistrement d'une charge
    Supplemental charge
    Créé le 06 août 1985
    Livré le 12 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on the book debts and other debts due or owing to the company both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC.
    Transactions
    • 12 août 1985Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 17 déc. 1980
    Livré le 02 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or westpark limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    Subordinated debenture stock
    Créé le 17 déc. 1980
    Livré le 24 déc. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £800,000
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Wilmont Breeden (Holdings) LTD.
    Transactions
    • 24 déc. 1980Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 1980
    Livré le 23 déc. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at station street, and park lane, east tipton and land at tarne road and dulverton road witton. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • I.C.F.C. Limited
    Transactions
    • 23 déc. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0