DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED

DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00344823
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DEBENHAMS PROPERTIES LIMITED20 août 199720 août 1997
    FREEBODY PROPERTIES LIMITED20 févr. 198420 févr. 1984
    DEBENHAMS (PROPERTIES) LIMITED30 sept. 193830 sept. 1938

    Quels sont les derniers comptes de DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 août 2019
    Date d'échéance des prochains comptes31 août 2020
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 sept. 2018

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au05 juil. 2020
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation16 août 2020
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au05 juil. 2019
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    38 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    36 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    47 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    37 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    44 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    45 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    45 pagesAM10

    Changement d'adresse du siège social de Bedford House Park Street Taunton Somerset TA1 4DB England à 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU le 17 août 2021

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    41 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name09 févr. 2021

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Changement d'adresse du siège social de 334 - 348 Oxford Street London W1C 1JG England à Bedford House Park Street Taunton Somerset TA1 4DB le 08 févr. 2021

    1 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    48 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    12 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    101 pagesAM03

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    11 pagesCVA4

    Cessation de la nomination de Sally Hopwood en tant que secrétaire le 09 avr. 2020

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DARWALL, Alice Ann
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Secrétaire
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    257967880001
    EARDLEY, Paul Rex
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Secrétaire
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    254483480001
    EARDLEY, Paul Rex
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Secrétaire
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    British74477320006
    HARRISON, Rosalynde
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Secrétaire
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    251921990001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Secrétaire
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    HOPWOOD, Sally
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Secrétaire
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    268365760001
    JOHNSON, Guy Antony
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Secrétaire
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    British29729020004
    SMITH, Philip Clayton
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    Secrétaire
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    British613980001
    DEBENHAMS PLC
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10 Brock Street
    Secrétaire
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10 Brock Street
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5448421
    313829910001
    ADAMS, David
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Administrateur
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    EnglandBritish239339020001
    BATES, David John
    11 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    11 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish613990001
    BROWN, David Nigel
    8 Flora Grove
    AL1 5ET St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Flora Grove
    AL1 5ET St Albans
    Hertfordshire
    British40354400002
    BUCHER, Sergio Rodriguez
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomSpanish216512370001
    CLIFFORD-KING, Martin
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British77456620001
    COATES, David Peter
    Stamford Lodge
    37 Priestlands Park Road
    DA15 7HJ Sidcup
    Kent
    Administrateur
    Stamford Lodge
    37 Priestlands Park Road
    DA15 7HJ Sidcup
    Kent
    British56148130001
    DUDDY, Terence
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Administrateur
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    EnglandBritish256736950001
    HARLOW, Suzanne
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish183585370001
    HAZELL, Mike
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Administrateur
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    United KingdomBritish263031350001
    HERRICK, Simon Edward
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish70414940003
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Administrateur
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Administrateur
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    JOHNSON, Guy Antony
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Administrateur
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    British29729020004
    KILBEY, Graham John
    20 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QJ Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    20 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QJ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish150198820001
    LOVERING, John David
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Administrateur
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    United KingdomBritish73573160004
    MURPHY, James William
    Pheasants Copse
    Rotherfield Greys
    RG9 4QJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Pheasants Copse
    Rotherfield Greys
    RG9 4QJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    NoneBritish4145300002
    OSBORNE, Rachel Claire Elizabeth
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Administrateur
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United KingdomBritish250468300001
    ROBERTS, Edward Matthew Giles
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Administrateur
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    British54689210005
    SHARP, Michael John Todkill
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish153448810002
    SHEPHERD, Jessica Louise
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Administrateur
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United KingdomBritish252987620001
    SKINNER, Patricia Valda
    11 Manor Drive
    NW7 3ND London
    Administrateur
    11 Manor Drive
    NW7 3ND London
    United KingdomBritish28667500001
    SMITH, David
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish245720490001
    SMITH, Matthew George
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish194410880002
    SMITH, Philip Clayton
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    Administrateur
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    British613980001
    TEMPLEMAN, Robert William
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Administrateur
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    UkBritish88293210002
    TIMMINS, Gail
    4 Oldean Close
    Tilehurst
    RG31 5QA Reading
    Berkshire
    Administrateur
    4 Oldean Close
    Tilehurst
    RG31 5QA Reading
    Berkshire
    EnglandBritish56148250002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Celine Group Holdings Limited
    Oxford Street
    W1C 1JG London
    334-348
    England
    06 avr. 2016
    Oxford Street
    W1C 1JG London
    334-348
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementDebenhams Properties Limited
    Numéro d'enregistrement3430071
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 janv. 2020
    Livré le 28 janv. 2020
    En cours
    Brève description
    Argentine trade mark registration number 2421249 and the additional ip listed in part 6 intellectual property rights) of schedule 2 of the attached charging document.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited as Security Agent
    Transactions
    • 28 janv. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 oct. 2019
    Livré le 18 oct. 2019
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited as Security Agent
    Transactions
    • 18 oct. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 avr. 2019
    Livré le 11 avr. 2019
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transactions
    • 11 avr. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 mars 2019
    Livré le 01 avr. 2019
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transactions
    • 01 avr. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 11 févr. 2019
    Livré le 19 févr. 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transactions
    • 19 févr. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 avr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession and charge
    Créé le 27 juin 2005
    Livré le 06 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee, as owed or incurred by each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse,London Branch
    Transactions
    • 06 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 avr. 2004
    Livré le 06 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the beneficial owner (roadstream limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land and buildings k/a store a, the st david's centre, cardiff, south glamorgan t/n:WA546525. L/h land and buildings k/a 275-287 (odd) station road, harrow t/n:NGL274785.for details of further properties charged please refer to form 395.first fixed charge: all of its rights and benefit under any agreement relating to the acquisition of the mortgaged properties, all plant and machinery, all of its benefits, claims and returns of premiums in respect of the insurances, all of its right, title and interest (if any) under the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Landesbank (Acting Through Its London Branch as Security Agent for Itself and Theother Beneficiaries)
    Transactions
    • 06 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession and charge
    Créé le 19 déc. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security agent for the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston, London Branch as Security Agent
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission pursuant to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 01/04/86
    Créé le 23 juil. 1986
    Livré le 05 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever supplemental to a letter of set-off dated 1/4/86
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 13 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Omnibus guarantee & setoff agreement
    Créé le 01 avr. 1986
    Livré le 11 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 13 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 mai 2019Date of meeting to approve CVA
    06 avr. 2020Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    James Robert Tucker
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Edward George Boyle
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    2
    DateType
    09 avr. 2020Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Geoffrey Paul Rowley
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0