G T SMITH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéG T SMITH LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 00347946
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de G T SMITH LIMITED ?

    • (5212) /

    Où se situe G T SMITH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de G T SMITH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    G.T.SMITH AND SONS LIMITED02 janv. 193902 janv. 1939

    Quels sont les derniers comptes de G T SMITH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 janv. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour G T SMITH LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour G T SMITH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Certificat d'immatriculation d'une société de secours mutuel

    CERTIPS

    Divers

    Convert to I & ps
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to I & ps 17/06/2011
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 01 janv. 2011

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 sept. 2010

    État du capital au 20 sept. 2010

    • Capital: GBP 368,500
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Hurrell le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Humes le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2010

    3 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 11 janv. 2010 au 02 janv. 2010

    1 pagesAA01

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 10 janv. 2009

    3 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 12 janv. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Qui sont les dirigeants de G T SMITH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    BritishCompany Secretary45801060004
    HUMES, Stephen
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Administrateur
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Administrateur
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritishGeneral Manager - Food Group99724260001
    CLARKE, Geoffrey
    9 Whitehouse Avenue
    Woodlesford
    LS26 8BN Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    9 Whitehouse Avenue
    Woodlesford
    LS26 8BN Leeds
    West Yorkshire
    British14604290001
    SMITH, Simon Lawrence
    10 Beechwood Dale
    Ackworth
    WF7 7NP Pontefract
    West Yorkshire
    Secrétaire
    10 Beechwood Dale
    Ackworth
    WF7 7NP Pontefract
    West Yorkshire
    British48625890001
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Administrateur
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritishChartered Accountant87486660004
    HINDLE, David
    76 Portree Drive
    CW4 7JF Holmes Chapel
    Cheshire
    Administrateur
    76 Portree Drive
    CW4 7JF Holmes Chapel
    Cheshire
    BritishDirector82227250001
    HOLLAND, Joseph
    87 Chapleton Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    87 Chapleton Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director14141950001
    HOPE, Julie Andrea
    Silverstone New Road
    Badsworth
    WF9 1AT Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    Silverstone New Road
    Badsworth
    WF9 1AT Pontefract
    West Yorkshire
    BritishNon Foods Director18163680001
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishRetailer106997230001
    SCROGGS, Susan Clare
    Paddock House
    Hillam Hall Lane
    LS25 5HL Hillam
    North Yorkshire
    Administrateur
    Paddock House
    Hillam Hall Lane
    LS25 5HL Hillam
    North Yorkshire
    BritishManufacturing Director18163610004
    SMITH, Antony Gerald
    2 Sutton Lane
    Byram
    WF11 9DL Knottingley
    West Yorkshire
    Administrateur
    2 Sutton Lane
    Byram
    WF11 9DL Knottingley
    West Yorkshire
    BritishFresh Foods Director87283650001
    SMITH, David Harold
    128 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    128 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    BritishManaging Director18163620001
    SMITH, Gerald West
    Fairleigh Wakefield Road
    WF8 4HB Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    Fairleigh Wakefield Road
    WF8 4HB Pontefract
    West Yorkshire
    BritishChief Executive14604310001
    SMITH, Harold Gordon
    Stable House
    Wentbridge
    WF8 3JP Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    Stable House
    Wentbridge
    WF8 3JP Pontefract
    West Yorkshire
    BritishTrading Director14604300001
    SMITH, Richard Gordon
    23 Windsor Rise
    WF8 4PZ Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    23 Windsor Rise
    WF8 4PZ Pontefract
    West Yorkshire
    BritishTrading Director18163630001
    SMITH, Simon Lawrence
    10 Beechwood Dale
    Ackworth
    WF7 7NP Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    10 Beechwood Dale
    Ackworth
    WF7 7NP Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director48625890001

    G T SMITH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2001
    Livré le 27 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a supermarket buildings and land lying to the south east and south west sides of leeds road outwood wakefield west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 mars 1998
    Livré le 31 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit at malvern road, knottingley, west yorkshire title number WYK399242.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 21 sept. 1994
    Livré le 21 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things being new kirwin refrigeration equipment as described in the schedule attached to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 21 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 sept. 1992
    Livré le 06 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Supermarket premises high street kippax west yorkshire title no WYK509993.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 sept. 1992
    Livré le 06 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north west side of valley street moorthorpe wakefield west yorkshire title no WYK203917.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 sept. 1992
    Livré le 06 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on tthe west side of marine villa road knottingley west yorkshire title no WYK265945.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 sept. 1992
    Livré le 06 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at carlton street and sagar street castleford west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 sept. 1992
    Livré le 06 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings hill top knottingley west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 sept. 1992
    Livré le 06 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings towngate ossett west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 sept. 1992
    Livré le 06 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at the junction of wakefield road and barnsley road ackworth west yorkshire title no WYK191333.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 mai 1987
    Livré le 19 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    13/19 doncaster road, goldthorpe barnsley south yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 01 mai 1987
    Livré le 19 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings at the junctions of wakefield road & barnsley road ackworth near pontefract west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 09 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 1982
    Livré le 25 mai 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H plot of land on the S.W. of green road and on the S.W. of green road and on the N.W. side of monk bridge road, meanwood leeds. Title no:- wyk 182028.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 1982Enregistrement d'une charge
    • 09 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further charge
    Créé le 23 janv. 1981
    Livré le 26 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage dated 29.4.74
    Brèves mentions
    1) supermarket premises carlton street, castleford 2) supermarket premises towngate ossett. 3) supermarket premises hill top knottingley.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Co LTD.
    Transactions
    • 26 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    • 06 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 1980
    Livré le 14 août 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property being:- 1 market place, 1 and 3 gillygate and 1 to 7 holmes chambers, pontefract, west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 1980Enregistrement d'une charge
    • 09 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 mars 1980
    Livré le 19 mars 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold the mansion house & land adjoining, marine villa road, knottingley, west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mars 1980Enregistrement d'une charge
    • 09 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 14 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H plot of land at barnsley road, moorthorpe, south elmsall, pontefract with no. 268, barnsley road, aforesaid, thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 09 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 29 avr. 1974
    Livré le 06 mai 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £300,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    (1) 41 & 43 high st normanton (2) 48, 50, 52 & 54 carlton st & 14/16, 18, 20 sagar st castleford. (3) site of no 1 wesley st castleford (4) 18/22 market place pontefract (5) supermarket premises towngate ossett(6) supermarket premises hill top knottingley.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transactions
    • 06 mai 1974Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 07 avr. 1972
    Livré le 19 avr. 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present goodwill and future including uncalled capital. By way of fixed & floating charge see doc 56 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1972Enregistrement d'une charge
    • 09 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 déc. 1960
    Livré le 13 janv. 1961
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,060 and any further advances.
    Brèves mentions
    76, nevison avenue, pontefract, york.
    Personnes ayant droit
    • Bradford Permemant Building Society
    Transactions
    • 13 janv. 1961Enregistrement d'une charge
    • 06 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0