ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROANDO DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00349263
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROANDO HOLDINGS LIMITED06 févr. 193906 févr. 1939

    Quels sont les derniers comptes de ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 mars 2013

    État du capital au 19 mars 2013

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2012

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2011

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    13 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    14 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George White le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Maurice Moses Benady le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Trafalgar Officers Limited le 28 févr. 2010

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Reit(Corporate Services) Limited le 09 déc. 2009

    1 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    14 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Qui sont les dirigeants de ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6745658
    135316290001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Secrétaire
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Administrateur
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Administrateur
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Administrateur
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Administrateur
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    PARRISH, Trevor Lawton
    46 Congreve Way
    Bardsey
    LS17 9BG Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    46 Congreve Way
    Bardsey
    LS17 9BG Leeds
    West Yorkshire
    British15527330001
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 27 oct. 1995
    Livré le 10 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage land and buildings on the west side of millshaw, beeston, leeds, west yorkshire t/nos. WYK488274 and WYK193393 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 juin 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 oct. 1995
    Livré le 01 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage:-all that f/h land and buildings k/as 22-30 (even) new york street and 13 & 15 harper street leeds west yorkshire.t/no.wyk 541898 the present or future goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 juin 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 sept. 1994
    Livré le 14 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 6TH june 1994 and/or any other related facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    Land on east of tramway road irlam t/n GM259157 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 sept. 1994
    Livré le 14 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever pursuant to the term loan facility letter dated 6TH june 1994 and/or any other related financial documents (as defined)
    Brèves mentions
    Property k/a 6 tyrawley road london t/n LN103163 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 sept. 1994
    Livré le 14 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    44 to 60 (even) richarshaw lane pudsey t/n WYK420976 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 avr. 1993
    Livré le 21 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities which now are or at any time herafter may become due from the company to lloyds bank PLC ("the bank") under or in respect of such part of the company's guarantee liability to the bank as may arise from facilities granted to evans (holdings) limited pursuant to a loan agreement dated the 2ND april 1993 on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 10 manor street leeds together with all buildings and fixtures thereon and goods, by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on at the property aforesaid, by way of assignment the benefit of all guarantees or covenants (as defined).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 mars 1993
    Livré le 29 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and/or evans universal limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that the f/h land and premises k/a land and buildings on the south side of manor street leeds t/no.WYK315874.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia
    Transactions
    • 29 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds
    Créé le 20 août 1992
    Livré le 24 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    6 tyrawley road fulham london.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds
    Créé le 07 févr. 1991
    Livré le 15 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    44/160 (even numbers) richardshaw lane, pudsey title no wyk 420976.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 11 juin 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds
    Créé le 07 févr. 1991
    Livré le 15 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Thames trading centre, fairbells road, irlam manchester title no gm 259157.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 11 juin 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of deposit
    Créé le 20 mars 1989
    Livré le 29 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Deeds & documents relating to the f/h property k/a land situate at millshaw beeston leeds.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 juin 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of charge
    Créé le 16 mars 1984
    Livré le 17 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from evans universal limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All that property situate at rawdon with all fixtures fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 28 août 1979
    Livré le 11 sept. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from rowland winn/harrogage limited and/or l hudson (yorks) limited
    Brèves mentions
    17, 18, 19 & 20 york place harrogate west yorks.
    Personnes ayant droit
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transactions
    • 11 sept. 1979Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 24 nov. 1975
    Livré le 16 déc. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from rowland winn (barnsley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    The west side of bredford road, batley, yorkshire together with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1975Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 24 nov. 1975
    Livré le 16 déc. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from rowland winn (barnsley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Three parcels of land fronting john street & thomas street, barnsley, yorkshire together with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1975Enregistrement d'une charge
    • 04 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 24 nov. 1975
    Livré le 16 déc. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    17, 18, 19 & 20 york place, harrogate together with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1975Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 24 nov. 1975
    Livré le 16 déc. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    New street & john street, barnsley yorkshire, together with all fixtutes.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1975Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 30 juil. 1975
    Livré le 06 août 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situated in new street and john street, barusley, west riding, yorks. Together with all buildings erected thereon. (See doc 123 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Mercantile Credit Co LTD
    Transactions
    • 06 août 1975Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 30 juil. 1975
    Livré le 06 août 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from rowland winn (batley) LTD and/or all or any of the other companies named therein. To the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land on the west side of bradford road, batley, west riding, yorkshire. With buildings erected thereon. (See doc 122 for details).
    Personnes ayant droit
    • Mercantile Credit Co LTD
    Transactions
    • 06 août 1975Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 30 juin 1972
    Livré le 06 juil. 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on south side of santengley lane, crofton, yorks.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1972Enregistrement d'une charge
    Memo of deposit
    Créé le 13 nov. 1967
    Livré le 30 nov. 1967
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at altofts, normanton. Title no. Yk 17464.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 1967Enregistrement d'une charge
    Instrument of charge
    Créé le 28 avr. 1967
    Livré le 07 mai 1967
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc
    Brèves mentions
    Land & buildings at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, park grove, & joiners workshop & garage in park terraces for headingley, leeds.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank LTD
    Transactions
    • 07 mai 1967Enregistrement d'une charge
    Charge by deposit of deeds
    Créé le 01 févr. 1967
    Livré le 22 févr. 1967
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc.
    Brèves mentions
    Land at south and south west side of durkar low lane, durker, wakefield, yorks.
    Personnes ayant droit
    • The Yorkshire Bank LTD
    Transactions
    • 22 févr. 1967Enregistrement d'une charge
    Memorandum of deposit
    Créé le 11 août 1966
    Livré le 15 août 1966
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc.
    Brèves mentions
    F/H land near broadowler lane, ossett.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 août 1966Enregistrement d'une charge
    Instr of charge
    Créé le 23 mai 1966
    Livré le 23 mai 1966
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings on west side of boston road, aforesaid. Title no. Yk 3815.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 1966Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0