TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED

TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00349879
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Frp Advisory Llp 4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TAYLOR-BLOXHAM LIMITED23 févr. 193923 févr. 1939

    Quels sont les derniers comptes de TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    36 pagesAM23

    Avis de nomination d'un administrateur remplaçant ou supplémentaire

    3 pagesAM11

    Avis de l'ordonnance de révocation de l'administrateur de ses fonctions

    17 pagesAM16

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    29 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    65 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de 17-21 Tolwell Road Leicester Leicestershire LE4 1BR à C/O Frp Advisory Llp 4th Floor Abbey House Booth Street Manchester M2 4AB le 14 févr. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2018

    29 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jacqueline Sharpless le 28 mai 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Charles Lockwood le 01 juin 2019

    2 pagesCH01

    Nomination de Mrs Teresa-Anne Dunleavy en tant qu'administrateur le 20 mai 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Graham John Farrell en tant que directeur le 01 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 24 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 003498790025 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Kevin Moss en tant que directeur le 01 juin 2018

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name01 mai 2018

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms April Jacqueline Sharpless le 14 mars 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs April Jacqueline Moss le 14 mars 2018

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUNLEAVY, Teresa-Anne
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    Administrateur
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    EnglandBritish137425310001
    LOCKWOOD, Robert Charles
    College Barn
    Thornborough Road Padbury
    MK18 2AH Buckingham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    College Barn
    Thornborough Road Padbury
    MK18 2AH Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish98046670002
    SHARPLESS, April Jacqueline
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    Administrateur
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    EnglandBritish150002490008
    SHARPLESS, Jacqueline
    Swinfield Road
    Quorn
    LE12 8RJ Loughborough
    10
    England
    Administrateur
    Swinfield Road
    Quorn
    LE12 8RJ Loughborough
    10
    England
    EnglandBritish7436780002
    SYKES, Wesley Mark
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Co Frp Advisory Llp
    England
    Administrateur
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Co Frp Advisory Llp
    England
    EnglandBritish29975680002
    WENNINGTON, Matthew Robert
    23 Navigation Drive
    Glen Parva
    LE2 9TB Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    23 Navigation Drive
    Glen Parva
    LE2 9TB Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish78232170002
    BERRY, David
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Secrétaire
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    British30955700001
    SHARPLESS, Jacqueline
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    British7436780001
    BOWEN, Christopher Paul
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Administrateur
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    United KingdomBritish71847370001
    FARRELL, Graham John
    6 Orlando Close
    CV22 6LT Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    6 Orlando Close
    CV22 6LT Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritish126763280001
    FARRELL, Graham John
    24 Russell Avenue
    Dunchurch
    CV22 6PX Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    24 Russell Avenue
    Dunchurch
    CV22 6PX Rugby
    Warwickshire
    British36128300002
    GRAHAM, David Stuart
    The Bungalow Bond Lane
    Heage
    DE56 2AH Belper
    Derbyshire
    Administrateur
    The Bungalow Bond Lane
    Heage
    DE56 2AH Belper
    Derbyshire
    British32018670001
    HAMMOND, Peter William
    7 Spinney Close
    Groby
    LE6 0BY Leicester
    Administrateur
    7 Spinney Close
    Groby
    LE6 0BY Leicester
    British7459650002
    HOLMES, Peter Stephen
    51 Dunton Road
    Broughton Astley
    LE9 6NA Leicester
    Administrateur
    51 Dunton Road
    Broughton Astley
    LE9 6NA Leicester
    British7674010002
    HOLOHAN, Paul Michael
    The New House, Church Farm
    Houghton-On-The-Hill
    LE7 9HE Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    The New House, Church Farm
    Houghton-On-The-Hill
    LE7 9HE Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish69485900001
    LAKIN, James Michael Wilson
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Administrateur
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    EnglandEnglish29975670003
    LINDOP, Roger
    Portland Crescent
    HG1 2QS Harrogate
    18
    North Yorkshire
    Administrateur
    Portland Crescent
    HG1 2QS Harrogate
    18
    North Yorkshire
    EnglandBritish142362320001
    MOSS, Kevin
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Administrateur
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Gb-EngBritish147463820001
    RICHARDSON, April Jacqueline
    1 Glebelands Road
    LE4 2WB Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    1 Glebelands Road
    LE4 2WB Leicester
    Leicestershire
    British53165470003
    SHARPLESS, Frederick Bruce Cave
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish7436790001
    WHITE, Kevin John
    12 Grove Gardens
    Woodland Grange
    B61 0UG Bromsgrove
    Worcestershire
    Administrateur
    12 Grove Gardens
    Woodland Grange
    B61 0UG Bromsgrove
    Worcestershire
    British29975660002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Print People Group Limited
    Tolwell Road
    LE4 1BR Leicester
    16-21 Tolwell Road
    England
    06 avr. 2016
    Tolwell Road
    LE4 1BR Leicester
    16-21 Tolwell Road
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement03655511
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 08 mars 2017
    Livré le 20 mars 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited (The “Security Trustee”)
    Transactions
    • 20 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 mai 2014
    Livré le 31 mai 2014
    Totalement satisfaite
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC as Security Trustee for Each Group Member
    Transactions
    • 31 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 19 avr. 2011
    Livré le 20 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 22 déc. 2010
    Livré le 30 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 30 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal assignment
    Créé le 12 oct. 2010
    Livré le 13 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal assignment
    Créé le 18 mars 2010
    Livré le 23 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 23 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 10 mars 2010
    Livré le 13 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited ("the Security Holder")
    Transactions
    • 13 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge (all assets)
    Créé le 10 mars 2010
    Livré le 13 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited ("the Security Holder")
    Transactions
    • 13 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 28 janv. 2010
    Livré le 30 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Heidelberg speedmaster 102 twelve colour press s/no 543874.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Equipment Finance(UK) LTD
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD
    Transactions
    • 30 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 22 déc. 2005
    Livré le 23 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h usm house warren park enderby leicester t/n LT341693,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 05 mai 2005
    Livré le 11 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the west side of tyrrell street and north west side of nugent street, leicester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 26 sept. 2001
    Livré le 27 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Heidelberg speedmaster 102FP 5 + 0 or 2 + 3 s/no: 533780.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 27 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 26 juil. 1999
    Livré le 06 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Brèves mentions
    £80000 deposit.
    Personnes ayant droit
    • Lenton Lane Estates (Leicester) Limited
    Transactions
    • 06 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 22 juil. 1999
    Livré le 28 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 'heidelberg' 102VP 72CM x 102CM four-colour/perfector offset lithographic printing machine no. 534295 with full pile suction feeder, (see continuation sheet to 395 for full details).. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 28 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 23 déc. 1993
    Livré le 31 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book and other debts subject to the factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Factors Limited
    Transactions
    • 31 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge
    Créé le 09 nov. 1992
    Livré le 12 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 23/10/68
    Brèves mentions
    First fixed charge on all goodwill uncalled capital all patents/applications inventions trade marks/names registered designs copyrights & all licences.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 11 avr. 1990
    Livré le 18 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & premises on the west side of tyrrell street leicester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 18 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 mars 1990
    Livré le 05 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land hereditaments and premises being:- junction of tyrrell street and nugent street leicester title no:- LT137934.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 mars 1990
    Livré le 15 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & buildings to the north west of nugent road leicester title no LT79166.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 1987
    Livré le 03 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H lands & premises being factory at, nugent street leicester or the proceeds of sale thereof title no LT171745.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 15 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 07 nov. 1985
    Livré le 08 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge a muller martini model 1509 minitman saddlesticker serial no 9906389 floating charge all contracts and all guarantees indemnities and other documents please see doc M92.
    Personnes ayant droit
    • British Credit Trust Limited
    Transactions
    • 08 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 15 janv. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 1985
    Livré le 21 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Factory & premises north west side nugent street leicester or the proceeds of the sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 21 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 15 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral mortgage
    Créé le 09 mars 1983
    Livré le 12 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from barkby thorpe press limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & premises to the north west side of nugent street leicester together with buildings & fixtures & space heating equipment title no lt 79166.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 12 mars 1983Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 01 juil. 1982
    Livré le 06 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts & other debts due, owing or incurred to the company present & future.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    • 21 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 01 déc. 1980
    Livré le 05 déc. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & premises to the north west side of nugent rd, leicester, tog with all buildings & fixtures & space heating equipment thereon title no lt 79166.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 05 déc. 1980Enregistrement d'une charge

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 févr. 2020Administration started
    26 oct. 2021Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Anthony Lowe
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    practitioner
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Ben Woolrych
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    practitioner
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Anthony Collier
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    practitioner
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0