GREENHOUS FLEET LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGREENHOUS FLEET LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00356027
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GREENHOUS FLEET LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe GREENHOUS FLEET LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Greenhous Village
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Shropshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GREENHOUS FLEET LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SMART FLEET SOLUTIONS LIMITED20 mai 201120 mai 2011
    GREENHOUS STOKE LIMITED12 févr. 200312 févr. 2003
    VINCENT GREENHOUS (WREXHAM) LIMITED16 août 193916 août 1939

    Quels sont les derniers comptes de GREENHOUS FLEET LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour GREENHOUS FLEET LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 14 juil. 2021

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Theodorus Jan Kortland en tant que directeur le 18 juin 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kerry Paul Finnon en tant que directeur le 10 mai 2021

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 janv. 2021

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Craig Michael Finnon en tant que directeur le 03 juin 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Edward Brown en tant que directeur le 03 juin 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Vincent House Sitka Drive Shrewsbury Business Park Shrewsbury SY2 6LG à Greenhous Village Osbaston Telford Shropshire TF6 6RA le 21 avr. 2017

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Philip Deegan en tant que directeur le 09 juin 2016

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de GREENHOUS FLEET LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PAWSON, Michael Andrew
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    Secrétaire
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    BritishChartered Accountant141444710001
    PASSANT, Derek Robert
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    United KingdomBritishDirector12940900002
    PAWSON, Michael Andrew
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant141444710001
    HASLEWOOD, Andrew John
    Little Ness Farm
    Little Ness
    SY4 2LG Shrewsbury
    Shropshire
    Secrétaire
    Little Ness Farm
    Little Ness
    SY4 2LG Shrewsbury
    Shropshire
    BritishDirector9854330006
    HASLEWOOD, Andrew John
    Little Ness Farm
    Little Ness
    SY4 2LG Shrewsbury
    Shropshire
    Secrétaire
    Little Ness Farm
    Little Ness
    SY4 2LG Shrewsbury
    Shropshire
    BritishDirector9854330006
    PADDOCK, Terence Richard
    The Wood
    All Stretton
    SY6 6JN Church Stretton
    Salop
    Secrétaire
    The Wood
    All Stretton
    SY6 6JN Church Stretton
    Salop
    BritishCompany Director32503370002
    BARRY, Christopher
    Farcross London Road
    Ireland Cross Woore
    CW3 8RQ Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    Farcross London Road
    Ireland Cross Woore
    CW3 8RQ Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector102366840001
    BAYFIELD, Stephen Charles
    Collina House, Holsworth Park
    Oxon Business Park
    SY3 5HJ Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Collina House, Holsworth Park
    Oxon Business Park
    SY3 5HJ Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector102856570001
    BOLTON, Christopher
    44 Sneyd Avenue
    Westlands
    ST5 2PR Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    44 Sneyd Avenue
    Westlands
    ST5 2PR Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishDirector87484950001
    BROWN, David Edward
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    EnglandBritishDirector182745370001
    COBLEY, Geoffrey Martin
    Cruckfield House
    Ford
    SY5 9NR Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Cruckfield House
    Ford
    SY5 9NR Shrewsbury
    Shropshire
    BritishCompany Director9910680001
    DEEGAN, Philip
    Sitka Drive
    Shrewsbury Business Park
    SY2 6LG Shrewsbury
    Vincent House
    United Kingdom
    Administrateur
    Sitka Drive
    Shrewsbury Business Park
    SY2 6LG Shrewsbury
    Vincent House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector79991840002
    FINNON, Craig Michael
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    United KingdomBritishDirector182745730001
    FINNON, Kerry Paul
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    EnglandBritishDirector142171310001
    GREENHOUS, Patrick Ernest John
    Brook House
    Little Stretton
    SY6 6PP Church Stretton
    Salop
    Administrateur
    Brook House
    Little Stretton
    SY6 6PP Church Stretton
    Salop
    BritishChairman9854340001
    HASLEWOOD, Andrew John
    Little Ness Farm
    Little Ness
    SY4 2LG Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Little Ness Farm
    Little Ness
    SY4 2LG Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director9854330006
    KORTLAND, Theodorus Jan
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    Shropshire
    England
    EnglandDutchDirector89511740011
    MURFIN, Dudley John
    Mulberry House Swan Hill
    SY1 1NQ Shrewsbury
    Administrateur
    Mulberry House Swan Hill
    SY1 1NQ Shrewsbury
    BritishDirector9854350002
    PADDOCK, Terence Richard
    The Wood
    All Stretton
    SY6 6JN Church Stretton
    Salop
    Administrateur
    The Wood
    All Stretton
    SY6 6JN Church Stretton
    Salop
    BritishCompany Director32503370002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GREENHOUS FLEET LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Greenhous Group Limited
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    England
    06 avr. 2016
    Osbaston
    TF6 6RA Telford
    Greenhous Village
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Cardiff
    Numéro d'enregistrement03493415
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    GREENHOUS FLEET LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 21 févr. 2005
    Livré le 23 févr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property cobridge road etruria stoke on trent t/n SF353034 & SF479687 f/h & l/h properties clough street stoke on trent t/ns SF336585 SF409625 SF132423 SF452551 & SF132414 f/h property blackfriars road newcastle under lyme t/n SF248821 * please refer to form 395 for further details of property charged *. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 23 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 21 déc. 2004
    Livré le 05 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors or any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    1) f/h property k/a cobridge road, etruria, stoke on trent, 2) l/h property k/a clough street, stoke on trent, 3) f/h property k/a blackfriars road, newcastle under lyme, see form 395 for other properties charged;. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC (Gmac)
    Transactions
    • 05 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2004
    Livré le 29 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 28 sept. 1982
    Livré le 04 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    Collateral floating charge
    Créé le 01 sept. 1982
    Livré le 07 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from vincent greenhous (shrewsbury) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital, stock-in-trade, work-in-progress, prepayments, stock exchange investments & cash with all buildings, fixtures (including stock fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 07 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    • 11 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0