SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED

SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00359523
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    St. Anns Manor 6-8
    St. Ann Street
    SP1 2DN Salisbury
    Wiltshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    13 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 nov. 2021

    12 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 23 nov. 2020

    LRESEX

    Déclaration des affaires

    10 pagesLIQ02

    Changement d'adresse du siège social de Hills Farmhouse Bishopstoke Lane Brambridge Eastleigh SO50 6HX England à St. Anns Manor 6-8 st. Ann Street Salisbury Wiltshire SP1 2DN le 02 déc. 2020

    2 pagesAD01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2019

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 24 nov. 2018 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de Sarah Jane Winstone en tant que directeur le 26 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Emma Claire Baker en tant que directeur le 26 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Owen Winstone en tant que directeur le 26 oct. 2018

    1 pagesTM01

    État du capital au 25 avr. 2018

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 24 nov. 2017 sans mise à jour

    4 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    14 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    État du capital au 11 déc. 2017

    • Capital: GBP 390,470
    10 pagesSH19

    État du capital au 11 déc. 2017

    • Capital: GBP 390,468
    10 pagesSH19

    Changement d'adresse du siège social de Athenia House, 10 - 14 Andover Road Winchester SO23 7BS England à Hills Farmhouse Bishopstoke Lane Brambridge Eastleigh SO50 6HX le 29 nov. 2017

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Somac House, Brickfield Lane Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 4YS à Athenia House, 10 - 14 Andover Road Winchester SO23 7BS le 29 nov. 2017

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WINSTONE, Martin Owen
    St. Ann Street
    SP1 2DN Salisbury
    St. Anns Manor 6-8
    Wiltshire
    Secrétaire
    St. Ann Street
    SP1 2DN Salisbury
    St. Anns Manor 6-8
    Wiltshire
    British1540800001
    WINSTONE, Martin Owen
    St. Ann Street
    SP1 2DN Salisbury
    St. Anns Manor 6-8
    Wiltshire
    Administrateur
    St. Ann Street
    SP1 2DN Salisbury
    St. Anns Manor 6-8
    Wiltshire
    United KingdomBritish1540800001
    BAKER, Emma Claire
    Bishopstoke Lane
    Brambridge
    SO50 6HX Eastleigh
    Hills Farmhouse
    England
    Administrateur
    Bishopstoke Lane
    Brambridge
    SO50 6HX Eastleigh
    Hills Farmhouse
    England
    United KingdomBritish136050460002
    DUNN, Lara Elaina
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish101360850002
    WINSTONE, John Ernest
    Fair Ways Hadrian Way
    Chilworth
    SO16 7HX Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Fair Ways Hadrian Way
    Chilworth
    SO16 7HX Southampton
    Hampshire
    British1540810001
    WINSTONE, Paul Stephen
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish1540820001
    WINSTONE, Sarah Jane
    Bishopstoke Lane
    Brambridge
    SO50 6HX Eastleigh
    Hills Farmhouse
    England
    Administrateur
    Bishopstoke Lane
    Brambridge
    SO50 6HX Eastleigh
    Hills Farmhouse
    England
    EnglandBritish101361630001
    WINSTONE, Sean Sebastian
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish101360960003
    WINSTONE, Timothy Owen
    Bishopstoke Lane
    Brambridge
    SO50 6HX Eastleigh
    Hills Farmhouse
    England
    Administrateur
    Bishopstoke Lane
    Brambridge
    SO50 6HX Eastleigh
    Hills Farmhouse
    England
    United KingdomBritish101361760002
    WINSTONE, Victoria Joan
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish101360790001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Andover Road
    SO23 7BS Winchester
    Athenia House, 10 - 14
    England
    24 nov. 2017
    Andover Road
    SO23 7BS Winchester
    Athenia House, 10 - 14
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement10987884
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mr Martin Owen Winstone
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    06 avr. 2016
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mr Paul Stephen Winstone
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    06 avr. 2016
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mrs Victoria Joan Winstone
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    06 avr. 2016
    Somac House, Brickfield Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4YS Eastleigh
    Hampshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 22 sept. 2006
    Livré le 11 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The anchor business centre school chandlers ford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 28 nov. 2000
    Livré le 08 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a fyffes building warrior close chandlers ford industrial estate eastleigh hampshire t/h HP350994. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 23 févr. 1998
    Livré le 26 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a plot 1 (O.K.industries) eagle close chandlers ford industrial estate chandlers ford hampshire.t/no.HP125452.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 15 janv. 1990
    Livré le 26 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 1-8 warrior park chandlers ford ind est, eastleigh hampshire, and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 15 janv. 1990
    Livré le 26 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Industrial unit k/a britvic soft drinks limited eagle close chandlers ford ind est eastleigh, hampshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 15 janv. 1990
    Livré le 26 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units c-n eagle close chandlers ford ind est east leigh, hampshire and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Memorandum of deposit
    Créé le 02 févr. 1989
    Livré le 08 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Deeds & documents relating to f/h property, k/a farling house brickfield lane, chandlers ford, hampshire and the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Memorandum of deposit
    Créé le 02 févr. 1989
    Livré le 08 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Deeds & documents relating to f/h land at chandlers ford industrial estate eastleigh, hants and the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Memorandum of deposit
    Créé le 02 févr. 1989
    Livré le 08 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land certificate title no hp 127744 relating to stanford meadows bishopstoke eastleigh hampshire and the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 08 juil. 1987
    Livré le 15 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 24/24A, st. Cross road, winchester, hampshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 08 juil. 1987
    Livré le 15 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a dolphin field, hursley hampshire and glebe field, hursley hampshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 28 nov. 1985
    Livré le 05 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at edgar road winchester hampshire and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    Memorandum of deposit
    Créé le 14 août 1984
    Livré le 30 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Deeds & documents relating to f/h property known as land fronting sutherlands way chandlers ford, eastleigh hampshire including a transfer dated 14/8/84 and made between hampshire county council (1) and southampton builders limited (2) and the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 1984Enregistrement d'une charge
    Sub-mortgage
    Créé le 02 sept. 1982
    Livré le 21 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property, known as home farm, leigh road east leigh, hampshire. Title no. Hp 211049.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    Memorandum of deposit
    Créé le 10 sept. 1980
    Livré le 19 sept. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Title deeds of heron's field compton, hampshire.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 1980Enregistrement d'une charge
    Memorandum of deposit
    Créé le 25 sept. 1979
    Livré le 02 oct. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north side of castle lane, chandlers ford and north baddesley, hampshire. Title no. Hp 125452.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 1979Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Memorandum of deposit
    Créé le 10 nov. 1976
    Livré le 26 nov. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the chandlers ford industrial estate, hants.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1976Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Memorandum of deposit
    Créé le 24 mars 1976
    Livré le 29 mars 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land in quarn road, binstead ryde, isle of wight.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 1976Enregistrement d'une charge
    • 10 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of deposit
    Créé le 24 mars 1976
    Livré le 29 mars 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property "macquarrie" quarn road, binstead, isle of wight.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 1976Enregistrement d'une charge
    • 10 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 nov. 2020Commencement of winding up
    24 nov. 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    James William Stares
    St Anns Manor 6-8 St Ann Street
    SP1 2DN Salisbury
    Wiltshire
    practitioner
    St Anns Manor 6-8 St Ann Street
    SP1 2DN Salisbury
    Wiltshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0