TRENT INSURANCE COMPANY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TRENT INSURANCE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00361687 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TRENT INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| Adresse du siège social | 2 Minster Court Mincing Lane EC3R 7BB London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TRENT INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2027 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TRENT INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 févr. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 19 févr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 févr. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour TRENT INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 déc. 2025 | 44 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr John Perkins en tant qu'administrateur le 12 nov. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de David Philip Roberts en tant que directeur le 16 oct. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 44 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de David Stanley Rooney en tant que directeur le 31 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Stephen Leslie Mccann en tant que directeur le 31 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 44 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Susan Janet Helson en tant qu'administrateur le 22 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Colin Malcolm Grint en tant qu'administrateur le 03 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Timothy Joseph Carroll en tant qu'administrateur le 12 févr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Christopher David Forbes en tant qu'administrateur le 01 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de John Maxwell Percy Taylor en tant que directeur le 29 févr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des détails de The Dominion Insurance Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 3 pages | PSC05 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Catherine Anne Watts le 10 nov. 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Changement d'adresse du siège social de The Minster Building 21 Mincing Lane London EC3R 7AG England à 2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7BB le 24 oct. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 43 pages | AA | ||
Nomination de Mr David Philip Roberts en tant qu'administrateur le 03 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mrs Catherine Anne Watts en tant qu'administrateur le 02 févr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Mariana Daoud O'connell en tant que secrétaire le 22 févr. 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Colin Malcolm Grint en tant que directeur le 07 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Robert David Andrews en tant que directeur le 30 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de TRENT INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAOUD O'CONNELL, Mariana | Secrétaire | Mincing Lane EC3R 7BB London 2 Minster Court United Kingdom | 305951810001 | |||||||
| CARROLL, Timothy Joseph | Administrateur | Mincing Lane EC3R 7BB London 2 Minster Court United Kingdom | England | Irish | 221512670001 | |||||
| FORBES, Christopher David | Administrateur | Mincing Lane EC3R 7BB London 2 Minster Court United Kingdom | England | British | 26139730003 | |||||
| GRINT, Colin Malcolm | Administrateur | Mincing Lane EC3R 7BB London 2 Minster Court United Kingdom | England | British | 321508950001 | |||||
| HELSON, Susan Janet | Administrateur | Mincing Lane EC3R 7BB London 2 Minster Court United Kingdom | England | British | 52748760002 | |||||
| PERKINS, John | Administrateur | Mincing Lane EC3R 7BB London 2 Minster Court United Kingdom | England | British | 342876760001 | |||||
| WATTS, Catherine Anne | Administrateur | Mincing Lane EC3R 7BB London 2 Minster Court United Kingdom | England | British | 287954150002 | |||||
| ATKINSON, Joanne Claire | Secrétaire | 23 Eastways Bishops Waltham SO32 1EX Southampton Hampshire | British | 88944200003 | ||||||
| CHANDLER, Michael John | Secrétaire | 9 Chestnut Rise Droxford SO32 3NY Southampton Hampshire | British | 12203710001 | ||||||
| DLABOHA, Larysa Alla | Secrétaire | 21 Mincing Lane EC3R 7AG London The Minster Building England | 284742500001 | |||||||
| LAMPSHIRE, Philip John | Secrétaire | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre Hampshire | British | 145998830001 | ||||||
| OWER, Richard James | Secrétaire | Knoll Rise BR6 0NX Orpington 2 Kent | British | 151683080001 | ||||||
| PORTER, Margaret Ann | Secrétaire | The Zurich Centre 3000 Parkway, Whiteley PO15 7JZ Fareham Hampshire | British | 63664390003 | ||||||
| STEVENS, Lindsey Anne | Secrétaire | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre Hampshire | British | 138509020001 | ||||||
| WILTSHIRE, James Anthony | Secrétaire | Wellington House Stroud Road GL6 6UT Painswick Gloucestershire | British | 461140002 | ||||||
| WORTHINGTON, Paul Frank | Secrétaire | 7 Victoria Close SO31 9NT Locks Heath Hampshire | British | 99470290001 | ||||||
| ANDREWS, Robert David | Administrateur | 21 Mincing Lane EC3R 7AG London The Minster Building England | United Kingdom | British | 198207290001 | |||||
| BASKERVILLE, Adrian Hamilton | Administrateur | Warwick House Bridge Street PO17 5JJ Wickham Hampshire | British | 110839190001 | ||||||
| CHANDLER, Michael John | Administrateur | 9 Chestnut Rise Droxford SO32 3NY Southampton Hampshire | British | 12203710001 | ||||||
| CHESSHER, Mark Christopher | Administrateur | 16 Denmark Villas BN3 3TE Hove East Sussex | British | 81345500002 | ||||||
| CLARK, Anthony Lewis Russell | Administrateur | The Water Gardens Birchley Road, Battledown GL52 6NY Cheltenham Gloucestershire | British | 71693630001 | ||||||
| COOKE, Judith Alison | Administrateur | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre Hampshire | British/Canadian | 131513260001 | ||||||
| COOPER, Peter James | Administrateur | The Zurich Centre 3000 Parkway, Whiteley PO15 7JZ Fareham Hampshire | British | 7369200010 | ||||||
| CULMER, Mark George | Administrateur | SO21 | England | British | 98008120001 | |||||
| DIFFEY, Stuart, Mr. | Administrateur | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre Hampshire | United Kingdom | British | 145998150001 | |||||
| DOWLING, John Patrick | Administrateur | The Spinney Kiln Lane Binfield Heath Henley On Thames RG9 4EH Reading Oxfordshire | British | 101547250001 | ||||||
| GILBERT, Malcolm Derek Edward | Administrateur | Herzogstrasse 22 FOREIGN Zurich 8044 Switzerland | British | 111221360001 | ||||||
| GRINT, Colin Malcolm | Administrateur | c/o Premia Uk Ltd Mincing Lane EC3R 7AG London The Minster Bulding England | England | British | 176392570002 | |||||
| HITCHINGS, Paul Barrington Knowles | Administrateur | Green End Old Green Lane GU15 4LG Camberley Surrey | British | 9453370001 | ||||||
| HOLMES, Colm Joseph | Administrateur | The Zurich Centre 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham Hampshire | Ireland | Irish | 125115060001 | |||||
| HOWETT, Bryan James | Administrateur | Keffolds Farm Bunch Lane GU27 1AJ Haslemere Surrey | Irish | 38970640002 | ||||||
| JAMES, Penelope Jane | Administrateur | Knoll House Northend Broughton SO20 8AN Stockbridge Hampshire | British | 96276790002 | ||||||
| JANES, Simon | Administrateur | Knoll Rise BR6 0NX Orpington 2 Kent | United Kingdom | British | 40790290002 | |||||
| MCCANN, Stephen Leslie | Administrateur | Mincing Lane EC3R 7BB London 2 Minster Court United Kingdom | England | British | 236019420001 | |||||
| NICHOLAS, John Stuart | Administrateur | Twistells Wood Road GU26 6PX Hindhead Surrey | British | 62665770001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRENT INSURANCE COMPANY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Dominion Insurance Company Limited | 06 avr. 2016 | Collins House Rutland Square EH1 2AA Edinburgh Dla Piper (Scotland) Llp Midlothian Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0