INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD

INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00366295
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD ?

    • Édition de journaux (58130) / Information et communication

    Où se situe INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD ?

    Adresse du siège social
    39 Welbeck Street
    W1G 8DR London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INDEPENDENT NEWSPAPERS (UK) LIMITED29 avr. 199429 avr. 1994
    GREATER LONDON & ESSEX NEWSPAPERS LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    ESSEX AND EAST LONDON NEWSPAPERS LIMITED03 avr. 194103 avr. 1941

    Quels sont les derniers comptes de INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    5 pagesMR04

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de 11 Welbeck Street London W1G 9XZ à 39 Welbeck Street London W1G 8DR le 10 août 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juil. 2015

    État du capital au 20 juil. 2015

    • Capital: GBP 7,226,546
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 déc. 2014

    1 pagesAA

    Cessation de la nomination de Eamonn O'kennedy en tant que directeur le 31 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 juil. 2014

    État du capital au 18 juil. 2014

    • Capital: GBP 7,226,546
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    1 pagesAA

    Cessation de la nomination de Vincent Crowley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 19 juil. 2013

    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    10 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * C/O 2Nd Floor 5 Jubilee Place London London SW3 3TD England* le 27 juil. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    10 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 2 Derry Street London W8 5HF* le 17 oct. 2011

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Eamonn O'kennedy en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Round en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    10 pagesAA

    Nomination de Mr Richard J Mcclean en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SNODDY, Simon
    Welbeck Street
    W1G 8DR London
    39
    England
    Secrétaire
    Welbeck Street
    W1G 8DR London
    39
    England
    159509000001
    MCCLEAN, Richard J
    Welbeck Street
    W1G 8DR London
    39
    England
    Administrateur
    Welbeck Street
    W1G 8DR London
    39
    England
    Northern IrelandBritish160639340001
    BRACKEN, Derek Andrew
    66 Solent Road
    West Hampstead
    NW6 1TX London
    Secrétaire
    66 Solent Road
    West Hampstead
    NW6 1TX London
    British79961570002
    BURGESS, Laurence Edward
    April Cottage
    Collett Road
    HP1 1HY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    April Cottage
    Collett Road
    HP1 1HY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British33551470002
    MCCREERY, Stuart Alexander
    5 Hills View
    Great Shelford
    CB2 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    5 Hills View
    Great Shelford
    CB2 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    British31612490004
    TIMMS, Roger Edward
    4 Monkhams Lane
    IG8 0NL Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    4 Monkhams Lane
    IG8 0NL Woodford Green
    Essex
    British1628510001
    BROWNING, Alec John
    78 Tycehurst Hill
    IG10 1DA Loughton
    Essex
    Administrateur
    78 Tycehurst Hill
    IG10 1DA Loughton
    Essex
    British1628520001
    BURGESS, Laurence Edward
    April Cottage
    Collett Road
    HP1 1HY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    April Cottage
    Collett Road
    HP1 1HY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British33551470002
    CROWLEY, Vincent Conor
    2023 Bianconi Avenue
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    Independent House
    Dublin
    Germany
    Administrateur
    2023 Bianconi Avenue
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    Independent House
    Dublin
    Germany
    IrelandIrish145612030001
    EVANS, Philip Neil
    3 Poseidon Court
    E14 3UG London
    Administrateur
    3 Poseidon Court
    E14 3UG London
    British27685760001
    FALLON, Ivan Gregory
    17 Kensington Mansions
    Trebovir Road
    SW5 9TF London
    Administrateur
    17 Kensington Mansions
    Trebovir Road
    SW5 9TF London
    UkIrish68609380003
    GROTE, Terence Michael
    The Old White House 27 High Street
    Melbourn
    SG8 6EB Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Old White House 27 High Street
    Melbourn
    SG8 6EB Royston
    Hertfordshire
    British18054520001
    GWINN, Paul
    8 Roy Gardens
    IG2 7QQ Ilford
    Essex
    Administrateur
    8 Roy Gardens
    IG2 7QQ Ilford
    Essex
    British13357390001
    HEALY, Liam Padraig
    Wood Lawn
    Golf Links Road
    IRISH Foxrock
    Co Dublin Eire
    Administrateur
    Wood Lawn
    Golf Links Road
    IRISH Foxrock
    Co Dublin Eire
    IrelandIrish1695450001
    HOPKINS, Brendan Michael Anthony
    43 Norland Square
    W11 4PZ London
    Administrateur
    43 Norland Square
    W11 4PZ London
    United KingdomBritish54628620001
    MCCREERY, Stuart Alexander
    5 Hills View
    Great Shelford
    CB2 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    5 Hills View
    Great Shelford
    CB2 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    British31612490004
    O'KENNEDY, Eamonn
    Welbeck Street
    W1G 9XZ London
    11
    England
    Administrateur
    Welbeck Street
    W1G 9XZ London
    11
    England
    IrelandIrish253646050001
    PARKINSON, James Joseph
    Tor
    Church Road
    IRISH Killiney
    Co Dublin
    Eire
    Administrateur
    Tor
    Church Road
    IRISH Killiney
    Co Dublin
    Eire
    IrelandIrish7264750001
    PROCTER, Lawrie
    11 Rectory Green
    BR3 4HX Beckenham
    Kent
    Administrateur
    11 Rectory Green
    BR3 4HX Beckenham
    Kent
    British69116920001
    ROUND, Andrew John
    Oak House
    No 77 High Street
    CB4 8DR Landbeach
    Administrateur
    Oak House
    No 77 High Street
    CB4 8DR Landbeach
    EnglandBritish34289090002
    TIMMS, Roger Edward
    41 Monkhams Lane
    IG8 0NN Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    41 Monkhams Lane
    IG8 0NN Woodford Green
    Essex
    British13668330001
    TINDLE, Raymond Stanley, Sir
    Devonshire House 92 West Street
    GU9 7EN Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Devonshire House 92 West Street
    GU9 7EN Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish57658900004

    INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 11 nov. 2009
    Livré le 19 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 août 2003
    Livré le 03 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any obligor to the secured parties or to the security agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge the company's right, title and interest to the real property and the trade marks floating charge the whole of the company's undertaking and assets present or future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Security Agent
    Transactions
    • 03 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 08 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge created by way of debenture
    Créé le 23 juin 2003
    Livré le 02 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as security agent on behalf of the beneficiaries (as defined) or under or pursuant to the relevant documents (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The whole of the company's undertaking and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 02 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 10 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge created by way of debenture dated 9 july 2001 between independent news & media (UK) limited, independent news & media (northern ireland) limited, independent newspapers (publishing) limited, independent newspapers (UK) limited, independent finance PLC, independent newspapers (regionals) limited, tih (belfast) and the security agent (as defined)
    Créé le 09 juil. 2001
    Livré le 17 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries by the company or under or pursuant to the releant documents (as defined)
    Brèves mentions
    By way of first floating charge the whole of the company's undertaking and assets, present and future as security for payment and discharge of the secured obligations.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Security Agent on Behalf of the Beneficiearies (As Defined)
    Transactions
    • 17 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 05 oct. 1998
    Livré le 06 oct. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 5TH october 1998
    Brèves mentions
    £5,334.25 plus vat.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Geoffrey Michael Warren
    Transactions
    • 06 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 31 mars 1980
    Livré le 02 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    3 paradise row, london E2. Title no ngl 24039. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 avr. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0