UNION PUMP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéUNION PUMP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00366985
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de UNION PUMP LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe UNION PUMP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    . Green Road
    Penistone
    S36 6BJ Sheffield
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de UNION PUMP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DAVID BROWN UNION PUMPS LIMITED03 avr. 199803 avr. 1998
    DAVID BROWN PUMPS LIMITED28 mars 198928 mars 1989
    DAVID BROWN PUMPS & FABRICATIONS LIMITED22 juin 198822 juin 1988
    DAVID BROWN ESTATES LIMITED07 mai 194107 mai 1941

    Quels sont les derniers comptes de UNION PUMP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour UNION PUMP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mai 2016

    État du capital au 16 mai 2016

    • Capital: GBP 582,222
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jeremy Wade Smeltser le 26 sept. 2015

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Balkar Sohal en tant que directeur le 26 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Paul Andrew Cahill en tant qu'administrateur le 26 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 mai 2015

    État du capital au 27 mai 2015

    • Capital: GBP 582,222
    SH01

    Cessation de la nomination de Kevin Lucius Lilly en tant que directeur le 03 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Stephen Tsoris en tant qu'administrateur le 03 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Balkar Sohal le 22 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Edward Shanahan le 22 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juin 2014

    État du capital au 11 juin 2014

    • Capital: GBP 582,222
    SH01

    Cessation de la nomination de Christopher Brown en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Thomas Brown en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Lucius Lilly le 01 janv. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jeremy Wade Smeltser le 01 janv. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Balkar Sohal le 12 mai 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Edward Shanahan le 15 mai 2013

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Allan Dowie en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de UNION PUMP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAHILL, Paul Andrew
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant202085370001
    SHANAHAN, Mark Edward
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector165707440001
    SMELTSER, Jeremy Wade
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    Administrateur
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanCfo, Spx Flow, Inc.163313000001
    TSORIS, Stephen
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    Administrateur
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanDirector197069810001
    ASHMAN, Linda Margaret
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    British86730910001
    BROWN, Thomas James
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    Secrétaire
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    BritishCompany Secretary60773560001
    COWAN, Jonathan Brandon
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    British29591090001
    TULLEY, Karen Ann
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor59112980002
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director1876370002
    ANDREWS, Alan
    27 Hill Top Road
    Salendine Nook
    HD3 3SW Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    27 Hill Top Road
    Salendine Nook
    HD3 3SW Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishAftermarket Director52101720001
    BAILEY, Derek
    26 Pennine Rise
    Scissett
    HD8 9JE Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    26 Pennine Rise
    Scissett
    HD8 9JE Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishEngineering And Technical Serv29591110001
    BLACKWELL, Malcolm
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    Administrateur
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    United KingdomBritishManaging Director40752710001
    BRADWELL, Garth Jeffrey
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    BritishFinance Director66587570001
    BROWN, Christopher John
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Managing Director1698880001
    COOK, Christopher David
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    Administrateur
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Managing Director1698890001
    COWAN, Jonathan Brandon
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    BritishFinance Director29591090001
    DOWIE, Allan Cameron
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    Administrateur
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    United KingdomBritishFinance Director132053460001
    ELSBORG, Anton Cecil
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Finance Director93041580001
    GARNER, Philip Frank
    83 Barrow Road
    Quorn
    LE12 8DH Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    83 Barrow Road
    Quorn
    LE12 8DH Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Director48137730001
    HOBBS, David John
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishFinance Dir48318550001
    HOLLAND, Mark Harry
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    Administrateur
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant98168130001
    LILLY, Kevin Lucius
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    Administrateur
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    UsaAmericanDirector165775730001
    LODGE, Christopher Martin
    21 Birchland Drive
    Killamarsh
    S31 8GL Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    21 Birchland Drive
    Killamarsh
    S31 8GL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishOperations Director48087890001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    Administrateur
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    United StatesAmericanBusiness Director61807850002
    PENNING, Graham Michael
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishVice President Of Engineering12354670001
    ROWLEY, Stephen Nicholas
    Pond Farm House Midway
    South Crosland
    HD4 7DA Huddersfield
    Administrateur
    Pond Farm House Midway
    South Crosland
    HD4 7DA Huddersfield
    BritishCompany Director47869520001
    SCHREIBER, Gregory
    6157 Bethany Circle
    Richland
    Michigan 49083
    Usa
    Administrateur
    6157 Bethany Circle
    Richland
    Michigan 49083
    Usa
    AmericanPresident71227450001
    SOHAL, Balkar
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishChartered Accountant161546310001
    STRUDWICK, Tony
    17 Broomleaf Road
    GU9 8DG Farnham
    Surrey
    Administrateur
    17 Broomleaf Road
    GU9 8DG Farnham
    Surrey
    BritishSales Director38754410001

    UNION PUMP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 sept. 1992
    Livré le 07 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 ref m*92. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 24 janv. 1990
    Livré le 06 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due frok each obligor to the chargee as agent & trustee for itself, the charges & for each b ank on any account whatsoever, under the terms of the financing documents (all terms as defined in a credit agreement dated 24.1.90)
    Brèves mentions
    (For full details refer no doc 395 ref M98). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Company
    Transactions
    • 06 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 24 janv. 1990
    Livré le 05 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor as defined in the charge as agent & trustee for itself & for each lender (as defined in the charge) on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Please see doc m 44 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • First Britannia Mezzanine Capital Bv
    Transactions
    • 05 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 juin 1989
    Livré le 04 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 27 juin 1989
    Livré le 30 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including heritable property & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1989Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 20 déc. 1985
    Livré le 03 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See m 132). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 oct. 1985
    Livré le 28 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all f/h & l/h property all buildings, fixtures fixed plant & machinery all goodwill & un-called capital, all book & other debts. Floating charge over all undertaking and all property and assets present and future (see M131).
    Personnes ayant droit
    • First Wisconsin National Bank of Milwaukee
    Transactions
    • 28 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 11 oct. 1984
    Livré le 26 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H chequers mann estate, carmore end, high wycombe buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 26 sept. 1984
    Livré le 03 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/L cobstone mill, ibstone bucks. As comprised in a conveyance dated 15/7/82.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    Deposit of deeds without written instrument
    Créé le 27 août 1984
    Livré le 12 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Chequers manor estate cadmore end high wycombe buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1984Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0