DORSMAN ESTATES CO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDORSMAN ESTATES CO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00368352
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DORSMAN ESTATES CO LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe DORSMAN ESTATES CO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DORSMAN ESTATES CO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au03 avr. 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour DORSMAN ESTATES CO LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour DORSMAN ESTATES CO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    4 pagesCOCOMP

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:re removal of liq
    7 pagesLIQ MISC OC

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 18/07/2014
    33 pagesLIQ MISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    6 pages2.33B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 18 juil. 2013

    49 pages2.24B

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    4 pagesCOCOMP

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    Qui sont les dirigeants de DORSMAN ESTATES CO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLIS, Roy George
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    Secrétaire
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    British116788900001
    BURNS, Neil Anthony
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    Administrateur
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    WalesBritishIt Director62596180004
    ELLIS, Roy George
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Administrateur
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    WalesBritishDirector161784490001
    KIRK, Richard Stanley, Mr.
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    Administrateur
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director54276260003
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Secrétaire
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    British75927820002
    MORGAN, David John
    Flat 2 258 Hagley Road
    DY9 0RW Stourbridge
    Worcestershire
    Secrétaire
    Flat 2 258 Hagley Road
    DY9 0RW Stourbridge
    Worcestershire
    British35923980005
    SHEPPARD, Jonathan Lance
    Borrowdale Close
    Penylan
    CF23 5LQ Cardiff
    7
    Wales
    Secrétaire
    Borrowdale Close
    Penylan
    CF23 5LQ Cardiff
    7
    Wales
    Welsh98026690002
    WIGLEY, Islwyn Thomas
    21 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    Secrétaire
    21 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    British49912180001
    BRYANT, Keith Ralph
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    Administrateur
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    United KingdomBritishFinance Director54831150003
    BULLAS, Michael Stuart
    Lumb House Farm
    Greenside Road, Thurstonland
    HD4 6XA Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Lumb House Farm
    Greenside Road, Thurstonland
    HD4 6XA Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director86392570001
    CHILD, Hugh
    Village House
    Colwinston
    CF7 7NL Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Village House
    Colwinston
    CF7 7NL Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    BritishChartered Accountant16578300001
    GIPSON, Stephen
    Rose Cottage
    Piccadilly
    CF71 7JL Llanblethin
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Rose Cottage
    Piccadilly
    CF71 7JL Llanblethin
    Vale Of Glamorgan
    BritishRetail Director90147660001
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Administrateur
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    WalesBritishDirector75927820002
    PEACOCK, Robert Frank
    Allt Laes Farm
    Cnepyn Lane Peterston Super Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Administrateur
    Allt Laes Farm
    Cnepyn Lane Peterston Super Ely
    CF5 6NE Cardiff
    BritishCompany Director13070020001
    WOODHOUSE, Anthony John
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    Administrateur
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    United KingdomBritishCompany Director131678400001

    DORSMAN ESTATES CO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 janv. 2006
    Livré le 31 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the non-consent mortgaged property the additional property the tangible moveable property the accounts the intellectual property the charged intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares and all dividends. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. as Security Trustees for and on Behalf of the Securedparties
    Transactions
    • 31 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Debenture
    Créé le 22 juil. 2002
    Livré le 25 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge all its right, title and interest in and to the property k/a 17 & 18 taff street, pontypridd t/no. WA545538 and unit e, cae mawr industrial estate t/no. WA957651 and any buildings fixtures fittings fixed plant or machinery thereon and all related rights (the real property) and the intellectual property. First floating charge the whole of its undertaking and assets, present and future, other than any assets validly and effectively charged by way of fixed charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee
    Transactions
    • 25 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A debenture made by the company,the peacock group PLC,peacocks (nantgarw) limited and peacock's stores limited (together with the company,the "chargors")
    Créé le 12 sept. 2001
    Livré le 18 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from the chargor to the chargee,as trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined), including the debenture, and including any liability in respect of any further advances made under the secured documents
    Brèves mentions
    First fixed charge over all rights,title and interest from time to time in and to the real property known as (I) 17 and 18 taff street,pontypridd,rhondda cyon taff (wa 545538) and (ii) unit e,cae mawr industrial estate,treorchy,rhondda cyon taff (wa 957651) with all buildings,fixtures,fittings,fixed plant or machinery thereon; see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture between the company, the chargors (as defined) and the governor and company of the bank of scotland (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined)
    Créé le 02 déc. 1999
    Livré le 17 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders (As Defined)
    Transactions
    • 17 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Group debenture
    Créé le 03 avr. 1997
    Livré le 08 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the chargee in it's capacity as security trustee for the secured parties (as defined) and to the secured parties or any of them under any of the financing documents (as defined) and under the debenture in whatsoever manner
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 mars 1995
    Livré le 25 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from peacock's stores limited and from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H land at sanatorium road, cardiff. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 août 1994
    Livré le 20 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at sanatorium road, cardiff. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 sept. 1991
    Livré le 20 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or peacock's stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property fronting sanatorium road canton cardiff south glamorgan and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 sept. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 sept. 1991
    Livré le 20 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company and/or peacock's stores to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Buildings north side sanatorium road canton cardiff south glamorgan title no. WA133241 and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 sept. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 janv. 1980
    Livré le 31 janv. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or peacoks stores limited t o any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at sanatorium road canton cardiff S. glamorgan title no: WA133241.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 1980Enregistrement d'une charge

    DORSMAN ESTATES CO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 janv. 2012Administration started
    19 juil. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Christine Mary Laverty
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Edward George Boyle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jonathan Scott Pope
    Marlborough House Fitzalan Court
    Fitzalan Road
    CF24 0TE Cardiff
    practitioner
    Marlborough House Fitzalan Court
    Fitzalan Road
    CF24 0TE Cardiff
    2
    DateType
    25 nov. 2015Conclusion of winding up
    28 juin 2013Petition date
    19 juil. 2013Commencement of winding up
    03 mars 2016Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Reading
    3d Apex Plaza
    Forbury Road
    RG1 1AX Reading
    practitioner
    3d Apex Plaza
    Forbury Road
    RG1 1AX Reading
    Jonathan Scott Pope
    3 Britannia Quay
    CF10 4AX Cardiff
    South Glamorgan
    practitioner
    3 Britannia Quay
    CF10 4AX Cardiff
    South Glamorgan
    Edward George Boyle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Christine Mary Laverty
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0