ARGENT MEAT TRADERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéARGENT MEAT TRADERS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00368420
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ARGENT MEAT TRADERS LIMITED ?

    • Production de produits à base de viande et de viande de volaille (10130) / Industries manufacturières

    Où se situe ARGENT MEAT TRADERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Henley Building
    Newtown Road
    RG9 1HG Henley-On-Thames
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ARGENT MEAT TRADERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FAIRFAX MEADOW LIMITED31 déc. 199631 déc. 1996
    FAIRFAX MEADOW FARM LIMITED10 janv. 199210 janv. 1992
    PYKE BIGGS FAIRFAX LIMITED03 déc. 198703 déc. 1987
    PYKE BIGGS LIMITED01 janv. 198401 janv. 1984
    PYKE BIGGS (LONDON) LTD01 févr. 198201 févr. 1982
    PYKE BUTCHERS (LONDON) LIMITED31 déc. 197831 déc. 1978
    W.J.PYKE(BUTCHERS)LIMITED29 juil. 194129 juil. 1941

    Quels sont les derniers comptes de ARGENT MEAT TRADERS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ARGENT MEAT TRADERS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au08 juil. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation22 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au08 juil. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour ARGENT MEAT TRADERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023

    13 pagesAA
    AD73WAEJ

    legacy

    62 pagesPARENT_ACC
    AD73WADV

    legacy

    2 pagesGUARANTEE2
    AD73WAE3

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2
    AD73WAEB

    Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XD6XAHT0

    Inscription de la charge 003684200026, créée le 30 avr. 2024

    5 pagesMR01
    XD2O410Z

    Satisfaction de la charge 003684200025 en totalité

    1 pagesMR04
    XD06O80B

    Modification des détails de Argent Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mars 2024

    2 pagesPSC05
    XCYO2RZE

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022

    13 pagesAA
    ACD4TRXM

    legacy

    61 pagesPARENT_ACC
    ACD9VPWJ

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2
    ACD4TRY2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2
    ACD4TRXU

    Changement d'adresse du siège social de Suite G09 the Henley Building Newtown Road Henley on Thames Oxfordshire RG9 1HG United Kingdom à The Henley Building Newtown Road Henley-on-Thames RG9 1HG le 06 sept. 2023

    1 pagesAD01
    XCBICRWA

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XC748EPF

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David John Gray le 31 mai 2023

    2 pagesCH01
    XC4Q2UAJ

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Fallowfield-Smith le 31 mai 2023

    2 pagesCH01
    XC4Q2AMG

    Changement d'adresse du siège social de Level 5, 9 Hatton Street London England NW8 8PL à Suite G09 the Henley Building Newtown Road Henley on Thames Oxfordshire RG9 1HG le 04 oct. 2022

    1 pagesAD01
    XBDY2YAP

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2021

    14 pagesAA
    ABCIMES1

    legacy

    62 pagesPARENT_ACC
    ABCIMEUX

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2
    ABCIMEQ9

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2
    ABBO5Q5U

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XB7ML9TE

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2
    AA9O4RO4

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2020

    14 pagesAA
    AA9O4RNS

    legacy

    61 pagesPARENT_ACC
    AA9O4ROO

    Qui sont les dirigeants de ARGENT MEAT TRADERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FALLOWFIELD-SMITH, James
    Newtown Road
    RG9 1HG Henley On Thames
    The Henley Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Newtown Road
    RG9 1HG Henley On Thames
    The Henley Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishAccountant282616690001
    GRAY, David John
    Newtown Road
    RG9 1HG Henley On Thames
    The Henley Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Newtown Road
    RG9 1HG Henley On Thames
    The Henley Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director105745700001
    BARNES, Andrew John
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    BritishChartered Accountant79031400002
    MEHEW, Barry James
    16f Garlinge Road
    NW2 3TR London
    Secrétaire
    16f Garlinge Road
    NW2 3TR London
    British54902120001
    MONKS, Anthony James
    Yarrow Cottage Severn Road
    Hallen
    BS10 7RZ Bristol
    Avon
    Secrétaire
    Yarrow Cottage Severn Road
    Hallen
    BS10 7RZ Bristol
    Avon
    British1374420001
    MORGAN, Peter Frederick
    The Oaks
    Spring Lane
    MK44 1AT Yelden
    Bedfordshire
    Secrétaire
    The Oaks
    Spring Lane
    MK44 1AT Yelden
    Bedfordshire
    British1491120001
    RYBCZAK, Myron
    The Hollies
    3 Central Avenue
    DE72 3JZ Borrowash
    Derbyshire
    Secrétaire
    The Hollies
    3 Central Avenue
    DE72 3JZ Borrowash
    Derbyshire
    BritishFinance Director7518500001
    ANDERSON, Roy Martin
    82 Tyrone Road
    SS1 3HB Thorpe Bay
    Essex
    Administrateur
    82 Tyrone Road
    SS1 3HB Thorpe Bay
    Essex
    EnglandBritishSales Director90158870001
    BARNES, Andrew John
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    Administrateur
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    EnglandBritishChartered Accountant79031400002
    BUSWELL, Michel Norman
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    Administrateur
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    BritishCompany Director15685720001
    HARWOOD, John
    Orchard Cottage
    Buckland Common
    HP23 6MC Tring
    Herts
    Administrateur
    Orchard Cottage
    Buckland Common
    HP23 6MC Tring
    Herts
    BritishDirector20448330001
    HOLDING, David Andrew
    Broadlands 32 Keats Avenue
    Littleover
    DE23 7ED Derby
    Administrateur
    Broadlands 32 Keats Avenue
    Littleover
    DE23 7ED Derby
    United KingdomBritishCompany Director46464370001
    HUNTER, Andrew Pennington Havard
    Ashlea House
    Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ashlea House
    Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Executive54239750004
    JOHNSON, Andrew William
    Hillcrest 7 Highgate
    Park Road Cross Hills
    BD20 8BE Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Hillcrest 7 Highgate
    Park Road Cross Hills
    BD20 8BE Keighley
    West Yorkshire
    BritishSales Director66197820001
    MORRIS, Douglas Campbell
    Cedar House Pine Trees
    One Pin Lane
    SL2 3RB Farnham Common
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Cedar House Pine Trees
    One Pin Lane
    SL2 3RB Farnham Common
    Buckinghamshire
    BritishDirector4896850002
    MUSK, Michael John
    Great Batchelors
    Sissinghurst Road
    TN27 8EX Biddenden
    Kent
    Administrateur
    Great Batchelors
    Sissinghurst Road
    TN27 8EX Biddenden
    Kent
    United KingdomBritishDirector127656990001
    O'SULLIVAN, Kevin
    Fir Tree Oast Plough Wents Road
    ME17 3RX Chart Sutton
    Kent
    Administrateur
    Fir Tree Oast Plough Wents Road
    ME17 3RX Chart Sutton
    Kent
    BritishMarketing Director34177870003
    OLDCORN, John
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    Administrateur
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    United KingdomEnglishCompany Director247632320002
    PEARCE, Peter Edwin
    Priory End Alderton Drive
    HP4 1NA Ashridge
    Hertfordshire
    Administrateur
    Priory End Alderton Drive
    HP4 1NA Ashridge
    Hertfordshire
    BritishCompany Director44603500002
    RYBCZAK, Myron
    The Hollies
    3 Central Avenue
    DE72 3JZ Borrowash
    Derbyshire
    Administrateur
    The Hollies
    3 Central Avenue
    DE72 3JZ Borrowash
    Derbyshire
    BritishFinance Director7518500001
    SACKS, Philip
    47 Saint Thomas's Road
    PE11 2XT Spalding
    Lincolnshire
    Administrateur
    47 Saint Thomas's Road
    PE11 2XT Spalding
    Lincolnshire
    BritishCompany Director75421730001
    TAYLOR, Robert
    Cornerways 9 Vine Close
    Littleover
    DE23 7BX Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Cornerways 9 Vine Close
    Littleover
    DE23 7BX Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director63693620001
    WENSLEY, Gerald Francis
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    Administrateur
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    United KingdomBritishDirector22391250001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ARGENT MEAT TRADERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Argent Holdings Limited
    Hatton Street
    Level 5
    NW8 8PL London
    9
    England
    01 juin 2016
    Hatton Street
    Level 5
    NW8 8PL London
    9
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleComanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement03407545
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ARGENT MEAT TRADERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 30 avr. 2024
    Livré le 08 mai 2024
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 2024Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 sept. 2017
    Livré le 29 sept. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 29 sept. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 avr. 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 sept. 2014
    Livré le 02 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank Commercial Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 02 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 sept. 2014
    Livré le 02 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 02 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission
    Créé le 05 mars 2010
    Livré le 15 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 march 2007 and
    Créé le 20 févr. 2008
    Livré le 12 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of admission
    Créé le 09 nov. 2007
    Livré le 27 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the further company or by any one of the existing companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 27 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28TH march 2007 and
    Créé le 17 sept. 2007
    Livré le 25 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 28 mars 2007
    Livré le 05 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from or by any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 avr. 2006
    Livré le 26 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 2002
    Livré le 11 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 30 sept. 1997
    Livré le 06 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the finance documents (as therein defined)
    Brèves mentions
    Property k/a the fulcrum building horton road poyle t/no BK332933 land to the south west of london road derby (f/h part of 6 newmarkt drive osmaston park industrial estate) t/no DY252113 and site b kentish town industrial park 24-27 regis road t/no NGL574578 together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1986
    Livré le 13 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land on north west side of jackson road, canterbury. T/N. K413134.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1986Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1986
    Livré le 13 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H barkby thorpe indust. Est. 1, tuxted road, leics. LE4 7TZ.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1986Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1986
    Livré le 13 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 6 & 8 brookway, hambridge newbury, berks.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1986Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1986
    Livré le 13 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 11, the exchange, tyles marsell, leics.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1986Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 12 juil. 1985
    Livré le 19 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 nov. 1984
    Livré le 13 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 mai 1982
    Livré le 21 mai 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. Together with all buildings fixtuers (including trade fixtures) and fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 1982Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 déc. 1981
    Livré le 08 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 12 norbreck parade north circular road ealing, london NW10 title no. Mx 391772.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 déc. 1981
    Livré le 08 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 184 park avenue & land adjoining, north circular road ealing london NW10 7XL title no. Mx 277484.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 déc. 1981
    Livré le 07 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 31 mai 1972
    Livré le 07 juin 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    34 cock lane, west smithfield london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1972Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 31 mai 1972
    Livré le 07 juin 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    46 carlyon road, alperton wembley, middlesex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1972Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 31 mai 1972
    Livré le 07 juin 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    11 & 12 norbreck parade north circular road, NW10 ealing. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1972Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0