SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00368815 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?
Adresse du siège social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 8 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 nov. 2018 | 16 pages | LIQ03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Justin Bruce Robinson en tant que directeur le 14 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG à 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 22 déc. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Haysmacintyre Company Secretaries Limited le 18 déc. 2017 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Bruce Robinson le 18 déc. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Thomas Mabry le 18 déc. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom à 10 Queen Street Place London EC4R 1AG le 18 déc. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Michael Teasdale le 18 déc. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 003688150004 | 5 pages | MR05 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 05 oct. 2017
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Bruce Robinson le 03 févr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 14 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
MABRY, Patrick Thomas | Administrateur | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | Luxembourg | German | Company Director | 204005420001 | ||||||||
TEASDALE, Simon Michael | Administrateur | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | Director | 204008350001 | ||||||||
BOLTON, Susan | Secrétaire | 10 Haygreen Close KT2 7TS Kingston Upon Thames Surrey | British | 59426570001 | ||||||||||
COMBEER, Jean Brenda | Secrétaire | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
COMBEER, Jean Brenda | Secrétaire | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
CRANE, Julia Alison | Secrétaire | 27 Hatton Court Lubbock Road BR7 5JQ Chislehurst Kent | British | Company Secretary | 46318020001 | |||||||||
ENGMANN, Catherine | Secrétaire | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
LOYNES, Paul | Secrétaire | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203613510001 | |||||||||||
TOON, Samantha Anne | Secrétaire | 10 St.Anthonys Court Nightingale Lane SW12 8NS London | British | Company Secretarial Assistant | 32930670001 | |||||||||
WHITNEY, Paul Sumpter | Secrétaire | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
WILLIAMS, Alison | Secrétaire | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Secrétaire | Ten Bishops Square E1 6EG London Eighth Floor United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
BAKER, Skardon Francis | Administrateur | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | Investment Professional | 196342720001 | ||||||||
CASTON, Robert Warwick | Administrateur | Square De Heeus 20 FOREIGN 1400 Brussels Belgium | British | Managing Director | 1311840002 | |||||||||
EKAS, Petra Cecilia Maria | Administrateur | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | Asset Manager | 169731050002 | ||||||||
FISH, Andrew John | Administrateur | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | Accountant | 77133450001 | ||||||||
GRAHAM, Ian Christopher | Administrateur | Avenue Venus 2 1410 Waterloo Belgium | British | Regional Vice President-Finance | 31551670001 | |||||||||
JACKMAN, Robert Loehr | Administrateur | 4 Durning Place SL5 7EZ Ascot Berkshire | American | Vp Legal Counsel | 35835670003 | |||||||||
KOLEV, Ivaylo | Administrateur | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | Investment Professional | 193389430001 | ||||||||
LOYNES, Paul | Administrateur | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 241370450001 | ||||||||
MCCARTHY, John Patrick | Administrateur | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | Banker | 112396050001 | |||||||||
MCEWAN, Allan Scott | Administrateur | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 75569660002 | ||||||||
NEWMAN, Mark | Administrateur | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | Managing Director | 62529820001 | ||||||||
PRINCE, Ryan David | Administrateur | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | Managing Director | 85682450077 | ||||||||
REES, Sally Irene | Administrateur | 3 Sandown Gate KT10 9LB Esher Surrey | England | British | Chartered Accountant | 49954790002 | ||||||||
RITSON, Leslie David | Administrateur | Old Middle Cator House Cator Widecombe In The Moor TQ13 7UA Newton Abbot Devonshire | British | Director | 26098610002 | |||||||||
ROBINSON, Justin Bruce | Administrateur | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | Director | 225299130001 | ||||||||
SPRINGETT, Catherine Mary | Administrateur | The Coach House 32 Kerrison Road Ealing W5 5NW London | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 147336720001 | ||||||||
STOCKS, Nigel Peter | Administrateur | Birdwoods School Lane Shackleford GU8 6AZ Godalming Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 147336730001 | ||||||||
VAN OOSTEROM, Sophie | Administrateur | Orlando Road SW4 0LD London 19 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | Banker | 139801070001 | ||||||||
WHITNEY, Paul Sumpter | Administrateur | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | Finance Director | 418890001 | |||||||||
WINTER, Richard Thomas | Administrateur | 33 St Johns Avenue Putney SW15 6AL London | United Kingdom | British | Solicitor Of The Supreme Court | 6308500001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribbon Acquisition Limited | 06 avr. 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 01 déc. 2015 Livré le 02 déc. 2015 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 22 mai 2013 Livré le 03 juin 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 20 juin 2005 Livré le 28 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Brèves mentions L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 juin 2005 Livré le 22 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0