SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED

SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00368815
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SIX CONTINENTS HOTELS & HOLIDAYS LIMITED06 août 200106 août 2001
    BASS HOTELS AND HOLIDAYS LIMITED16 sept. 198516 sept. 1985
    BASS HOLIDAYS LIMITED27 nov. 198427 nov. 1984
    PONTIN'S LIMITED20 août 194120 août 1941

    Quels sont les derniers comptes de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 nov. 2018

    16 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Justin Bruce Robinson en tant que directeur le 14 sept. 2018

    1 pagesTM01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG à 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 22 déc. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 nov. 2017

    LRESSP

    Modification des coordonnées du secrétaire Haysmacintyre Company Secretaries Limited le 18 déc. 2017

    1 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Bruce Robinson le 18 déc. 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Thomas Mabry le 18 déc. 2017

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom à 10 Queen Street Place London EC4R 1AG le 18 déc. 2017

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Michael Teasdale le 18 déc. 2017

    2 pagesCH01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 003688150004

    5 pagesMR05

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 05 oct. 2017

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Bruce Robinson le 03 févr. 2017

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Secrétaire
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4682161
    89121630002
    MABRY, Patrick Thomas
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    LuxembourgGermanCompany Director204005420001
    TEASDALE, Simon Michael
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritishDirector204008350001
    BOLTON, Susan
    10 Haygreen Close
    KT2 7TS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    10 Haygreen Close
    KT2 7TS Kingston Upon Thames
    Surrey
    British59426570001
    COMBEER, Jean Brenda
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    Secrétaire
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    British50345500001
    COMBEER, Jean Brenda
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    Secrétaire
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    British50345500001
    CRANE, Julia Alison
    27 Hatton Court
    Lubbock Road
    BR7 5JQ Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    27 Hatton Court
    Lubbock Road
    BR7 5JQ Chislehurst
    Kent
    BritishCompany Secretary46318020001
    ENGMANN, Catherine
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    British92722710002
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    203613510001
    TOON, Samantha Anne
    10 St.Anthonys Court
    Nightingale Lane
    SW12 8NS London
    Secrétaire
    10 St.Anthonys Court
    Nightingale Lane
    SW12 8NS London
    BritishCompany Secretarial Assistant32930670001
    WHITNEY, Paul Sumpter
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    Secrétaire
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    British418890001
    WILLIAMS, Alison
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    Secrétaire
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    British78744290002
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Secrétaire
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4682161
    89121630002
    PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
    Ten Bishops Square
    E1 6EG London
    Eighth Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ten Bishops Square
    E1 6EG London
    Eighth Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04131463
    125623230001
    BAKER, Skardon Francis
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Administrateur
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United KingdomAmericanInvestment Professional196342720001
    CASTON, Robert Warwick
    Square De Heeus 20
    FOREIGN 1400 Brussels
    Belgium
    Administrateur
    Square De Heeus 20
    FOREIGN 1400 Brussels
    Belgium
    BritishManaging Director1311840002
    EKAS, Petra Cecilia Maria
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Administrateur
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    United KingdomDutchAsset Manager169731050002
    FISH, Andrew John
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    EnglandBritishAccountant77133450001
    GRAHAM, Ian Christopher
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    Administrateur
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    BritishRegional Vice President-Finance31551670001
    JACKMAN, Robert Loehr
    4 Durning Place
    SL5 7EZ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    4 Durning Place
    SL5 7EZ Ascot
    Berkshire
    AmericanVp Legal Counsel35835670003
    KOLEV, Ivaylo
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Administrateur
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    UkBulgarianInvestment Professional193389430001
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor241370450001
    MCCARTHY, John Patrick
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    Administrateur
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    United StatesBanker112396050001
    MCEWAN, Allan Scott
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant75569660002
    NEWMAN, Mark
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    Administrateur
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    United KingdomCanadianManaging Director62529820001
    PRINCE, Ryan David
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomCanadianManaging Director85682450077
    REES, Sally Irene
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    Administrateur
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant49954790002
    RITSON, Leslie David
    Old Middle Cator House
    Cator Widecombe In The Moor
    TQ13 7UA Newton Abbot
    Devonshire
    Administrateur
    Old Middle Cator House
    Cator Widecombe In The Moor
    TQ13 7UA Newton Abbot
    Devonshire
    BritishDirector26098610002
    ROBINSON, Justin Bruce
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritishDirector225299130001
    SPRINGETT, Catherine Mary
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    Administrateur
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    United KingdomBritishChartered Secretary147336720001
    STOCKS, Nigel Peter
    Birdwoods
    School Lane Shackleford
    GU8 6AZ Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Birdwoods
    School Lane Shackleford
    GU8 6AZ Godalming
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor147336730001
    VAN OOSTEROM, Sophie
    Orlando Road
    SW4 0LD London
    19
    United Kingdom
    Administrateur
    Orlando Road
    SW4 0LD London
    19
    United Kingdom
    United KingdomDutchBanker139801070001
    WHITNEY, Paul Sumpter
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    Administrateur
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    BritishFinance Director418890001
    WINTER, Richard Thomas
    33 St Johns Avenue
    Putney
    SW15 6AL London
    Administrateur
    33 St Johns Avenue
    Putney
    SW15 6AL London
    United KingdomBritishSolicitor Of The Supreme Court6308500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05385882
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 déc. 2015
    Livré le 02 déc. 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale,London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent)
    Transactions
    • 02 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 déc. 2017L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 22 mai 2013
    Livré le 03 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutshce Bank Ag, London Branch (The Common Security Agent)
    Transactions
    • 03 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 20 juin 2005
    Livré le 28 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 28 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 juin 2005
    Livré le 22 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transactions
    • 22 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 nov. 2017Commencement of winding up
    03 juil. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Harvey Dean
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0