T.T.BOUGHTON & SONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéT.T.BOUGHTON & SONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00373198
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de T.T.BOUGHTON & SONS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe T.T.BOUGHTON & SONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BAKER TILLY RESTRUCTURING & RECOVERY LLP
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de T.T.BOUGHTON & SONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour T.T.BOUGHTON & SONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 oct. 2012

    18 pages4.68

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    10 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    7 pagesF10.2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 20 oct. 2011

    55 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 05 oct. 2011

    55 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Résultat de la réunion des créanciers

    2 pages2.23B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    4 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    75 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    5 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de Graycar Business Park Barton Turn, Barton Under Needwood, Burton on Trent Staffordshire DE13 8EN le 18 avr. 2011

    1 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination de Paul Maidstone en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 janv. 2011

    État du capital au 25 janv. 2011

    • Capital: GBP 790,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Karen Elizabeth Gallagher le 17 déc. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de James Walsh en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 août 2009

    25 pagesAA

    Nomination de Mr James Richard Chester Walsh en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Brian Husselbee en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Manny Weiss le 01 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Brian Leslie Husselbee le 01 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Karen Elizabeth Gallagher le 01 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de T.T.BOUGHTON & SONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GALLAGHER, Karen Elizabeth
    Dame Annis House
    16 Burgh Heath Road
    KT17 4LL Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Dame Annis House
    16 Burgh Heath Road
    KT17 4LL Epsom
    Surrey
    EnglandBritishDirector61071940006
    WEISS, Manny
    Danescroft Gardens
    NW4 2ND London
    1a
    Administrateur
    Danescroft Gardens
    NW4 2ND London
    1a
    EnglandAmericanDirector37758940002
    BOUGHTON, Richard William
    11 Fleet Close
    Hughenden Valley
    HP14 4LL High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    11 Fleet Close
    Hughenden Valley
    HP14 4LL High Wycombe
    Buckinghamshire
    British18085020001
    MAIDSTONE, Paul Kenneth
    2 Paget Rise
    WS15 3EF Abbots Bromley
    Staffordshire
    Secrétaire
    2 Paget Rise
    WS15 3EF Abbots Bromley
    Staffordshire
    BritishFinance Controller97431040001
    MORGAN, Colin Graham
    30 Cardy Road
    HP1 1SQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    30 Cardy Road
    HP1 1SQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British55884890001
    BOUGHTON, John Henry
    69 Amersham Road
    Little Chalfont
    HP6 6SP Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    69 Amersham Road
    Little Chalfont
    HP6 6SP Amersham
    Buckinghamshire
    BritishEngineer22182900001
    BOUGHTON, Richard William
    11 Fleet Close
    Hughenden Valley
    HP14 4LL High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    11 Fleet Close
    Hughenden Valley
    HP14 4LL High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary18085020001
    BOUGHTON, Stephen Rutland
    East Newton Farm Leigh Cross
    Zeal Monachorum
    EX17 6LH Crediton
    Devon
    Administrateur
    East Newton Farm Leigh Cross
    Zeal Monachorum
    EX17 6LH Crediton
    Devon
    EnglandBritishManaging Director71711490002
    BOUGHTON, Thomas Trafford
    Dodds Mill House Chenies
    WD3 6EU Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Dodds Mill House Chenies
    WD3 6EU Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishEngineer50979890001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Secretary70326980001
    EVANS, John Russell
    6 Poyntz Gardens
    Dallington
    NN5 7RY Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    6 Poyntz Gardens
    Dallington
    NN5 7RY Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director46914950002
    GRAHAM, David John
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    Administrateur
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    United KingdomBritishFinancial Director75314100001
    HUSSELBEE, Brian Leslie
    16 Goodwood Drive
    Streetly
    B74 2JG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    16 Goodwood Drive
    Streetly
    B74 2JG Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishGroup Managing Director74076970001
    ISAAC, Michael James
    259 Morley Road
    Oakwood
    DE21 4TD Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    259 Morley Road
    Oakwood
    DE21 4TD Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishChartered Accountant106397180001
    PARK, John
    Doebank House
    Avenue Road, Astwood Bank
    B96 6AT Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Doebank House
    Avenue Road, Astwood Bank
    B96 6AT Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector71675650001
    ROBERTSON-SMITH, Michael John
    42 Mansell Street
    CV37 6NR Stratford Upon Avon
    Administrateur
    42 Mansell Street
    CV37 6NR Stratford Upon Avon
    United KingdomBritishEngineer85369940001
    SCHAPIRA, Jonathan Joseph
    23 Shirehall Lane
    NW4 2PE London
    Administrateur
    23 Shirehall Lane
    NW4 2PE London
    EnglandBritishChartered Accountant70891580001
    SULLIVAN, Derek Maurice
    Green End Orchard
    Radnage
    HP14 4BZ High Wycombe
    Bucks
    Administrateur
    Green End Orchard
    Radnage
    HP14 4BZ High Wycombe
    Bucks
    BritishChartered Accountant22180950001
    WALSH, James Richard Chester
    Graycar Business Park
    Barton Turn, Barton Under
    DE13 8EN Needwood, Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Graycar Business Park
    Barton Turn, Barton Under
    DE13 8EN Needwood, Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishGroup Md48669590002
    WINTER, Anthony Joseph
    8 Petersham Mews
    SW7 5NR London
    Administrateur
    8 Petersham Mews
    SW7 5NR London
    BritishChartered Accountant55939390003

    T.T.BOUGHTON & SONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 oct. 2000
    Livré le 08 nov. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Manrows Venture Partners Limited
    Transactions
    • 08 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 23 mai 2000
    Livré le 10 juin 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 21 avr. 1999
    Livré le 28 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Account number 80511110. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 août 1997
    Livré le 30 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage any f/h and l/h property with all fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery; by way of fixed charge all plant, machinery and equipment, all present and future goodwill and uncalled capital, all present and future book and other debts; by way of floating charge all undertaking and all property and assets both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Manrows Venture Partners Limited
    Transactions
    • 30 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 02 juin 1997
    Livré le 17 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Herbert '9B' lathe (adapted for long boring) serial no. Unknown; 6FT post jib with air hoist serial no. Unknown; o'brian 10-speed pillar drill serial no. Unknown,see schedule attached to the form M395 for full details of all the mortgaged property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1997
    Livré le 18 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 30 bell lane little chalfont buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 05 mars 1997
    Livré le 19 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 mars 1997
    Livré le 15 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a the old stables venn lane stoke fleming devon dn 102351.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Transfer deed
    Créé le 06 avr. 1994
    Livré le 25 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charges on all property and/or assets listed on schedule together with all buildins fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juin 1993
    Livré le 25 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brèves mentions
    The old stables venn lane stoke flemming dartmouth.
    Personnes ayant droit
    • Chesham Building Society
    Transactions
    • 25 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of guarantee
    Créé le 15 juin 1993
    Livré le 19 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £271000 due from the comapny to the chargee under a mortgage dated 15/06/93
    Brèves mentions
    Property k/a broome court broomhill dartmouth devon.
    Personnes ayant droit
    • Chesham Building Society
    Transactions
    • 19 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 juin 1993
    Livré le 21 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 4 penn street works penn street amersham buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 07 déc. 1990
    Livré le 22 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 72,000
    Brèves mentions
    F/H the forge bell lane amersham buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Chesham Building Society
    Transactions
    • 22 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 1988
    Livré le 20 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at winkleigh, devon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 12 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 1988
    Livré le 20 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land in parish of winkleigh in county of devon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 1988
    Livré le 20 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at winkleigh, devon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 1988
    Livré le 29 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 210,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The f/h factory and adjoining land situated at the airfield winkleigh devon.
    Personnes ayant droit
    • Boughton Pensions Limitede.as Trustees of the Boughton Group Pensions Schem
    Transactions
    • 29 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 11 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mars 1988
    Livré le 16 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plots 1 & 6 industrial estate townstal dartmouth devon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mars 1988
    Livré le 16 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situate at townstale dartmouth devon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mars 1988
    Livré le 10 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at middle hill dolton devon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mars 1988
    Livré le 10 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at middle hill dolton devon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mars 1988
    Livré le 10 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at middle hill dolton devon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mars 1988
    Livré le 10 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at middle hill dolton devon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 juil. 1986
    Livré le 28 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land part of honor's yard, lodge lane, chalfont st giles, buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 juil. 1986Enregistrement d'une charge
    • 23 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 déc. 1985
    Livré le 10 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at jasons hill, latimer, buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 22 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    T.T.BOUGHTON & SONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 oct. 2011Administration ended
    06 avr. 2011Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Guy Edward Brooke Mander
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    practitioner
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Graham Paul Bushby
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    practitioner
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    2
    DateType
    20 mars 2014Dissolved on
    26 oct. 2011Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Guy Edward Brooke Mander
    The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    practitioner
    The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Graham Paul Bushby
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    practitioner
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0