WILTSHIER PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWILTSHIER PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00379646
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WILTSHIER PLC ?

    • (7415) /

    Où se situe WILTSHIER PLC ?

    Adresse du siège social
    Manor Court
    High Street
    UB7 0AQ Harmondsworth
    Middlesex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WILTSHIER PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JOHN E. WILTSHIER GROUP PLC23 août 198223 août 1982
    JOHN E. WILTSHIER & COMPANY LIMITED27 mars 194327 mars 1943

    Quels sont les derniers comptes de WILTSHIER PLC ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2002
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2003
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2001

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WILTSHIER PLC ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au28 mai 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation11 juin 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WILTSHIER PLC ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour WILTSHIER PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages244

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2001

    14 pagesAA

    legacy

    1 pages244

    legacy

    7 pages363s

    Divers

    Section 394
    1 pagesMISC

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2000

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    6 pages363s

    Qui sont les dirigeants de WILTSHIER PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COOPER, Phillip John
    126 Broad Hinton
    RG10 0XH Twyford
    Berkshire
    Administrateur
    126 Broad Hinton
    RG10 0XH Twyford
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director116775310001
    SAUNDERS, Michael
    37 Camden Road
    LD3 7RT Brecon
    Powys
    Wales
    Secrétaire
    37 Camden Road
    LD3 7RT Brecon
    Powys
    Wales
    British85860030001
    SNASDELL, Michael Percy
    84 Wood Ride
    Petts Wood
    BR5 1PY Orpington
    Kent
    Secrétaire
    84 Wood Ride
    Petts Wood
    BR5 1PY Orpington
    Kent
    British726550001
    SUMNER, Peter Charles
    27 Quince Tree Way
    RG27 9SG Hook
    Hampshire
    Secrétaire
    27 Quince Tree Way
    RG27 9SG Hook
    Hampshire
    British62704800001
    AHEARN, Paul John
    The Croft
    Anglefield Road
    HP4 3JA Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Croft
    Anglefield Road
    HP4 3JA Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishDirector39260100001
    ALKEMA, Dirk
    Feenlanden 195
    Hoevelaken
    3871RC Gelderland
    The Netherlands
    Administrateur
    Feenlanden 195
    Hoevelaken
    3871RC Gelderland
    The Netherlands
    DutchCompany Director51803490001
    BARRAT, Douglas Anthony
    Hereford House Avenue Road
    CM23 5NT Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Hereford House Avenue Road
    CM23 5NT Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishCompany Director48797440001
    DAVIES, Angie Michael
    Little Woolpit
    Ewhurst
    GU6 7NP Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Little Woolpit
    Ewhurst
    GU6 7NP Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant35774310001
    ELLIS, Michael John
    Yew Tree Cottage
    The Green
    MK18 3LW Dunton
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    The Green
    MK18 3LW Dunton
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director14016520001
    HEATHFIELD, Robert
    1 Redwing Rise
    Merrow
    GU4 7DU Guildford
    Surrey
    Administrateur
    1 Redwing Rise
    Merrow
    GU4 7DU Guildford
    Surrey
    EnglandBritishBaronsmead Director1128300001
    HILLS, Harrie John
    Hillview Agester Lane
    Denton
    CT4 6NP Canterbury
    Kent
    Administrateur
    Hillview Agester Lane
    Denton
    CT4 6NP Canterbury
    Kent
    BritishCompany Director10223500001
    MACKINNON, Alan Barclay
    Augusta House
    Cranbrook Road
    TN17 1OX Goodhurst
    Kent
    Administrateur
    Augusta House
    Cranbrook Road
    TN17 1OX Goodhurst
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant61300010002
    MARSDEN, Christopher John
    Dubthorn House Dubthorn Lane
    Betchton
    CW11 4TA Sandbach
    Cheshire
    Administrateur
    Dubthorn House Dubthorn Lane
    Betchton
    CW11 4TA Sandbach
    Cheshire
    BritishDirector59233440001
    MIDDLEMISS, James Michael
    17 Merlin Park
    FK14 7BZ Dollar
    Clackmannanshire
    Administrateur
    17 Merlin Park
    FK14 7BZ Dollar
    Clackmannanshire
    BritishCompany Director87720001
    MYERS, Derek
    10 Primrose Close
    TS14 8ED Guisborough
    Cleveland
    Administrateur
    10 Primrose Close
    TS14 8ED Guisborough
    Cleveland
    BritishCompany Director13487810001
    ROBERTSHAW, Michael Leslie
    29 Belsize Avenue
    NW3 4BL London
    Administrateur
    29 Belsize Avenue
    NW3 4BL London
    BritishCompany Director9233350001
    SCHOONDERBEEK, Johannes Timotius Joseph
    37b Spencer Road
    Chiswick
    W4 3SS London
    Administrateur
    37b Spencer Road
    Chiswick
    W4 3SS London
    DutchFinance Director77533220001
    SCULL, Brian William
    Fairfield Lodge
    Pelham Road Albury
    SG11 2JF Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    Fairfield Lodge
    Pelham Road Albury
    SG11 2JF Ware
    Hertfordshire
    BritishCompany Director10928150001
    SHAW, Geoffrey Robert
    27 St Johns Road
    IG10 1RZ Loughton
    Essex
    Administrateur
    27 St Johns Road
    IG10 1RZ Loughton
    Essex
    EnglandBritishCompany Director50765930002
    SNASDELL, Michael Percy
    84 Wood Ride
    Petts Wood
    BR5 1PY Orpington
    Kent
    Administrateur
    84 Wood Ride
    Petts Wood
    BR5 1PY Orpington
    Kent
    BritishChartered Secretary726550001
    STEENVOORDEN, Raymond Theodorus Antonius
    Tanglewood House
    9 Norfolk Farm Road Pyrford
    GU22 8LF Woking
    Surrey
    Administrateur
    Tanglewood House
    9 Norfolk Farm Road Pyrford
    GU22 8LF Woking
    Surrey
    DutchCompany Director56223740001
    TAYLOR, Alan Robert
    68 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HP Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    68 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HP Hampton
    Middlesex
    BritishChartered Surveyor3710470001
    WATTS, John Clifford
    11 West Drive
    Sonning On Thames
    RG4 0GE Reading
    Berkshire
    Administrateur
    11 West Drive
    Sonning On Thames
    RG4 0GE Reading
    Berkshire
    BritishCompany Director499270001

    WILTSHIER PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 14 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 winnal close winchester hampshire with buildings & fixtures (inc trade) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 14 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 mars 1994
    Livré le 21 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 1994
    Livré le 10 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the west side of tovil green, maidstone, kent t/no:k 687769.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 17 sept. 1993
    Livré le 22 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 22 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 sept. 1993
    Livré le 20 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H hall place harbledown canterbury kent t/n K694762 and the proceeds of sale thereof an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 25 févr. 1993
    Livré le 05 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to the facility by way of l oan referred to in a letter dated 29/11/88 addressed to the mortgagor in the sum of £2,000,000 now reduced to £1,090,000
    Brèves mentions
    The sum of £1,090,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank finance (C.I.) limited in jersey on an account numbered 3007630 and earmarked or designated by reference to the comapny.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 déc. 1992
    Livré le 29 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Hereford house hereford way hardwick narrows industrial estate kings lynn norfolk t/n NK98713 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of debt
    Créé le 13 mai 1992
    Livré le 26 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum of £2,000,000 due from the royalbank of scotland (iom) to the company.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 mars 1992
    Livré le 07 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £260,000
    Brèves mentions
    "The woodlands" 91 woodland road darlington co. Durham.
    Personnes ayant droit
    • Darlington Building Society
    Transactions
    • 07 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Jersey security interest agreement see 395 for full description
    Créé le 16 janv. 1992
    Livré le 04 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a facility by way of a loan referred to in a letter dated 29TH/11/88 addressed to the company in the sum of £2,000,000 now reduced to £1,545,000
    Brèves mentions
    The sum of £1,545,000 in the name of the company on an account no: 2953949 held by national westminster bank finance (C.I.) limited.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of debt
    Créé le 23 déc. 1991
    Livré le 03 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum of £2,000,000 due from the royal bank of scotland (iom) limited to the company including all interest accrued and all increases in the amount of the debt.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage and floating charge.
    Créé le 18 mars 1991
    Livré le 28 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge by way of legal mortgage the property together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) & fixed plant & machinery described in schedule a to form 395 (see schedule for full details of the property) floating charge upon all other. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 28 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of pledge.
    Créé le 24 janv. 1991
    Livré le 06 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum of £2,000,000 invested with the bank in special interest bearing account no: do 280495 together with any smaller or lowger sums which may thereafter be invested.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 25 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of deposit account
    Créé le 20 déc. 1990
    Livré le 31 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assignment of the sum of £2,000,000 or such sum or such part thereof as is for the time being standing to the credit of the deposit account with 3I group PLC with all interest & all right title & interest of the company whatsoever present & future.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge over cash deposit
    Créé le 03 mai 1990
    Livré le 12 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge and as a counting security the balance (including and interest) from time to time standing to the credit of deposit account (number 37215665) not with standing any settlement of account or otherwise for the payment to the bank of the monies herby secured.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank
    Transactions
    • 12 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 17 oct. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on credit balances
    Créé le 06 janv. 1989
    Livré le 20 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies from time to time held to the credit of the company with the bank on any current, deposit or other account see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 1989Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 avr. 1988
    Livré le 28 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plot 4 prospect road alresford, hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Chartered Trust Public Limited Company.
    Transactions
    • 28 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 16 sept. 1986
    Livré le 18 sept. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from theand/or any associated company and/or any guarantor company to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H land at manor farm house, moor lane, harmondsworth, l/b of hillingdon, title no. Ngl 325108. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited.
    Transactions
    • 18 sept. 1986Enregistrement d'une charge
    • 17 oct. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 01 août 1985
    Livré le 21 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account (s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re: john e wiltshier group limited.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 1985Enregistrement d'une charge
    • 17 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 22 mars 1985
    Livré le 26 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    10 to 15 (inclusive) hawks lane, canterbury kent, a site at the corner of beer court lane and stour street, canterbury aforesaid title no. K 408373 72 & 73 stour street aforesaid and 2 to 5 blue coat boys cottages (site of) and 74 & 75 stour street aforesaid (site of) together with all buildings & fixtures (inlcuding trade fixtures) and fixed plant & machinery from time to time thereon & therein.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 26 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security registered at sasines on the 31/1/85
    Créé le 31 janv. 1985
    Livré le 06 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The plot of ground with buildings thereon known as ten lynedoch place glagow. The triangular plot of ground situated at the rear of eight lynedoch place that rectangular plot of land at the rear of nine lynedoch place (for details see doc M103).
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 06 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 29 janv. 1985
    Livré le 06 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property on the south east side of vale road tonbridge title no k 392377 f/h property on the south east side of eastern lane winchester hampshire including trade fixtures. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 06 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Asignment of deposit account
    Créé le 28 déc. 1984
    Livré le 07 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the tems of an agreement of even date
    Brèves mentions
    £850,000 deposited with investors in industry group PLC together with all interest credited thereto.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Standard security presented for registration at sasines on the 11/1/84
    Créé le 16 déc. 1983
    Livré le 30 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond of even date
    Brèves mentions
    1) 10 lynedoch place, glasgow 2) triangular plot of ground situate at rear of 8 lynedoch place. 3) rectangular plot of ground at rear of 9 lynedoch place aforesaid.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 10 oct. 1983
    Livré le 21 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H may avenue estate, may avenue, gravesham, kent.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 oct. 1983Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0