AMEC SPARECO (12) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | AMEC SPARECO (12) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00381547 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AMEC SPARECO (12) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AMEC SPARECO (12) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour AMEC SPARECO (12) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Jennifer Ann Warburton en tant que secrétaire le 22 févr. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Helen Morrell en tant que secrétaire le 22 févr. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mrs Helen Morrell en tant que secrétaire le 22 juil. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Laskey Fidler en tant que secrétaire le 22 juil. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 13 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Allen en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Amec Nominees Limited en tant qu'administrateur | 2 pages | AP02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 4 pages | AUD | ||||||||||
Divers Section 519 | 3 pages | MISC | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de AMEC SPARECO (12) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARBURTON, Jennifer Ann | Secrétaire | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | 225597720001 | |||||||||||
| LING, Grant Richmond | Administrateur | The Academy 16 Highgate Hill N19 5NS London Flat 24 | England | British | 68935320003 | |||||||||
| AMEC NOMINEES LIMITED | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England |
| 32732300002 | ||||||||||
| ELLIOTT, David John | Secrétaire | Temple View Banner Lane, Barston B92 0JY Solihull | British | 99771830001 | ||||||||||
| FELLOWES, Colin | Secrétaire | 9 Thistlewood Drive Summerfields SK9 2RF Wilmslow Cheshire | British | 800670001 | ||||||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Secrétaire | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | British | 141025870003 | ||||||||||
| MORRELL, Helen | Secrétaire | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire | 210981190001 | |||||||||||
| RENSHAW, Geoffrey Mark | Secrétaire | 9 Morgrove Avenue Knowle B93 9QL Solihull West Midlands | British | 61351870001 | ||||||||||
| ALLEN, Mark Edward Hugh | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire | England | British | 148511740001 | |||||||||
| AVENAS, Michel | Administrateur | 16 Rue Du Colonel Candelot 92340 Bourg La Reine France | French | 36238710002 | ||||||||||
| BERARD, Jean-Paul | Administrateur | 1 Westmount Square Suite 650 FOREIGN Montreal Quebec H32 2sr Canada | French | 14302260001 | ||||||||||
| BIDDLE, Norman Michael, Dr | Administrateur | The Chantry 25 Church Road, Abbots Leigh BS8 3QP Bristol | United Kingdom | British | 35032440001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Brian Harry | Administrateur | Tannery Cottage Manchester Road Lostock Gralam CW9 7PJ Northwich Cheshire | British | 14302270001 | ||||||||||
| CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd | Administrateur | 58 Bracken Road HX6 2HR Brighouse West Yorkshire | British | 107105790003 | ||||||||||
| CLARKE, John James | Administrateur | Manor Close East Horsley KT24 6SB Leatherhead Dalehurst Surrey | United Kingdom | British | 150891000001 | |||||||||
| COADY, Arthur Bernard | Administrateur | 79 Bel Air Place Sw FOREIGN Calgary Alberta T2z 2c3 Canada | Canadian | 14302210001 | ||||||||||
| COWPER, Jonathan | Administrateur | 2 Bluebell Close Etherley Dene DL14 0TL Bishop Auckland County Durham | British | 124817460001 | ||||||||||
| DELIGNY, Jean Louis | Administrateur | 106 Avenue Emile Zola 92100 Boulogne Billancourt France | French | 45894430001 | ||||||||||
| DITTMER, Robert | Administrateur | 78 Sunset Way S E Calgary Alberta T2x 3c1 Canada | Canadian | 61292360003 | ||||||||||
| ELIA, Claudio | Administrateur | 40 Ridgeview Avenue Greenwich Ct06830 Usa | Italian | 36238720001 | ||||||||||
| EMMANUEL, Derousseaux | Administrateur | 25 Rue St J B De La Salle Lille FOREIGN France 59000 | French | 60092120001 | ||||||||||
| GOURVENNEC, Michel Jean Jacques | Administrateur | 3151 Freeman Street Coconut Grove Florida 33133 Usa | French | 41434270003 | ||||||||||
| HAEGEL, Didier Gerard Patrick | Administrateur | 13-15 Rue De 8 Mai 1945 Villiers Sur Marne FOREIGN 94350 France | French | 42856880001 | ||||||||||
| HIGGINS, Nigel Alan | Administrateur | Conifers Cecil Avenue HX3 8SN Halifax West Yorkshire | England | British | 119181620001 | |||||||||
| KENNEDY, Michael George | Administrateur | 34 Rue Numa Gillet 77690 Montigny Sur Loing France | British | 46681650001 | ||||||||||
| LANCEREAU, Alain Yves Marcel Andre | Administrateur | 51 Rue D Archeres Maisons Laffitte 78600 France | French | 47515880001 | ||||||||||
| LEBRUN, Andre, Msr | Administrateur | 3 Avenue Stephane Mallarme Paris 75017 FOREIGN France | French | 34945510001 | ||||||||||
| LEE, Stephen Warwick | Administrateur | The Barn Hildenley YO17 6QU Malton North Yorkshire | British | 84186060002 | ||||||||||
| PATTERSON, Martin | Administrateur | 985 Clement FOREIGN Saint - Laurent Quebec H2v 3zx Canada | Canadian | 14302220001 | ||||||||||
| PEARSON, Harold William | Administrateur | 136 Avondale Court L7L2M8 Burlington Ontario Canada | Canadian | 63588330001 | ||||||||||
| PFLEGER, Didier Maurice Christian | Administrateur | Faubourg De Brisach 90000 Belfort 34 France | French | 128722240001 | ||||||||||
| PRICE, John Leslie | Administrateur | 536 Coach Grove Road Sw FOREIGN Calgary Alberta T3h 1j4 Canada | Canadian | 14302230001 | ||||||||||
| REALE, Robert J | Administrateur | 444 E86th St Apt 36f New York NY 10028 Usa | Us | 47515760001 | ||||||||||
| REDDEN, Charles Frederick David | Administrateur | 161 Woodpark Cx S W Calgary Alberta T2w 6es FOREIGN Canada | Canadian | 61291470001 | ||||||||||
| RENSHAW, Geoffrey Mark | Administrateur | 9 Morgrove Avenue Knowle B93 9QL Solihull West Midlands | British | 61351870001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AMEC SPARECO (12) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amec Foster Wheeler Group Limited | 06 avr. 2016 | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
AMEC SPARECO (12) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of insurance (the "assignment") | Créé le 12 mai 1999 Livré le 26 mai 1999 | En cours | Montant garanti In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of the company to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof | |
Brèves mentions The company assigns and transfers to the administrative agent all of its interests as insured under the policies of insurance described in the certificate of insurance attached as exhibit a to the assignment and under any and all policies issued in replacement of or in substitution for such policies or renewals of such policies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating security document (the "security document") | Créé le 12 mai 1999 Livré le 26 mai 1999 | En cours | Montant garanti In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of such chargor to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Créé le 01 déc. 1998 Livré le 09 déc. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Account number 57589055. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of charge | Créé le 10 avr. 1992 Livré le 28 avr. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All monies standing to the credit of any account(s) in the bank in name of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 08 août 1990 Livré le 24 août 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A credit agreement | Créé le 15 mars 1990 Livré le 27 mars 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Brèves mentions All its right, title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurances particulars as from time to time varies or extended and the benefit of all power and remedies for cancelling and/or enforcing the same (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge on book debts | Créé le 06 sept. 1989 Livré le 14 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book debts & other debts present & future the company's entire right, title , benefit & interest present & future in all debts and claims due or owing to the company under the contracts particulars of which are set out in the schedule on form 395 (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 22 févr. 1989 Livré le 27 févr. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All rights title benefit and interest under the contracts see form 395 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental trust deed | Créé le 16 mai 1980 Livré le 25 mai 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing debenture stock of guest keen and nettlefords (U.K.) LTD amounting to £3,509,390 supplemental to a trust deed dated 17-11-70 & deeds supplemental thereto | |
Brèves mentions Floating charge over the undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0