AMEC SPARECO (12) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAMEC SPARECO (12) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00381547
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AMEC SPARECO (12) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe AMEC SPARECO (12) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AMEC SPARECO (12) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AMEC BIRWELCO LIMITED24 oct. 200024 oct. 2000
    AGRA BIRWELCO LIMITED01 mars 199901 mars 1999
    BIRWELCO LIMITED18 févr. 198718 févr. 1987
    GKN BIRWELCO LIMITED06 juil. 194306 juil. 1943

    Quels sont les derniers comptes de AMEC SPARECO (12) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour AMEC SPARECO (12) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mrs Jennifer Ann Warburton en tant que secrétaire le 22 févr. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Helen Morrell en tant que secrétaire le 22 févr. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Helen Morrell en tant que secrétaire le 22 juil. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Christopher Laskey Fidler en tant que secrétaire le 22 juil. 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2016

    État du capital au 15 juin 2016

    • Capital: GBP 750,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2015

    État du capital au 15 juin 2015

    • Capital: GBP 750,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juin 2014

    État du capital au 11 juin 2014

    • Capital: GBP 750,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de Mark Allen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Amec Nominees Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Démission de l'auditeur

    4 pagesAUD

    Divers

    Section 519
    3 pagesMISC

    Qui sont les dirigeants de AMEC SPARECO (12) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WARBURTON, Jennifer Ann
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    Secrétaire
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    225597720001
    LING, Grant Richmond
    The Academy
    16 Highgate Hill
    N19 5NS London
    Flat 24
    Administrateur
    The Academy
    16 Highgate Hill
    N19 5NS London
    Flat 24
    EnglandBritish68935320003
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement374498
    32732300002
    ELLIOTT, David John
    Temple View
    Banner Lane, Barston
    B92 0JY Solihull
    Secrétaire
    Temple View
    Banner Lane, Barston
    B92 0JY Solihull
    British99771830001
    FELLOWES, Colin
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    British800670001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Secrétaire
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    British141025870003
    MORRELL, Helen
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    210981190001
    RENSHAW, Geoffrey Mark
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    British61351870001
    ALLEN, Mark Edward Hugh
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    EnglandBritish148511740001
    AVENAS, Michel
    16 Rue Du Colonel Candelot
    92340 Bourg La Reine
    France
    Administrateur
    16 Rue Du Colonel Candelot
    92340 Bourg La Reine
    France
    French36238710002
    BERARD, Jean-Paul
    1 Westmount Square
    Suite 650
    FOREIGN Montreal
    Quebec H32 2sr
    Canada
    Administrateur
    1 Westmount Square
    Suite 650
    FOREIGN Montreal
    Quebec H32 2sr
    Canada
    French14302260001
    BIDDLE, Norman Michael, Dr
    The Chantry
    25 Church Road, Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    Administrateur
    The Chantry
    25 Church Road, Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    United KingdomBritish35032440001
    CARTWRIGHT, Brian Harry
    Tannery Cottage Manchester Road
    Lostock Gralam
    CW9 7PJ Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Tannery Cottage Manchester Road
    Lostock Gralam
    CW9 7PJ Northwich
    Cheshire
    British14302270001
    CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd
    58 Bracken Road
    HX6 2HR Brighouse
    West Yorkshire
    Administrateur
    58 Bracken Road
    HX6 2HR Brighouse
    West Yorkshire
    British107105790003
    CLARKE, John James
    Manor Close
    East Horsley
    KT24 6SB Leatherhead
    Dalehurst
    Surrey
    Administrateur
    Manor Close
    East Horsley
    KT24 6SB Leatherhead
    Dalehurst
    Surrey
    United KingdomBritish150891000001
    COADY, Arthur Bernard
    79 Bel Air Place Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2z 2c3
    Canada
    Administrateur
    79 Bel Air Place Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2z 2c3
    Canada
    Canadian14302210001
    COWPER, Jonathan
    2 Bluebell Close
    Etherley Dene
    DL14 0TL Bishop Auckland
    County Durham
    Administrateur
    2 Bluebell Close
    Etherley Dene
    DL14 0TL Bishop Auckland
    County Durham
    British124817460001
    DELIGNY, Jean Louis
    106 Avenue Emile Zola
    92100 Boulogne Billancourt
    France
    Administrateur
    106 Avenue Emile Zola
    92100 Boulogne Billancourt
    France
    French45894430001
    DITTMER, Robert
    78 Sunset Way S E
    Calgary
    Alberta
    T2x 3c1
    Canada
    Administrateur
    78 Sunset Way S E
    Calgary
    Alberta
    T2x 3c1
    Canada
    Canadian61292360003
    ELIA, Claudio
    40 Ridgeview Avenue
    Greenwich
    Ct06830
    Usa
    Administrateur
    40 Ridgeview Avenue
    Greenwich
    Ct06830
    Usa
    Italian36238720001
    EMMANUEL, Derousseaux
    25 Rue St J B De La Salle
    Lille
    FOREIGN France 59000
    Administrateur
    25 Rue St J B De La Salle
    Lille
    FOREIGN France 59000
    French60092120001
    GOURVENNEC, Michel Jean Jacques
    3151 Freeman Street
    Coconut Grove
    Florida 33133
    Usa
    Administrateur
    3151 Freeman Street
    Coconut Grove
    Florida 33133
    Usa
    French41434270003
    HAEGEL, Didier Gerard Patrick
    13-15 Rue De 8 Mai 1945
    Villiers Sur Marne
    FOREIGN 94350 France
    Administrateur
    13-15 Rue De 8 Mai 1945
    Villiers Sur Marne
    FOREIGN 94350 France
    French42856880001
    HIGGINS, Nigel Alan
    Conifers
    Cecil Avenue
    HX3 8SN Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Conifers
    Cecil Avenue
    HX3 8SN Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritish119181620001
    KENNEDY, Michael George
    34 Rue Numa Gillet
    77690 Montigny Sur Loing
    France
    Administrateur
    34 Rue Numa Gillet
    77690 Montigny Sur Loing
    France
    British46681650001
    LANCEREAU, Alain Yves Marcel Andre
    51 Rue D Archeres
    Maisons Laffitte
    78600 France
    Administrateur
    51 Rue D Archeres
    Maisons Laffitte
    78600 France
    French47515880001
    LEBRUN, Andre, Msr
    3 Avenue Stephane Mallarme
    Paris 75017
    FOREIGN France
    Administrateur
    3 Avenue Stephane Mallarme
    Paris 75017
    FOREIGN France
    French34945510001
    LEE, Stephen Warwick
    The Barn
    Hildenley
    YO17 6QU Malton
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Barn
    Hildenley
    YO17 6QU Malton
    North Yorkshire
    British84186060002
    PATTERSON, Martin
    985 Clement
    FOREIGN Saint - Laurent
    Quebec H2v 3zx
    Canada
    Administrateur
    985 Clement
    FOREIGN Saint - Laurent
    Quebec H2v 3zx
    Canada
    Canadian14302220001
    PEARSON, Harold William
    136 Avondale Court
    L7L2M8 Burlington
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    136 Avondale Court
    L7L2M8 Burlington
    Ontario
    Canada
    Canadian63588330001
    PFLEGER, Didier Maurice Christian
    Faubourg De Brisach
    90000 Belfort
    34
    France
    Administrateur
    Faubourg De Brisach
    90000 Belfort
    34
    France
    French128722240001
    PRICE, John Leslie
    536 Coach Grove Road Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T3h 1j4
    Canada
    Administrateur
    536 Coach Grove Road Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T3h 1j4
    Canada
    Canadian14302230001
    REALE, Robert J
    444 E86th St Apt 36f
    New York
    NY 10028 Usa
    Administrateur
    444 E86th St Apt 36f
    New York
    NY 10028 Usa
    Us47515760001
    REDDEN, Charles Frederick David
    161 Woodpark Cx S W
    Calgary Alberta T2w 6es
    FOREIGN Canada
    Administrateur
    161 Woodpark Cx S W
    Calgary Alberta T2w 6es
    FOREIGN Canada
    Canadian61291470001
    RENSHAW, Geoffrey Mark
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    British61351870001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AMEC SPARECO (12) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    06 avr. 2016
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4612748
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    AMEC SPARECO (12) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment of insurance (the "assignment")
    Créé le 12 mai 1999
    Livré le 26 mai 1999
    En cours
    Montant garanti
    In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of the company to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof
    Brèves mentions
    The company assigns and transfers to the administrative agent all of its interests as insured under the policies of insurance described in the certificate of insurance attached as exhibit a to the assignment and under any and all policies issued in replacement of or in substitution for such policies or renewals of such policies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce (The "Administrative Agent")
    Transactions
    • 26 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating security document (the "security document")
    Créé le 12 mai 1999
    Livré le 26 mai 1999
    En cours
    Montant garanti
    In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of such chargor to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce (The "Administrative Agent")
    Transactions
    • 26 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 01 déc. 1998
    Livré le 09 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Account number 57589055. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 10 avr. 1992
    Livré le 28 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account(s) in the bank in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 août 1990
    Livré le 24 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A credit agreement
    Créé le 15 mars 1990
    Livré le 27 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    All its right, title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurances particulars as from time to time varies or extended and the benefit of all power and remedies for cancelling and/or enforcing the same (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 27 mars 1990Enregistrement d'une charge
    Charge on book debts
    Créé le 06 sept. 1989
    Livré le 14 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts & other debts present & future the company's entire right, title , benefit & interest present & future in all debts and claims due or owing to the company under the contracts particulars of which are set out in the schedule on form 395 (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    Deed of assignment
    Créé le 22 févr. 1989
    Livré le 27 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights title benefit and interest under the contracts see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Banque Arake Et International I'investisement
    Transactions
    • 27 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    Supplemental trust deed
    Créé le 16 mai 1980
    Livré le 25 mai 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing debenture stock of guest keen and nettlefords (U.K.) LTD amounting to £3,509,390 supplemental to a trust deed dated 17-11-70 & deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    Floating charge over the undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 25 mai 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0