DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD

DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société 00394532
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD ?

    • Autres activités des agences de placement (78109) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD ?

    Adresse du siège social
    5 New Street Square
    EC4A 3TW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REMPLOY,LIMITED07 avr. 194507 avr. 1945

    Quels sont les derniers comptes de DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 oct. 2023

    7 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 oct. 2022

    7 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 oct. 2021

    7 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 oct. 2020

    7 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 oct. 2019

    8 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 oct. 2018

    8 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Anthony John Osmond en tant que directeur le 31 déc. 2017

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Simon Macgregor Russell en tant que directeur le 31 déc. 2017

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Iain James Bagwell en tant que directeur le 31 déc. 2017

    2 pagesTM01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 07 oct. 2017

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    42 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    Secrétaire
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement04328885
    84071220002
    JOHN, Helen Sarah Louise
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Civil Servant196520800001
    GOLDSBROUGH, Mary Cathleen
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    Secrétaire
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    163642700001
    JONES, Alan Richard Watson
    18 The Grove
    Finchley
    N3 1QL London
    Secrétaire
    18 The Grove
    Finchley
    N3 1QL London
    British1543580001
    MUNNS, Joanne Mary
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    Secrétaire
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    186347710001
    PHILLIPS, Guy Jonathan Gibson
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    Secrétaire
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    British27254280002
    RELF, Claire Elizabeth
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Secrétaire
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    199725860001
    BAGWELL, Iain James
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    Administrateur
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    EnglandBritishCivil Servant205843140001
    BLACK, Ian
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    Administrateur
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    United KingdomBritishDir128042920002
    BOGIE, William, Dr
    23 Andrews Way
    SL7 3QJ Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    Administrateur
    23 Andrews Way
    SL7 3QJ Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    BritishCo Director34406450001
    BOOTHMAN, Derek Arnold
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    BritishCo Director5733500001
    BOULTON, Leonard James
    Bryn Mair
    Maenan
    LL26 0YR Llanrwst
    Gwynedd
    Administrateur
    Bryn Mair
    Maenan
    LL26 0YR Llanrwst
    Gwynedd
    BritishOperations Dir71649090001
    BROWN, Sarah Elizabeth
    32 Cumberland Street
    SW1V 4LX London
    Administrateur
    32 Cumberland Street
    SW1V 4LX London
    BritishConsultant68693050001
    BUTCHER, Susan Jane
    1 Worwood Drive
    NG2 7LY Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    1 Worwood Drive
    NG2 7LY Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishHuman Resources109151540001
    CARRUTHERS, Elizabeth Muir
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    Administrateur
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    United KingdomBritishCeo184244460001
    COHEN, Ivor Harold, Sir
    24 Selborne Road
    CR0 5JQ Croydon
    Surrey
    Administrateur
    24 Selborne Road
    CR0 5JQ Croydon
    Surrey
    BritishCompany Director2016630001
    COOKE, Peter Nicholas Collins
    Little Ruffians
    Lyon Close North Court Lane
    OX14 1PT Abingdon
    Oxon
    Administrateur
    Little Ruffians
    Lyon Close North Court Lane
    OX14 1PT Abingdon
    Oxon
    BritishProfessor13668240001
    CORBETT, Graham
    95 Coleherne Court
    Old Brompton Road
    SW5 0ED London
    Administrateur
    95 Coleherne Court
    Old Brompton Road
    SW5 0ED London
    BritishBoard Member100461760001
    DAYMOND, Mark
    14 Inglis Road
    Ealing
    W5 3RN London
    Administrateur
    14 Inglis Road
    Ealing
    W5 3RN London
    BritishCo Director2507850001
    FLETCHER, Raymond Norman
    6 Primrose Drive
    OX26 3WP Bicester
    Oxfordshire
    Administrateur
    6 Primrose Drive
    OX26 3WP Bicester
    Oxfordshire
    United KingdomBritishPersonnel Director11943220003
    GRAHAM, Kenneth
    90 Springfield Drive
    IG2 6QS Ilford
    Essex
    Administrateur
    90 Springfield Drive
    IG2 6QS Ilford
    Essex
    BritishCo Director6599980001
    HARLEY, Ian
    Britsih Energy, Systems House
    Alba Campus
    EH54 7EG Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    Britsih Energy, Systems House
    Alba Campus
    EH54 7EG Livingston
    West Lothian
    BritishBoard Member25941180003
    HEYWOOD, David George
    Logie Cedar Road
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    Administrateur
    Logie Cedar Road
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    BritishCompany Director6298840001
    HILL, Jill Vivien
    4 The Rock Mill
    Rockmill Lane
    CV32 6AZ Leamington Spa
    Administrateur
    4 The Rock Mill
    Rockmill Lane
    CV32 6AZ Leamington Spa
    BritishChief Operating Officer65976240002
    HOBBS, Andrew Gordon
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    EnglandBritishSenior Civil Servant159444230001
    HOPKINS, Nigel Peter
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    Administrateur
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    United KingdomBritishFinance Director182163720001
    JACKSON, Roy Arthur
    27 The Ryde
    AL9 5DQ Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    27 The Ryde
    AL9 5DQ Hatfield
    Hertfordshire
    BritishRetired31254980001
    JESSOPP, Patricia Anne
    Stoneycroft Mill House
    LE67 8NJ Thringstone
    Leicestershire
    Administrateur
    Stoneycroft Mill House
    LE67 8NJ Thringstone
    Leicestershire
    BritishExec Director Hr & External Af100701050001
    JOHNSON, John Brian Hansen
    Cambridge Road
    Littlebury
    CB11 4TL Saffron Walden
    Cherington
    Essex
    Administrateur
    Cambridge Road
    Littlebury
    CB11 4TL Saffron Walden
    Cherington
    Essex
    United KingdomBritishOperations133696770001
    KNOWLES, Sandra Anne
    42 Priory Road
    Noak Hill
    RM3 9AT Romford
    Essex
    Administrateur
    42 Priory Road
    Noak Hill
    RM3 9AT Romford
    Essex
    BritishBusiness Director76949980001
    KNOWLES, Stuart Anthony
    19 Countryman Way
    LE67 9QL Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    19 Countryman Way
    LE67 9QL Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector171952740001
    LAING, Jennifer Charlina Ellsworth
    20 Gloucester Crescent
    NW1 7DS London
    Administrateur
    20 Gloucester Crescent
    NW1 7DS London
    EnglandBritishCo Director11815800001
    LEARNER, Richard Charles Maurice, Dr
    11 Princes Gardens
    SW7 1NA London
    Administrateur
    11 Princes Gardens
    SW7 1NA London
    BritishCo Director18569070003
    MANN, Joe
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    Administrateur
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    United KingdomBritishNational Secretary113530650003
    MATTHEWS, Timothy John
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    Administrateur
    Meridian East
    Meridian Business Park
    LE19 1WZ Leicester
    18c
    Leicestershire
    United KingdomBritishChief Executive50382860001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Secretary Of State For Work And Pensions
    Caxton House
    Tothill Street
    SW1H 9NA London
    Department For Work And Pensions
    England
    06 avr. 2016
    Caxton House
    Tothill Street
    SW1H 9NA London
    Department For Work And Pensions
    England
    Non
    Forme juridiqueGovernment Department
    Autorité légaleEngland & Wales
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 29 mars 2012
    Livré le 03 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £100,000 being the amount from time to time held in the deposit account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Legal & General Property Partners (Industrial Fund) Limited and Legal & General Property Partners (Industrial) Nominees Limited
    Transactions
    • 03 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 mai 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 06 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 02 avr. 2002
    Livré le 12 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £1,750.
    Personnes ayant droit
    • Barnardo's
    Transactions
    • 12 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 1996
    Livré le 24 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges on all the company's property and assets execpting those l/h interests or other similar arrangements which by their terms prohibit creation of security over the said l/h interests or other arrangements.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Education and Employment
    Transactions
    • 24 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2013Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 14 déc. 2013Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 09 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 mars 1992
    Livré le 21 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges on all the company's property and assets.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Employment
    Transactions
    • 21 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 1997Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 12 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement
    Créé le 30 janv. 1964
    Livré le 31 janv. 1964
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A sum equal to the amount for the time being outstanding in respect of advances made to the company by the minister of labour in accordance with the agreement dated 12/11/46 and 30/1/64
    Brèves mentions
    A charge by way of legal mortgage of heritable properties in scotland as described on doc 122.. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Treasury Solicitor
    Transactions
    • 31 janv. 1964Enregistrement d'une charge
    • 09 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Sixth further charge supplemental to a debenture dated 26/11/46
    Créé le 01 mai 1963
    Livré le 13 mai 1963
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A sum equal to the amount for the time being outstanding in respect of advances made to the company by the minister of labour and national service in accordance with an agreement dated 12/11/46
    Brèves mentions
    F/H and l/h land and premises as specified on doc 118.
    Personnes ayant droit
    • The Treasury Solicitor
    Transactions
    • 13 mai 1963Enregistrement d'une charge
    • 09 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fifth charge supplemental to debenture dated 26/11/46
    Créé le 18 août 1954
    Livré le 24 août 1954
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A sum equal to the amount for the time being outstanding in respect of advances made to the company by the minister of labour and national service in accordance with an agreement dated 12/11/46
    Brèves mentions
    F/H and l/h land and premises as specified on doc 55.
    Personnes ayant droit
    • The Treasury Solicitor
    Transactions
    • 24 août 1954Enregistrement d'une charge
    • 09 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fourth further charge supplemental to a debenture dated 26/11/46
    Créé le 14 nov. 1951
    Livré le 21 nov. 1951
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A sum equal to the amount for the time being outstanding in respect of advances made to the company by the minister of labour and national service in accordance with an agreement dated 12/11/46
    Brèves mentions
    F/H & l/h land and premises as specified on doc 41.
    Personnes ayant droit
    • The Treasury Solicitor
    Transactions
    • 21 nov. 1951Enregistrement d'une charge
    • 09 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Third further charge supplemental to a debenture dated 26/11/46
    Créé le 22 févr. 1950
    Livré le 01 mars 1950
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A sum equal to the amount for the time being outstanding in respect of advances made to the company by the minister of labour and national service in accordance with an agreement dated 12/11/46
    Brèves mentions
    F/H & l/h land and premises as specified on doc 34.
    Personnes ayant droit
    • The Treasury Solicitor.
    Transactions
    • 01 mars 1950Enregistrement d'une charge
    • 09 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Second further charge supplemental to a debenture dated 26/11/46
    Créé le 22 sept. 1948
    Livré le 30 sept. 1948
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A sum equal to the amount for the time being outstanding in respect of advances made to the company by the minister of labour and national service in accordance with an agreement dated 12/11/46
    Brèves mentions
    F/H and l/h land and premises as specified on doc 20.
    Personnes ayant droit
    • The Treasury Solicitor.
    Transactions
    • 30 sept. 1948Enregistrement d'une charge
    • 09 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 31 mars 1947
    Livré le 12 avr. 1947
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies secured by a debenture dated 26/11/46
    Brèves mentions
    All f/h & l/h property as specified on doc 14.
    Personnes ayant droit
    • The Treasury Solicitor
    Transactions
    • 12 avr. 1947Enregistrement d'une charge
    • 09 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 nov. 1946
    Livré le 02 déc. 1946
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A sum equal to the amount for the time being outstanding in respect of advances made to the company by the minister of labour and national service in accordance with an agreement dated 12 november 1946
    Brèves mentions
    A floating charge over the undertaking and all property and assets present and future a charge by way of legal mortgage on freehold properties being land at uttoxeter road longton, stoke-on-trent with the laundry & all other buildings thereon and land at sutton road, mansfield, notts.
    Personnes ayant droit
    • The Treasury Solicitor
    Transactions
    • 02 déc. 1946Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 2013Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 14 déc. 2013Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 09 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    DISABLED PEOPLE'S EMPLOYMENT CORPORATION (GB) LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 oct. 2017Commencement of winding up
    03 juin 2024Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0