BRANTHAM LAND GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRANTHAM LAND GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00423080
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRANTHAM LAND GROUP LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe BRANTHAM LAND GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRANTHAM LAND GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BERNARD WARDLE GROUP LIMITED06 janv. 198206 janv. 1982
    BERNARD WARDLE AND COMPANY LIMITED06 nov. 194606 nov. 1946

    Quels sont les derniers comptes de BRANTHAM LAND GROUP LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le28 févr. 2007
    Date d'échéance des prochains comptes28 déc. 2007
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2005

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BRANTHAM LAND GROUP LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au27 déc. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation10 janv. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BRANTHAM LAND GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour BRANTHAM LAND GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 mars 2010

    6 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    5 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 déc. 2009

    8 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    5 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    6 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 juin 2009

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 déc. 2008

    7 pages4.68

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des affaires

    7 pages4.20

    legacy

    1 pages287

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages403a

    Comptes annuels établis au 31 août 2005

    12 pagesAA

    legacy

    5 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 août 2004

    12 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    Qui sont les dirigeants de BRANTHAM LAND GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COX, Malcolm Peter
    58 Burnham Drive
    Whetstone
    LE8 6HY Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    58 Burnham Drive
    Whetstone
    LE8 6HY Leicester
    Leicestershire
    BritishGeneral Manager105976490001
    COX, Malcolm Peter
    58 Burnham Drive
    Whetstone
    LE8 6HY Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    58 Burnham Drive
    Whetstone
    LE8 6HY Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishGeneral Manager105976490001
    O'NEILL, Derham Charles
    17a Hugh Mews
    SW1V 1QH London
    Administrateur
    17a Hugh Mews
    SW1V 1QH London
    United KingdomBritishConsultant57161700003
    BROWNE, Marcus Henderson
    The Willows 59 Needham Road
    IP14 2AL Stowmarket
    Suffolk
    Secrétaire
    The Willows 59 Needham Road
    IP14 2AL Stowmarket
    Suffolk
    BritishAdministration Manager85387100001
    HOAD, Geoffrey Douglas
    23 North Street
    CM6 1AZ Great Dunmow
    Essex
    Secrétaire
    23 North Street
    CM6 1AZ Great Dunmow
    Essex
    British48622020001
    SEVERN, John Philip
    Wychwood Chesapeake Close
    Chelmondiston
    IP9 1HH Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    Wychwood Chesapeake Close
    Chelmondiston
    IP9 1HH Ipswich
    Suffolk
    BritishCompany Director80671560001
    WILMAN, David John
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    British22174080001
    WILMAN, David John
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    British22174080001
    BOND, Michael Peter
    Barnrooden Farm
    Shuckburgh Road Priors Marston
    CV47 7RY Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    Barnrooden Farm
    Shuckburgh Road Priors Marston
    CV47 7RY Southam
    Warwickshire
    United KingdomBritishConsultant80816550001
    DEERING, Lorraine
    Blue Barns Cottage
    Harts Lane
    CO7 7QL Ardleigh
    Essex
    Administrateur
    Blue Barns Cottage
    Harts Lane
    CO7 7QL Ardleigh
    Essex
    BritishGroup Accountant89886380001
    EARP, John
    4 Bedford Road
    SS15 6PG Laindon
    Essex
    Administrateur
    4 Bedford Road
    SS15 6PG Laindon
    Essex
    BritishChartered Accountant67307010001
    LEES, Brian
    9b Ridge Avenue
    Marple
    SK6 7HJ Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    9b Ridge Avenue
    Marple
    SK6 7HJ Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director60016130001
    SEVERN, John Philip
    26 Henry Laver Court
    CO3 3AF Colchester
    Essex
    Administrateur
    26 Henry Laver Court
    CO3 3AF Colchester
    Essex
    BritishCompany Director80671560002
    TAYLOR, Brian Reginald
    The Manor
    Marten
    SN8 3SJ Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    The Manor
    Marten
    SN8 3SJ Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director2197890003
    WILMAN, David John
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    BritishCompany Director22174080001
    WRIGHT, David Charles
    2 Marennes Crescent
    CO7 0RX Brightlingsea
    Essex
    Administrateur
    2 Marennes Crescent
    CO7 0RX Brightlingsea
    Essex
    BritishCompany Director85449670001

    BRANTHAM LAND GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 janv. 2002
    Livré le 12 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) in any currency whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including land and premises at brantham,suffolk; sk 203799; property at earby,pendle,lancashire; la 863756; durbar mill,hereford rd,blackburn; la 393060; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,London as Security Trustee for Itself and Theother Finance Parties
    Transactions
    • 12 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture of even date between troyess PLC (the parent) edlaw PLC (the company) the companies listed in the schedule 1 of the debenture (the charging companies) and the chargee
    Créé le 27 avr. 2001
    Livré le 08 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the subordinated finance documents (as defined) on any account
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security deed of accession to a debenture dated 17 november 1999 (the "debenture deed"), as amended by a deed of amendment dated 26TH january 2000 and a deed of accession and amendment dated 15 march 2000
    Créé le 17 mars 2000
    Livré le 05 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities due or to become due from the company and each of the obligors to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture deed) in whatsoever manner
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage the key properties together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery .. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dlj Capital Funding Inc.as Security Agent on Behalf of Itself and Othersecured Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 05 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 12 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BRANTHAM LAND GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 déc. 2007Commencement of winding up
    25 juin 2010Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Bruce Alexander Mackay
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    practitioner
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Michael David Rollings
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    London
    Ec4m 7af
    practitioner
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    London
    Ec4m 7af
    Matthew Robert Haw
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    practitioner
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0