WALLIS'S CAYTON BAY HOLIDAY CAMP LIMITED

WALLIS'S CAYTON BAY HOLIDAY CAMP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWALLIS'S CAYTON BAY HOLIDAY CAMP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00424148
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WALLIS'S CAYTON BAY HOLIDAY CAMP LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe WALLIS'S CAYTON BAY HOLIDAY CAMP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WALLIS'S CAYTON BAY HOLIDAY CAMP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour WALLIS'S CAYTON BAY HOLIDAY CAMP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 févr. 2012

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 17 févr. 2012

    • Capital: GBP 14.48743
    6 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 16/02/2012
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Rank Nemo (Twenty-Six) Limited le 05 sept. 2011

    1 pagesCH04

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Frances Bingham le 01 mars 2010

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de WALLIS'S CAYTON BAY HOLIDAY CAMP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THE RANK ORGANISATION LIMITED
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    116576210002
    BINGHAM, Frances
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishSolicitor128838610001
    ADAMS, Charlotte
    10 Park Way
    HA4 8NY Ruislip
    Middlesex
    Secrétaire
    10 Park Way
    HA4 8NY Ruislip
    Middlesex
    British52017000001
    DUFFILL, Clare Marianne
    91a Crystal Palace Road
    SE22 9EY London
    Secrétaire
    91a Crystal Palace Road
    SE22 9EY London
    BritishChartered Secretary71005690004
    PATEL, Aurelia Azalea
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    Secrétaire
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    BritishCompany Secretariat Assistant108784710001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    British34191470001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Secrétaire
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002
    COLES, Pamela Mary
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary70326980002
    CORMICK, Charles Bruce Arthur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    Administrateur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    United KingdomBritishCompany Secretary17946190001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretariat Executive42996540002
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Administrateur
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    BritishCompany Secretary26244410001
    DUFFILL, Clare Marianne
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    Administrateur
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    BritishAssistant Company Secretary71005690005
    PATEL, Aurelia Azalea
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    Administrateur
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    BritishCompany Secretariat Assistant108784710001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant34191470001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Administrateur
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    BritishAssistant Secretary34048840002

    WALLIS'S CAYTON BAY HOLIDAY CAMP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed charge
    Créé le 22 mai 1989
    Livré le 24 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mecca leisure group PLC to samuel montagu & co. Limited as agent for itself and the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 29/12/87
    Brèves mentions
    F/H property comprising the wallis's cayton bay holiday centre, cayton, scarborough, north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transactions
    • 24 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 09 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge
    Créé le 13 janv. 1989
    Livré le 17 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 29/12/87
    Brèves mentions
    F/H - two semi detached bungalows k/a braemar mill lane, cayton, scarborough north yorkshire and 29 mill lane cayton. Title no's yk 612 and yk 621.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Security Agent and Trustee for the Banks.
    Transactions
    • 17 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 09 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge.
    Créé le 28 nov. 1988
    Livré le 09 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from mecca leisure group PLC to the chargee under the terms of the loan agreement dated 15/11/88.
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and rights & assets.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Security Agent and Trustee for the Banks.
    Transactions
    • 09 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    First supplemental trust deed
    Créé le 30 déc. 1987
    Livré le 15 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing all principal amounts of £20,000,000 11.5 percent debenture stock 2011 of mecca leisure group PLC and all other moneys due or to become due from mecca leisure group PLC and/or all or any other company named therein to alliance assurance company limited. Pursuant to the provisions of the principal deed dated 28.7.86 and this charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all the undertaking property and assets for the time being both present and future (including uncalled capital) of the company.
    Personnes ayant droit
    • Alliance Assurance Company Limited.
    Transactions
    • 15 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 09 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 30 déc. 1987
    Livré le 11 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing all moneys due or to become due from mecca leisure group PLC to samuel montagu & co. Limited as agent for itself and the chargees.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over all f/h & l/h property including all fittings fixtures fixed plant and machinery all debts and other sums, undertaking rights & assets.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    • Samuel Montagu & Co.
    • Charterhouse Bank Limited
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 janv. 1988Enregistrement d'une charge

    WALLIS'S CAYTON BAY HOLIDAY CAMP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2013Dissolved on
    24 févr. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0