WALTER AINSBURY & SON LIMITED

WALTER AINSBURY & SON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWALTER AINSBURY & SON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00424757
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WALTER AINSBURY & SON LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe WALTER AINSBURY & SON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WALTER AINSBURY & SON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour WALTER AINSBURY & SON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de 1 Minster Court London EC3R 7AA United Kingdom à 2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7PD le 14 juil. 2020

    1 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Antonios Erotocritou en tant que directeur le 01 août 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Diane Cougill en tant qu'administrateur le 01 août 2019

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN à 1 Minster Court London EC3R 7AA le 30 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Nomination de Dean Clarke en tant que secrétaire le 04 janv. 2019

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Geoffrey Costerton Gouriet en tant que secrétaire le 04 janv. 2019

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jacqueline Anne Gregory en tant que secrétaire le 03 août 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Geoffrey Costerton Gouriet en tant que secrétaire le 03 août 2018

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Antonios Erotocritou en tant qu'administrateur le 02 mars 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Stephen Mugge en tant que directeur le 02 mars 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    3 pagesAA

    Nomination de Mr David Christopher Ross en tant qu'administrateur le 20 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mrs Jacqueline Anne Gregory en tant que secrétaire le 20 déc. 2016

    2 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jennifer Owens en tant que secrétaire le 01 mars 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 janv. 2016

    État du capital au 15 janv. 2016

    • Capital: GBP 835
    SH01

    Qui sont les dirigeants de WALTER AINSBURY & SON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARKE, Dean
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    253940770001
    COUGILL, Diane
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Finance Officer158614590002
    ROSS, David Christopher
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandIrishDirector222326970001
    BRIDGES, Paul
    38 Ladywell Avenue
    EH12 7LH Edinburgh
    Secrétaire
    38 Ladywell Avenue
    EH12 7LH Edinburgh
    BritishIns Broker87366150002
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    British117669700002
    EDWARDS, Peter
    222 Newshaw Lane
    Hadfield
    SK14 8BD Hyde
    Cheshire
    Secrétaire
    222 Newshaw Lane
    Hadfield
    SK14 8BD Hyde
    Cheshire
    English32273160001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249086790001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    221962350001
    MINAY, Nigel Geoffrey
    1 Woodford Road
    SK12 1DY Poynton
    Cheshire
    Secrétaire
    1 Woodford Road
    SK12 1DY Poynton
    Cheshire
    BritishInsurance Broker89063280001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    183285060001
    WATSON, Catherine Mary
    15 Solway Close
    Clifton
    M27 6PR Manchester
    Greater Manchester
    Secrétaire
    15 Solway Close
    Clifton
    M27 6PR Manchester
    Greater Manchester
    BritishAccountant73319460001
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector125097020001
    BINGHAM, David
    11 Welbeck Road
    M28 2SL Worsley
    Manchester
    Administrateur
    11 Welbeck Road
    M28 2SL Worsley
    Manchester
    BritishInsurance Broker41761900001
    BRIDGES, Paul
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector87366150002
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Administrateur
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritishDirector134140540001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector171398800001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector149939610001
    CLIFFORD, Lee Christopher
    23 Clerwood View
    EH12 8PH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    23 Clerwood View
    EH12 8PH Edinburgh
    Midlothian
    BritishCompany Director46183980004
    EDWARDS, Peter
    222 Newshaw Lane
    Hadfield
    SK14 8BD Hyde
    Cheshire
    Administrateur
    222 Newshaw Lane
    Hadfield
    SK14 8BD Hyde
    Cheshire
    EnglishAccountant32273160001
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector170703910001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    United KingdomCypriotDeputy Cfo167795710001
    HALL, Rowland
    1 The Retreat
    Worsley
    M28 2BY Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    1 The Retreat
    Worsley
    M28 2BY Manchester
    Lancashire
    BritishInsurance Broker16234020001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector58444370003
    MINAY, Nigel Geoffrey
    1 Woodford Road
    SK12 1DY Poynton
    Cheshire
    Administrateur
    1 Woodford Road
    SK12 1DY Poynton
    Cheshire
    British89063280001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritishDirector162920630005
    PALMER, David John
    Flat 5 Abbots Court
    Abbots Close
    M33 2DB Sale
    Cheshire
    Administrateur
    Flat 5 Abbots Court
    Abbots Close
    M33 2DB Sale
    Cheshire
    United KingdomBritishInsurance Broker78284060001
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector113694470002
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector147194830001
    VANDEN BERG, Gudo Damiaan Maria
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomDutchInsurance Broker78599130001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WALTER AINSBURY & SON LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ainsbury (Insurance Brokers) Limited
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    England
    06 avr. 2016
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Cardiff
    Numéro d'enregistrement05821192
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WALTER AINSBURY & SON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 14 sept. 2010
    Livré le 18 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 18 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession
    Créé le 13 oct. 2009
    Livré le 22 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 22 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 07 nov. 2006
    Livré le 15 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 79 station road, swinton, manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 07 nov. 2006
    Livré le 15 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 75 and 77 station road, swinton, manchester t/no LA243987 and LA80033. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 07 nov. 2006
    Livré le 15 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 05 août 2002
    Livré le 07 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 22 nov. 1993
    Livré le 24 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h land and buildings k/as 75 station road pendlebury salford greater manchester.t/no.LA243987 the present or future goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 1993
    Livré le 07 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/as 73 station road swinton manchester M27 2BR the present or future goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 sept. 1993
    Livré le 07 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h land and buildings k/a 75 station road pendlebury salford greater manchester t/n LA243987 the present or future goodwill. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 juin 1985
    Livré le 04 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,000
    Brèves mentions
    77-79 station road, swinton, M27 2BR.
    Personnes ayant droit
    • The National and Provincial Building Society
    Transactions
    • 04 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1985
    Livré le 30 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land & property erected thereon and k/a 35 lovely lane warrington cheshire. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 12 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge by deposit of deed without instrument.
    Créé le 07 mars 1960
    Livré le 09 mars 1960
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc.
    Brèves mentions
    L/H (999 yrs. From 10.10.1898) land and dwellinghouse no. 79 station rd. Pendlebury, lancs.
    Personnes ayant droit
    • Williams Beacon's Bank LTD.
    Transactions
    • 09 mars 1960Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0