CRR REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCRR REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00425057
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CRR REALISATIONS LIMITED ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration

    Où se situe CRR REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ship Canal House 8th Floor
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CRR REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAFE ROUGE RESTAURANTS LIMITED16 mai 200616 mai 2006
    THE PELICAN GROUP LIMITED09 août 199009 août 1990
    L. HARRIS (HARELLA) PLC05 déc. 194605 déc. 1946

    Quels sont les derniers comptes de CRR REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 mai 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour CRR REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    37 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    36 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    4 pagesAM19

    Démission d'un administrateur

    4 pagesAM15

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    44 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    46 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    5 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    66 pagesAM10

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 004250570024

    11 pagesMR05

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 004250570022

    11 pagesMR05

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 004250570025

    11 pagesMR05

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 004250570023

    11 pagesMR05

    Changement d'adresse du siège social de 8th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WB à Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WU le 11 nov. 2020

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de James Forrester Spragg en tant que directeur le 08 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Adrian Rowland Walker en tant que directeur le 08 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed cafe rouge restaurants LIMITED\certificate issued on 15/10/20
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    9 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    5 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    99 pagesAM03

    Qui sont les dirigeants de CRR REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUXTON SMITH, Maria Rita
    83 Wordsworth Avenue
    MK16 8RH Newport Pagnell
    Bucks
    Secrétaire
    83 Wordsworth Avenue
    MK16 8RH Newport Pagnell
    Bucks
    British39442340002
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Secrétaire
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    237559770001
    FENTON, Nicola Jane
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    Secrétaire
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    British31440290005
    FRANKLIN, Robert Norman Carew
    147 Middleton Road
    E8 4LL London
    Secrétaire
    147 Middleton Road
    E8 4LL London
    British37258120002
    MANSIGANI, Mohan
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Secrétaire
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    British64318140001
    MORLEY, Harry Michael Charles
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    Secrétaire
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    British49107830002
    BEKAY SECRETARIES LIMITED
    Conduit House 24 Conduit Place
    W2 1EP London
    Secrétaire
    Conduit House 24 Conduit Place
    W2 1EP London
    56992480001
    BARBOUR, Niel Paterson
    Church View Barn
    Loversall
    DN11 9DF Doncaster
    Administrateur
    Church View Barn
    Loversall
    DN11 9DF Doncaster
    British71423490001
    COX, Robert John Barry
    11 Wellington Court
    116 Knightsbridge
    SW11 1HX London
    Administrateur
    11 Wellington Court
    116 Knightsbridge
    SW11 1HX London
    British12592800002
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Administrateur
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    CUSHING, Philip Edward
    Warren End
    Warren Cutting
    KT2 7HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    Warren End
    Warren Cutting
    KT2 7HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish69325760003
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Administrateur
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    EnglandBritish187907210001
    DERKACH, John
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Administrateur
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    United KingdomBritish113885080002
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    EARL, Robert Ian
    5217 Fairway Oaks Drive
    Windermere
    Florida
    Usa
    Administrateur
    5217 Fairway Oaks Drive
    Windermere
    Florida
    Usa
    British76625410001
    HARDY, George Barry Conyers
    21 Fallows Green
    AL5 4DH Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    21 Fallows Green
    AL5 4DH Harpenden
    Hertfordshire
    British38430001
    JOHNSON, Michael Andrew
    North End House
    Oakley Road
    SO51 0LQ Mottisfont
    Hampshire
    Administrateur
    North End House
    Oakley Road
    SO51 0LQ Mottisfont
    Hampshire
    United KingdomBritish98243170001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    31 Rosehill Road
    SW18 2NY London
    Administrateur
    31 Rosehill Road
    SW18 2NY London
    British47793260004
    MANSIGANI, Mohan
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Administrateur
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    EnglandBritish64318140002
    MANSIGANI, Mohan
    36 Copthall Drive
    Mill Hill
    NW7 2NB London
    Administrateur
    36 Copthall Drive
    Mill Hill
    NW7 2NB London
    United KingdomBritish64318140001
    MCGIVERN, James
    18 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AF Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    18 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AF Bedford
    Bedfordshire
    British48320550001
    MORLEY, Harry Michael Charles
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    Administrateur
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    British49107830002
    MYERS, Roger
    Flat 16 9/11 Belsize Grove
    NW3 4UU London
    Administrateur
    Flat 16 9/11 Belsize Grove
    NW3 4UU London
    British56413030001
    PARSONS, James
    East Heath Road
    NW3 1AL London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    East Heath Road
    NW3 1AL London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish98887110002
    RICHARDS, Stephen
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish187618040002
    ROSS, Lewis Ian
    64 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Administrateur
    64 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    United KingdomBritish8006590004
    SCOTT, Finlay Thomas Kennedy
    The Limes
    OX15 6NH Shenington
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Limes
    OX15 6NH Shenington
    Oxfordshire
    United KingdomBritish72912750001
    SIMPSON, Richard Barry
    Astra House
    53 Dallington Road
    NN5 7BW Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Astra House
    53 Dallington Road
    NN5 7BW Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish81507560001
    SPRAGG, James Forrester
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish127602840002
    THOMAS, David Malcolm
    The Paddocks 25 Charlwood Drive
    Oxshott
    KT22 0HB Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    The Paddocks 25 Charlwood Drive
    Oxshott
    KT22 0HB Leatherhead
    Surrey
    British10685860001
    TURNER, Graham
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish59209570004
    WALKER, Adrian Rowland
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish265227060001
    WARNER, Sophie Jane
    7 Melrose Terrace
    W6 7RL London
    Administrateur
    7 Melrose Terrace
    W6 7RL London
    EnglandBritish49748240001
    WILLIAMS, Gavin Laurence
    2 Greenwood Road
    KT7 0DY Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    2 Greenwood Road
    KT7 0DY Thames Ditton
    Surrey
    British54736710002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CRR REALISATIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04349917
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CRR REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 janv. 2020
    Livré le 16 janv. 2020
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transactions
    • 16 janv. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 15 août 2018
    Livré le 31 août 2018
    En cours
    Brève description
    The charged property (as defined under the supplemental debenture). For more details please refer to the supplemental debenture, the security agreement (as defined in the supplemental debenture) and the chargor's deed of accession thereto.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent
    Transactions
    • 31 août 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 15 août 2018
    Livré le 23 août 2018
    En cours
    Brève description
    None at the date of the charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 23 août 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 05 févr. 2016
    Livré le 15 févr. 2016
    En cours
    Brève description
    The security document enclosed with this form MR01 includes a fixed charge or a fixed security over land and intellectual property, including unit 11G, the waters edge, birmingham. For more details of the land and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 15 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 20 juil. 2015
    Livré le 07 août 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    "Cafe rouge (in arbic)" trademark, registration number 201683. please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 07 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 mai 2015
    Livré le 15 mai 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    UK trademarks abbaye and amalfi 2122804 and 2122810 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S.Bank Trustees Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 15 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 sept. 2014
    Livré le 03 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 03 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 26 nov. 2010
    Livré le 30 nov. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposited sum (as defined in the rent deposit deed).
    Personnes ayant droit
    • Network Rail Infrastructure Limited
    Transactions
    • 30 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Fixed and floating security document
    Créé le 25 juil. 2007
    Livré le 31 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right, title and interest in and to the assigned contracts all insurances and a fixed charge on all present and future real property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transactions
    • 31 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating security document
    Créé le 22 janv. 2007
    Livré le 26 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the assigned contracts, all insurances and a fixed charge present and future real property and other assets. Floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transactions
    • 26 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 26 july 2006 and
    Créé le 25 mai 2006
    Livré le 31 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In security of the secured obligations to barclays bank PLC as security trustee for security beneficiaries in terms of a senior facilities agreement and a mezzanine facility agreement
    Brèves mentions
    The tenants interest in the lease between capital and regional (braehead) limited, csc braehead leisure limited and the pelican group limited dated 7 april, 8 and 31 may, all dates 2006 in relation to subjects k/a unit 14 xscape development braehead glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 31 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 mai 2006
    Livré le 09 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All property,first fixed charge all other property,all licences,all computers,vehicles,office equipment and other equipment,the benefit of all contracts,licences and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC the "Security Agent"
    Transactions
    • 09 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed relating to a debenture dated 17 january 2005
    Créé le 16 mai 2006
    Livré le 20 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a outside seating area and 174-176 wharfside street salvage wharf commercial street birmingham, l/h property k/a unit 5 condor house st paul's churchyard london, l/h property k/a unit 37 upper floor level the met quarter liverpool. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 20 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed to a debenture
    Créé le 07 mars 2006
    Livré le 25 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 1 the printworks shudehill manchester. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 25 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 25 nov. 2005
    Livré le 30 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit G40B, lowry centre, salford. L/h property k/a units 3 and 5 longmarket, canterbury. L/h property k/a unit 1 derry's cross, plymouth. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC 'Security Agent'
    Transactions
    • 30 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession and amendment
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 10 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A grant of security over all security interests and disposistions and are created with a full title guarantee and are continuing security for payment of all of the secured obligations. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC ( the Security Agent)
    Transactions
    • 10 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 janv. 2005
    Livré le 29 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Properties k/a blackheath-16A, 18, 18A montpelier vale t/no TGL150289; bury st edmunds-59 abbeygate street t/no SK182434; cambridge-25/26 bridge street t/no CB187973. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 29 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 17 févr. 2003
    Livré le 19 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £16,156.25.
    Personnes ayant droit
    • Genco (Spil) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 31 mai 2002
    Livré le 11 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    20A winchester street basingstoke; unit 1 bishops wharf 39 and 49 parkgate road; 296/298 high street berkhamsted t/nos: HP536633 TGL104043 HD351012. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 25 avr. 1995
    Livré le 28 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage.
    Créé le 23 août 1993
    Livré le 06 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that leasehold property known as or being unit 209, second floor,whiteleys shopping centre, queensway,bayswater , london .W2. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Limited.
    Transactions
    • 06 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 mai 1992
    Livré le 03 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H- known as the basement, ground floor and first floor and second floor and roof or roofs of that part of the building k/a no.390 Kings road chelsea london SW3 (see 395 and contd sheets for full details ).
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Limited
    Transactions
    • 03 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of accession to a guarantee and camposite debenture
    Créé le 24 mai 1990
    Livré le 12 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the bridging facility dated 2/4/90 and main facility agreement dated 24/5/90 and/or the guarantee and debenture
    Brèves mentions
    (For full details of charge see form 395 ref M156). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • British & Commonwealth Merchant Bank PLC
    Transactions
    • 12 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 05 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Record priority mortgage debenture.
    Créé le 23 mars 1990
    Livré le 29 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    (See 395 ref M113 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Third Grosvenor Fund
    Transactions
    • 29 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 19 oct. 1989
    Livré le 24 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £900,000 under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All moneys from time to time held to the credit of the company by the bank on any current deposit and or account(s) which the bank may now and/or hereafter have with the bank and/or under any deposit receipt.
    Personnes ayant droit
    • United Overseas Bank of Geneva
    Transactions
    • 24 oct. 1989Enregistrement d'une charge

    CRR REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 juin 2014Date of meeting to approve CVA
    22 juil. 2016Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DateType
    02 juil. 2020Administration started
    28 juin 2023Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Catherine Williamson
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    practitioner
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Clare Kennedy
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Daniel Imison
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0