MAYER PARRY (BRENTFORD) LIMITED

MAYER PARRY (BRENTFORD) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMAYER PARRY (BRENTFORD) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00429015
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MAYER PARRY (BRENTFORD) LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe MAYER PARRY (BRENTFORD) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sirius House, Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MAYER PARRY (BRENTFORD) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PARRY (METAL MERCHANTS) LIMITED 04 févr. 194704 févr. 1947

    Quels sont les derniers comptes de MAYER PARRY (BRENTFORD) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour MAYER PARRY (BRENTFORD) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 mars 2011

    État du capital au 10 mars 2011

    • Capital: GBP 14,650
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Phillip Robert Sheppard le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Phillip Sheppard le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Neil Andrew Stinson le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de MAYER PARRY (BRENTFORD) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STINSON, Neil Andrew
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    British130992930001
    SHEPPARD, Christopher Phillip
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    EnglandBritishCompany Director151399580001
    SHEPPARD, Phillip Robert
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector6443270001
    ARMER, Peter Thomas
    16 Heysham Avenue
    Heysham
    LA3 2DH Morecambe
    Lancashire
    Secrétaire
    16 Heysham Avenue
    Heysham
    LA3 2DH Morecambe
    Lancashire
    British71912780003
    CALLAGHAN, Peter John
    Penn Oast Manor Lane
    Hollingbourne
    ME17 1UN Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    Penn Oast Manor Lane
    Hollingbourne
    ME17 1UN Maidstone
    Kent
    British25043970001
    HARPER, Derek David
    The Laurels
    14 Woolwich Road
    DA17 5EW Belvedere
    Kent
    Secrétaire
    The Laurels
    14 Woolwich Road
    DA17 5EW Belvedere
    Kent
    British45048870001
    HUGHES, Michael Blake
    209 Newcastle Road
    ST15 8LF Stone
    Staffordshire
    Secrétaire
    209 Newcastle Road
    ST15 8LF Stone
    Staffordshire
    BritishAccountant77731090003
    MAHER, Michael John
    7 Cae Eithin
    Lixwm
    CH8 8NB Holywell
    Clwyd
    Secrétaire
    7 Cae Eithin
    Lixwm
    CH8 8NB Holywell
    Clwyd
    BritishCompany Secretary110531730001
    WARREN, Nicholas
    15 Chaddock Lane
    Boothstown
    M28 1DB Worsley
    Secrétaire
    15 Chaddock Lane
    Boothstown
    M28 1DB Worsley
    British79704130002
    BUCKINGHAM, Andrew Oxborrow
    High Trees Clock Barn Lane
    Hydon Heath
    GU8 4A2 Godalming
    Surrey
    Administrateur
    High Trees Clock Barn Lane
    Hydon Heath
    GU8 4A2 Godalming
    Surrey
    BritishCompany Director55900660001
    CALLAGHAN, Peter John
    Penn Oast Manor Lane
    Hollingbourne
    ME17 1UN Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Penn Oast Manor Lane
    Hollingbourne
    ME17 1UN Maidstone
    Kent
    BritishCompany Director25043970001
    COOKSON, John Lomax
    6 Jameson Street
    W8 7SH London
    Administrateur
    6 Jameson Street
    W8 7SH London
    BritishCompany Director35205980002
    CROWE, Alan Michael
    4 Courtenay Avenue
    SM2 5ND Sutton
    Surrey
    Administrateur
    4 Courtenay Avenue
    SM2 5ND Sutton
    Surrey
    BritishCompany Director25043770003
    ILES, Colin David
    75 1 Myrtle Ave
    Edgewater
    New Jersey 07020
    Usa
    Administrateur
    75 1 Myrtle Ave
    Edgewater
    New Jersey 07020
    Usa
    BritishDirector48986000008
    ROBERTS, John Brian
    39 Holbrook Lane
    BR7 6PE Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    39 Holbrook Lane
    BR7 6PE Chislehurst
    Kent
    EnglandBritishCompany Director2733200001
    SHIRLEY, Martin John
    Burnham House
    The Street Bredgar
    ME9 8EX Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    Burnham House
    The Street Bredgar
    ME9 8EX Sittingbourne
    Kent
    BritishCompany Director105167270001

    MAYER PARRY (BRENTFORD) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission relating to a composite guarantee and debenture dated 2ND december 1993
    Créé le 05 janv. 2000
    Livré le 12 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 02 déc. 1993
    Livré le 15 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mayer Parry Recycling Limited
    Transactions
    • 15 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 02 déc. 1993
    Livré le 03 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 29 oct. 1993
    Livré le 03 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mayer parry recycling (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 03 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 janv. 1991
    Livré le 15 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 30 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental charge
    Créé le 19 sept. 1983
    Livré le 23 sept. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the charge supplemental to a mortgage debenture dated 25-2-1975
    Brèves mentions
    All bookdebts and other debts present & future.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 sept. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 02 févr. 1981
    Livré le 06 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land & premises in brentford town goods yard brentford hounslow london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 févr. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 1981
    Livré le 04 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H number one ballast quay greenwich. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0