SDI SPORTS (SC 2016) LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SDI SPORTS (SC 2016) LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00429750 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SDI SPORTS (SC 2016) LTD ?
| Adresse du siège social | Unit A Brook Park East NG20 8RY Shirebrook |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SDI SPORTS (SC 2016) LTD ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 avr. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour SDI SPORTS (SC 2016) LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2021 | 7 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2020 | 7 pages | AA | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2019 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas James Piper en tant que secrétaire le 01 juil. 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Cameron John Olsen en tant que secrétaire le 01 juil. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alastair Peter Orford Dick le 01 mai 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Alastair Peter Orford Dick en tant qu'administrateur le 14 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rachel Isabel Lilian Stockton en tant que directeur le 14 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de Dunlop Slazenger Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 déc. 2016 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2018 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 30 avr. 2016 | 7 pages | AAMD | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour | 7 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de David Michael Forsey en tant que directeur le 14 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Miss Rachel Isabel Lilian Stockton en tant qu'administrateur le 14 oct. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Wallace Ashley en tant que directeur le 14 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Adedotun Ademola Adegoke en tant qu'administrateur le 14 oct. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SDI SPORTS (SC 2016) LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPER, Thomas James | Secrétaire | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 260021810001 | |||||||
| ADEGOKE, Adedotun Ademola | Administrateur | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 203129860001 | |||||
| DICK, Alastair Peter Orford | Administrateur | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 256598390002 | |||||
| MARCHETTI, Carlo Antonio | Secrétaire | Glenwood Woodland Rise TN15 0HZ Sevenoaks Kent | British | 1229580001 | ||||||
| MELLORS, Robert Frank | Secrétaire | The Warrener Warren Row RG10 8QS Reading Berkshire | British | 30104540002 | ||||||
| MOODIE, Gordon Murray | Secrétaire | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | 66078560001 | ||||||
| OLSEN, Cameron John | Secrétaire | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 183494020001 | |||||||
| RITCHIE, Alistair John, Sol | Secrétaire | Waterman's Lodge 15 Beales Lane KT13 8JS Weybridge Surrey | British | 6417760002 | ||||||
| SIMPSON, Brian Charles | Secrétaire | 15 Langham Way RG10 8AX Wargrave Berkshire | British | 47141350001 | ||||||
| TYLEE-BIRDSALL, Rebecca Louise | Secrétaire | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | British | 131967270001 | ||||||
| INVENSYS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London | 75491680001 | |||||||
| AINSLEY, Stanley | Administrateur | Ash Tree Cottage Maidensgrove RG9 6EZ Henley On Thames Oxfordshire | British | 59267330001 | ||||||
| ASHLEY, Michael James Wallace | Administrateur | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British | 95500210002 | |||||
| AUSTEN, Patrick George | Administrateur | 14 Chantry View Road GU1 3XR Guildford Surrey | British | 55015730001 | ||||||
| BROWN, Robert Casson | Administrateur | 38 Newlands Avenue Melton Park NE3 5PX Newcastle Upon Tyne | British | 6343100001 | ||||||
| BROWN, Robert Casson | Administrateur | 38 Newlands Avenue Melton Park NE3 5PX Newcastle Upon Tyne | British | 6343100001 | ||||||
| FORSEY, David Michael | Administrateur | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British | 147207580002 | |||||
| JACOBS, David Michael | Administrateur | Riverside House Hall Cottages Lodden Drive RG10 8ND Reading Berkshire | British | 47141160001 | ||||||
| JENKINS, Brian John | Administrateur | 27 Fort Road GU1 3TE Guildford Surrey | England | British | 12010260001 | |||||
| LOVELL, Alan Charles | Administrateur | The Palace House Bishops Lane SO32 1DP Bishops Waltham Hampshire | England | British | 149625410001 | |||||
| MARCHETTI, Carlo Antonio | Administrateur | Glenwood Woodland Rise TN15 0HZ Sevenoaks Kent | British | 1229580001 | ||||||
| MARNOCH, Alasdair, Mr. | Administrateur | Bramble Bottom Wedmans Lane RG27 9BX Rotherwick Hampshire | England | British | 216655900001 | |||||
| MELLORS, Robert Frank | Administrateur | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 30104540005 | |||||
| MOODIE, Gordon Murray | Administrateur | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | 66078560001 | ||||||
| PARNELL, Philip John | Administrateur | The Old Bell House The Common HP10 8LQ Penn Buckinghamshire | England | British | 57485400001 | |||||
| PETERS, Andrew Robert Gerald, 151298 | Administrateur | 1 Josephine Avenue KT20 7AB Lower Kingswood Surrey | British | 56810170001 | ||||||
| RONNIE, Christopher | Administrateur | 18 Macclesfield Road SK9 2AA Wilmslow Cheshire | British | 79360390001 | ||||||
| STOCKTON, Rachel Isabel Lilian | Administrateur | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 245592990001 | |||||
| THOM, James Demmink | Administrateur | Tollgate Cottage Turners Hill Road RH10 4HG Crawley Down West Sussex | British | 38683120002 | ||||||
| WILLIAMS, Stanley Killa | Administrateur | White Raven Park Lane KT21 1EU Ashtead Surrey | England | British | 34401400001 | |||||
| WILLIAMS, Stanley Killa | Administrateur | White Raven Park Lane KT21 1EU Ashtead Surrey | England | British | 34401400001 | |||||
| WYCHERLEY, Peter | Administrateur | 394 Barnsley Road Sandal WF2 6BW Wakefield West Yorkshire | British | 130910001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SDI SPORTS (SC 2016) LTD ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slazenger Carlton (Holdings) Limited | 16 déc. 2016 | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Dunlop Slazenger Group Limited | 06 avr. 2016 | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SDI SPORTS (SC 2016) LTD a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Créé le 04 avr. 1996 Livré le 19 avr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the financing documents (as defined in the charge) and all monies due or to become due from pixelframe limited (now renamed dunlop slazenger group limited) (newco) to any vendor note creditor (as defined in the inter-creditor deed) under or in connection with the vendor a note (as therein defined) including the guarantee liabilities of the company to pay all monies due to any of the secured parties by any company within the group (as defined in the credit agreement) under or pursuant to any of the financing documents and the vendor a note | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trade marks and patents charge | Créé le 04 avr. 1996 Livré le 19 avr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the financing documents (as defined in the charge) and all monies due or to become due from pixelframe limited (now renamed dunlop slazenger group limited) (newco) to any vendor note creditor (as defined in the inter-creditor deed) under or in connection with the vendor a note (as therein defined) including the guarantee liabilities of the company to pay all monies due to any of the secured parties by any company within the group (as defined in the credit agreement) under or pursuant to any of the financing documents and the vendor a note | |
Brèves mentions All the trade marks set out in schedule 1 of the deed and form 395 together with all goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 mai 1984 Livré le 06 juin 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees on any account whatsoever | |
Brèves mentions All f/h & l/h property with all fixtures thereon undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. For further details see doc M102. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0