INFORMA EVENTS GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INFORMA EVENTS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00435820 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INFORMA EVENTS GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | 5 Howick Place SW1P 1WG London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INFORMA EVENTS GROUP LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INFORMA EVENTS GROUP LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mars 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 mars 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mars 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour INFORMA EVENTS GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2026 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Ascential Financing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 oct. 2025 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed ascential group LIMITED\certificate issued on 23/10/25 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2nd Floor, 81-87 High Holborn London WC1V 6DF England à 5 Howick Place London SW1P 1WG le 22 oct. 2025 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2024 | 24 pages | AA | ||||||||||
legacy | 240 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Amanda Jane Gradden en tant que directeur le 28 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Owain Thomas en tant que directeur le 28 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Informa Cosec Limited en tant que secrétaire le 01 févr. 2025 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Naomi Howden en tant que secrétaire le 01 févr. 2025 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Robert Bane en tant qu'administrateur le 01 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Owen Richard O'hagan en tant qu'administrateur le 01 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Nicholas Michael Perkins en tant qu'administrateur le 01 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 34 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Louise Meads en tant que secrétaire le 30 avr. 2024 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Ascential Financing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 mars 2024 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 33 Kingsway London WC2B 6UF United Kingdom à 2nd Floor, 81-87 High Holborn London WC1V 6DF le 26 mars 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 34 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Duncan Anthony Painter en tant que directeur le 02 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Philip Owain Thomas en tant qu'administrateur le 02 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 29 juin 2023
| 4 pages | RP04SH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INFORMA EVENTS GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMA COSEC LIMITED | Secrétaire | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom |
| 279172060001 | ||||||||||
| BANE, Simon Robert | Administrateur | 5 Howick Place SW1P 1WG London Informa Plc United Kingdom | England | British | 180051020003 | |||||||||
| O'HAGAN, Owen Richard | Administrateur | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 332357970001 | |||||||||
| PERKINS, Nicholas Michael | Administrateur | 5 Howick Place SW1P 1WG London Informa Plc United Kingdom | England | British | 66598870001 | |||||||||
| ELSDON, Kate | Secrétaire | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | 107227940002 | ||||||||||
| FOLLAND, Nicholas James | Secrétaire | Strethall House Strethall CB11 4XJ Saffron Walden Essex | British | 73711450003 | ||||||||||
| FREEMAN, Susanna Elizabeth Genevieve | Secrétaire | 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | 173131360001 | |||||||||||
| GRIFFITHS, Ian Ward | Secrétaire | The Gate House 1 Rhymers Gate Wyton PE28 2JR Huntingdon | British | 99547790001 | ||||||||||
| HAY, Helen Frances | Secrétaire | MK43 7BB Odell The Old Stable Yard Beds | 146427030001 | |||||||||||
| HOWDEN, Naomi | Secrétaire | 81-87 High Holborn WC1V 6DF London 2nd Floor, England | 288669190001 | |||||||||||
| LOOI, Shanny | Secrétaire | 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | British | 129906110001 | ||||||||||
| MEADS, Louise | Secrétaire | 81-87 High Holborn WC1V 6DF London 2nd Floor, England | 224385810001 | |||||||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secrétaire | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||||||
| ARCULUS, Thomas David Guy | Administrateur | Flat 193 County Hall North Block 1a Belvedere Road SE1 7GH London | British | 80344070001 | ||||||||||
| BHAKTA-JONES, Nilema | Administrateur | 7b Wolseley Road N8 8RR London | United Kingdom | British | 124888590001 | |||||||||
| BOASE, Martin | Administrateur | 27 St Leonards Terrace SW3 4QG London | United Kingdom | British | 1460150003 | |||||||||
| BROADBENT, Adam Humphrey Charles | Administrateur | 4 Dynevor Road TW10 6PF Richmond Surrey | United Kingdom | British | 27788780001 | |||||||||
| CARTER, Derek Raymond Anthony | Administrateur | Pinewych Vigo Road Fairseat TN15 7LR Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 29959930002 | |||||||||
| CATHCART, William Alun | Administrateur | 89 Blandford Street W1U 8AF London | British | 9490580009 | ||||||||||
| CLIFTON, Rita Ann | Administrateur | Woodend Farmhouse Woodend SL7 2HW Medmenham Buckinghamshire | England | British | 150443010001 | |||||||||
| COLE, Christopher Michael | Administrateur | Lucas Avenue HA2 9JU Harrow 30 Middlesex England | United Kingdom | British | 133510510001 | |||||||||
| COOKE, Patrick Joseph Dominic | Administrateur | 18-20 Brincliffe Crescent S11 9AW Sheffield South Yorkshire | British | 41430120001 | ||||||||||
| DANON, Pierre | Administrateur | Apartment J 42 Eaton Square SW1W 9DB London | French | 97576680001 | ||||||||||
| ELLIOT, Richard Emmerson | Administrateur | Orchard House 2 Richardson Close, Mill Drove PE10 9YN Bourne Lincolnshire | United Kingdom | British | 40591070005 | |||||||||
| GESTETNER, Emily Henrietta | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | 138386390001 | |||||||||
| GILBERTSON, David Stuart | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | 10921820004 | |||||||||
| GRADDEN, Amanda Jane | Administrateur | 81-87 High Holborn WC1V 6DF London 2nd Floor, England | England | British | 77425910003 | |||||||||
| GRIFFITHS, Ian Ward | Administrateur | The Gate House 1 Rhymers Gate Wyton PE28 2JR Huntingdon | United Kingdom | British | 99547790001 | |||||||||
| GRIGSON, David John | Administrateur | Bainton Farmhouse Tallington Road, Bainton PE9 3AF Stamford Lincolnshire | British | 71511500001 | ||||||||||
| GULLIVER, John Keith | Administrateur | 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | United Kingdom | British | 170112360001 | |||||||||
| HAND, Kevin Lawrence | Administrateur | 20 Ormonde Gate SW3 4EX London | British | 5022630006 | ||||||||||
| HARRISON, Andrew | Administrateur | Wimbushes Ragged Hall Lane AL2 3NW St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 9006050004 | |||||||||
| HINDLEY, Martyn John | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | 134332760002 | |||||||||
| HOSKYNS, John Austin Hungerford Leigh, Sir | Administrateur | 83 Clapham Common West Side SW4 9AY London | British | 37474760002 | ||||||||||
| HOWELL, Jonathan Anton George | Administrateur | 4 Crescent Grove Clapham SW4 7AH London | British | 63127420002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INFORMA EVENTS GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informa Events Financing Limited | 06 avr. 2016 | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0