GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED

GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00437299
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED ?

    Adresse du siège social
    KPMG
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 3000 Hillswood Drive Hillswood Business Park Chertsey Surrey KT16 0RS le 27 avr. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 avr. 2012

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de Watchmoor Point Watchmoor Road Camberley Surrey GU15 3EX le 03 févr. 2012

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Stuart David Mccaslin en tant que directeur le 31 août 2011

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    9 pagesAA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    27 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Premium Aircraft Interiors Group Limited en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Maureen Hodgkinson en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juil. 2011

    État du capital au 11 juil. 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Cessation de la nomination de Neil Rodgers en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Carter en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Premium Aircraft Interiors Group Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Seton House International Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    9 pagesAA

    État du capital au 27 juil. 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Re interim dividend 30/06/2010
    RES14

    Consolidation des actions au 30 juin 2010

    4 pagesSH02

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Qui sont les dirigeants de GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HODGKINSON, Maureen
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    Secrétaire
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    British161783250001
    DEVANNEY, William Gerard
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    Administrateur
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    United KingdomBritish,Irish87628900001
    PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Secrétaire
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3929802
    154770740001
    SETON HOUSE INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement579928
    109290008
    CANNON, Thomas Charles
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    British2756000001
    CARTER, Paul Dennis
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    EnglandBritish123148720001
    CARTER, Paul Dennis
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish123148720001
    DAWSON, Anthony David
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    Administrateur
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish89317200001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish24487000002
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    Administrateur
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    British58979090001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish141893610001
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    British34653220001
    MCCASLIN, Stuart David, Mr
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    United KingdomBritish1824650002
    MCCOMASKY, James Anthony
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish148271070001
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Administrateur
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritish123487130001
    RODGERS, Neil Anthony
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    EnglandBritish136538310002
    THORNE, Raymond
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    British2756010001
    TURNBULL, Peter
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    British41591930001

    GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 oct. 2008
    Livré le 07 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 07 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2005
    Livré le 06 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Legal mortgage all f/h and l/h property,first fixed charge all the subsidiary shares and investments,all other interests in any f/h or l/h property,the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property,all proceeds of sale derived therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security accession deed
    Créé le 08 févr. 2002
    Livré le 19 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies or liabilities due or to become due from any charging company or any other obligor (as defined) to the chargee as security trustee for itself and the other secured parties (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    Transactions
    • 19 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 21 déc. 1984
    Livré le 10 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts and other debts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1985Enregistrement d'une charge

    GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 nov. 2012Dissolved on
    19 avr. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0