JAMES STREET WEST (2001) LIMITED

JAMES STREET WEST (2001) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJAMES STREET WEST (2001) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00439957
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JAMES STREET WEST (2001) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe JAMES STREET WEST (2001) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Johnsons Group Limited
    James St West
    BA1 2BU Bath
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JAMES STREET WEST (2001) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PITKIN GUIDES LIMITED01 mai 199601 mai 1996
    PITKIN PICTORIALS LIMITED30 juil. 194730 juil. 1947

    Quels sont les derniers comptes de JAMES STREET WEST (2001) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour JAMES STREET WEST (2001) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A251E5OA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 août 2012

    État du capital au 06 août 2012

    • Capital: GBP 10,000
    SH01
    X1EQXG7E

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Claire Louise Scoble le 15 nov. 2011

    1 pagesCH03
    X1EQXG76

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    6 pagesAA
    A15QIEK9

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    XISWRWSI

    Modification des coordonnées du secrétaire Claire Louise Scoble le 28 juil. 2011

    2 pagesCH03
    XISWQWSH

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    6 pagesAA
    AYJZKSDF

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    XWT2CMH3

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    6 pagesAA
    ARGA3IJV

    legacy

    3 pages363a
    X2D2SCBT

    Comptes établis au 30 juin 2008

    6 pagesAA
    AY6YC9EB

    legacy

    3 pages363a
    XJ2GX21Y

    Comptes établis au 30 juin 2007

    6 pagesAA
    AOCLMZAQ

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 30 juin 2006

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 30 juin 2005

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 30 juin 2004

    6 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 30 juin 2003

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de JAMES STREET WEST (2001) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SCOBLE, Claire Louise
    The Johnsons Group Limited
    James St West
    BA1 2BU Bath
    Secrétaire
    The Johnsons Group Limited
    James St West
    BA1 2BU Bath
    BritishDirector97068300001
    PEARCE, Malcolm Victor Lawrence
    Lady Farm
    Chelwood
    BS39 4NN Bristol
    Administrateur
    Lady Farm
    Chelwood
    BS39 4NN Bristol
    EnglandBritishChairman5325360001
    RADCLIFFE, Willoughby Mark St John
    14 The Orchard
    Bedford Park
    W4 1JX London
    Secrétaire
    14 The Orchard
    Bedford Park
    W4 1JX London
    British32447610001
    SMITH, Stuart Raymond
    Penn Hill Farmhouse
    High Street Weston
    BA1 4DB Bath
    Avon
    Secrétaire
    Penn Hill Farmhouse
    High Street Weston
    BA1 4DB Bath
    Avon
    British2734740001
    RIB SECRETARIES LIMITED
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    Secrétaire
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    32438680003
    BOVILL, Michael Antony
    Long Acre
    Chalk Lane, East Horsley
    KT24 6TJ Leatherhead
    Administrateur
    Long Acre
    Chalk Lane, East Horsley
    KT24 6TJ Leatherhead
    United KingdomBritishCompany Director112204460001
    CHARKIN, Richard
    10 Thackeray Court
    Elystan Place
    SW3 3JZ London
    Administrateur
    10 Thackeray Court
    Elystan Place
    SW3 3JZ London
    BritishExecutive Director22140670003
    CHEESEMAN, Peter Ernest
    New House Farm
    Eastling
    ME13 0BN Faversham
    Kent
    Administrateur
    New House Farm
    Eastling
    ME13 0BN Faversham
    Kent
    EnglandBritishCommercial Director92554630001
    CORSIE, Ian
    11 Winchester Road
    SP10 2EG Andover
    Hampshire
    Administrateur
    11 Winchester Road
    SP10 2EG Andover
    Hampshire
    BritishPublisher65978500001
    FREEMAN, Derek Keith
    The Plantation Village Road
    Bromham
    MK43 8LL Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Plantation Village Road
    Bromham
    MK43 8LL Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritishCompany Director16386900001
    RADCLIFFE, Willoughby Mark St John
    14 The Orchard
    Bedford Park
    W4 1JX London
    Administrateur
    14 The Orchard
    Bedford Park
    W4 1JX London
    EnglandBritishCompany Secretary32447610001
    TREDWIN, Richard Nicholas
    Brooklands 70 Naishes Avenue
    Peasedown St John
    BA2 8TW Bath
    Avon
    Administrateur
    Brooklands 70 Naishes Avenue
    Peasedown St John
    BA2 8TW Bath
    Avon
    BritishFinancial Director56821450001
    RIB DIRECTORS 1 LIMITED
    Michelin House
    81 Fulham Road
    SW3 6RB London
    Administrateur
    Michelin House
    81 Fulham Road
    SW3 6RB London
    32501660001
    RIB DIRECTORS 2 LIMITED
    Michelin House
    81 Fulham Road
    SW3 6RB London
    Administrateur
    Michelin House
    81 Fulham Road
    SW3 6RB London
    32499130001

    JAMES STREET WEST (2001) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee & debenture
    Créé le 21 déc. 1984
    Livré le 04 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • H & H Factory Limited
    Transactions
    • 04 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Composite guarantee & debenture
    Créé le 21 déc. 1984
    Livré le 04 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • First National Bank
    Transactions
    • 04 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 17 juil. 1984
    Livré le 03 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 août 1984Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 29 janv. 1981
    Livré le 09 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts & other debts present & future due airng or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 1981Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 03 juin 1980
    Livré le 13 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over (see doc M101). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 juin 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0