JAMES STREET WEST (2001) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | JAMES STREET WEST (2001) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00439957 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe JAMES STREET WEST (2001) LIMITED ?
Adresse du siège social | The Johnsons Group Limited James St West BA1 2BU Bath |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de JAMES STREET WEST (2001) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour JAMES STREET WEST (2001) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Claire Louise Scoble le 15 nov. 2011 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Claire Louise Scoble le 28 juil. 2011 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2008 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2007 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2006 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2005 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2004 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2003 | 5 pages | AA |
Qui sont les dirigeants de JAMES STREET WEST (2001) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOBLE, Claire Louise | Secrétaire | The Johnsons Group Limited James St West BA1 2BU Bath | British | Director | 97068300001 | |||||
PEARCE, Malcolm Victor Lawrence | Administrateur | Lady Farm Chelwood BS39 4NN Bristol | England | British | Chairman | 5325360001 | ||||
RADCLIFFE, Willoughby Mark St John | Secrétaire | 14 The Orchard Bedford Park W4 1JX London | British | 32447610001 | ||||||
SMITH, Stuart Raymond | Secrétaire | Penn Hill Farmhouse High Street Weston BA1 4DB Bath Avon | British | 2734740001 | ||||||
RIB SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 1-3 Strand WC2N 5JR London | 32438680003 | |||||||
BOVILL, Michael Antony | Administrateur | Long Acre Chalk Lane, East Horsley KT24 6TJ Leatherhead | United Kingdom | British | Company Director | 112204460001 | ||||
CHARKIN, Richard | Administrateur | 10 Thackeray Court Elystan Place SW3 3JZ London | British | Executive Director | 22140670003 | |||||
CHEESEMAN, Peter Ernest | Administrateur | New House Farm Eastling ME13 0BN Faversham Kent | England | British | Commercial Director | 92554630001 | ||||
CORSIE, Ian | Administrateur | 11 Winchester Road SP10 2EG Andover Hampshire | British | Publisher | 65978500001 | |||||
FREEMAN, Derek Keith | Administrateur | The Plantation Village Road Bromham MK43 8LL Bedford Bedfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 16386900001 | ||||
RADCLIFFE, Willoughby Mark St John | Administrateur | 14 The Orchard Bedford Park W4 1JX London | England | British | Company Secretary | 32447610001 | ||||
TREDWIN, Richard Nicholas | Administrateur | Brooklands 70 Naishes Avenue Peasedown St John BA2 8TW Bath Avon | British | Financial Director | 56821450001 | |||||
RIB DIRECTORS 1 LIMITED | Administrateur | Michelin House 81 Fulham Road SW3 6RB London | 32501660001 | |||||||
RIB DIRECTORS 2 LIMITED | Administrateur | Michelin House 81 Fulham Road SW3 6RB London | 32499130001 |
JAMES STREET WEST (2001) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee & debenture | Créé le 21 déc. 1984 Livré le 04 janv. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee & debenture | Créé le 21 déc. 1984 Livré le 04 janv. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 17 juil. 1984 Livré le 03 août 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 29 janv. 1981 Livré le 09 févr. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over all book debts & other debts present & future due airng or incurred to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 03 juin 1980 Livré le 13 juin 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Floating charge over (see doc M101). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0