EASTFIELD NO.30 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEASTFIELD NO.30 LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00444966
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EASTFIELD NO.30 LIMITED ?

    • fabrication de machines pour l'exploitation minière (28921) / Industries manufacturières

    Où se situe EASTFIELD NO.30 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Axon Commerce Road
    Lynch Wood
    PE2 6LR Peterborough
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EASTFIELD NO.30 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    O & K ORENSTEIN & KOPPEL LIMITED11 nov. 194711 nov. 1947

    Quels sont les derniers comptes de EASTFIELD NO.30 LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2010
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour EASTFIELD NO.30 LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au04 oct. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation18 oct. 2016
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EASTFIELD NO.30 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour EASTFIELD NO.30 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    5 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    Nomination de Mr Michael David Cleaver en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Laurence Dobney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * Halco Drilling International Limited West Lane Southowram Halifax West Yorkshire HX3 9TW* le 12 mars 2012

    1 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Certificat de changement de nom

    Company name changed o & k orenstein & koppel LIMITED\certificate issued on 29/02/12
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name29 févr. 2012

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name29 févr. 2012

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 oct. 2011

    État du capital au 26 oct. 2011

    • Capital: GBP 27,753,000
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Timothy Sullivan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Craig Mackus en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Cobbetts (Secretarial) Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Laurence Michael Dobney en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Janette Margaret Nicholls en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Nomination de Mr Nigel John Burroughs en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Eric Cohen en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Phillip Widman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Eric Cohen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Cobbetts (Secretarial) Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Howes Percival 252 Upper Third Street Graftan Gate East Milton Keynes MK9 1DZ* le 11 mai 2010

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Timothy William Sullivan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Craig Richard Mackus en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de EASTFIELD NO.30 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NICHOLLS, Janette Margaret
    Commerce Road
    Lynch Wood
    PE2 6LR Peterborough
    2 Axon
    Secrétaire
    Commerce Road
    Lynch Wood
    PE2 6LR Peterborough
    2 Axon
    163729270001
    BURROUGHS, Nigel John
    Commerce Road
    Lynch Wood
    PE2 6LR Peterborough
    2 Axon
    Administrateur
    Commerce Road
    Lynch Wood
    PE2 6LR Peterborough
    2 Axon
    EnglandBritishTax Accountant61945760002
    CLEAVER, Michael David
    Eastfield
    PE1 5NA Peterborough
    Shared Services
    England
    Administrateur
    Eastfield
    PE1 5NA Peterborough
    Shared Services
    England
    EnglandBritishAccountant174251010001
    BAILLIE, Fergus Cumming
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    Secrétaire
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    BritishCompany Director924340002
    COHEN, Eric I
    Turtleback Lane
    Westport
    Connecticut
    3
    Ct06880
    Usa
    Secrétaire
    Turtleback Lane
    Westport
    Connecticut
    3
    Ct06880
    Usa
    American65582430009
    VAUGHAN, Ian Charles
    16 Sandford Way
    Dunchurch
    CV22 6NB Rugby
    Warwickshire
    Secrétaire
    16 Sandford Way
    Dunchurch
    CV22 6NB Rugby
    Warwickshire
    British72203540001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    West Lane
    Southowram
    HX3 9TW Halifax
    Halco Drilling International Limited
    West Yorkshire
    Secrétaire
    West Lane
    Southowram
    HX3 9TW Halifax
    Halco Drilling International Limited
    West Yorkshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02787585
    151136500001
    BAILLIE, Fergus Cumming
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    BritishCompany Director924340002
    BROCK, Brian
    Greenburn Baxter Wood
    Cross Hills
    BD20 8BB Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Greenburn Baxter Wood
    Cross Hills
    BD20 8BB Keighley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director6446900001
    COHEN, Eric
    3 Turtleback Lane
    IRISH Westport
    Ct 06880
    Usa
    Administrateur
    3 Turtleback Lane
    IRISH Westport
    Ct 06880
    Usa
    United StatesAmericanLawyer65582430001
    DOBNEY, Laurence Michael
    Commerce Road
    Lynch Wood
    PE2 6LR Peterborough
    2 Axon
    Administrateur
    Commerce Road
    Lynch Wood
    PE2 6LR Peterborough
    2 Axon
    United KingdomEnglishChartered Accountant125805020001
    GOLUCKE, Karl Friedrich, Dr
    Eichenstrasse 13
    5804 Herdecke
    Germany
    Administrateur
    Eichenstrasse 13
    5804 Herdecke
    Germany
    GermanCompany Director17073880001
    KAMPMANN, Dieter
    Resingstr 12
    46 Dortmund 30 4600
    Deutschland
    Administrateur
    Resingstr 12
    46 Dortmund 30 4600
    Deutschland
    GermanCompany Director34712230001
    KERSTING, Friedrich, Dr
    Rubin Strasse 34
    4600 Dortmund 30
    Germany
    Administrateur
    Rubin Strasse 34
    4600 Dortmund 30
    Germany
    GermanCompany Director17073890001
    KREIGENFELD, Friedrich Wilhelm Heinrich
    2 Cloister Crofts
    CV32 6QQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    2 Cloister Crofts
    CV32 6QQ Leamington Spa
    Warwickshire
    GermanCompany Director72339530001
    MACKUS, Craig Richard
    West Lane
    Southowram
    HX3 9TW Halifax
    Halco Drilling International Limited
    West Yorkshire
    Administrateur
    West Lane
    Southowram
    HX3 9TW Halifax
    Halco Drilling International Limited
    West Yorkshire
    UsaUnited States Of AmericaChief Financial Officer151124020001
    MOMBERG, Michael, Dr
    Zeppelinstr 26
    58313 Herdecke
    Germany
    Administrateur
    Zeppelinstr 26
    58313 Herdecke
    Germany
    GermanCompany Director56760560002
    ROBERTSON, Colin
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    Administrateur
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    BritishManaging Director77076440001
    SCHMIEDEKNECHT, Knut
    Kampehenstr 4
    4600 Dortmund 1
    Germany
    Administrateur
    Kampehenstr 4
    4600 Dortmund 1
    Germany
    German17073900001
    STARKE, Wolfgang Peter
    Hue Strasse 106
    46 Dortmund 4600
    Germany
    Administrateur
    Hue Strasse 106
    46 Dortmund 4600
    Germany
    GermanCompany Director34712220001
    SULLIVAN, Timothy William
    West Lane
    Southowram
    HX3 9TW Halifax
    Halco Drilling International Limited
    West Yorkshire
    Administrateur
    West Lane
    Southowram
    HX3 9TW Halifax
    Halco Drilling International Limited
    West Yorkshire
    UsaUnited States Of AmericaChief Executive Officer151122760001
    WIDMAN, Phillip Charles
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    Administrateur
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    UsaAmericanDirector144249950001
    WILFORD, John
    28 The Leys
    Welford
    NN6 6HS Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    28 The Leys
    Welford
    NN6 6HS Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector5014270001

    EASTFIELD NO.30 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment
    Créé le 13 mars 1997
    Livré le 22 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a leasing agreement
    Brèves mentions
    All rights title and interest (present and future) in or to :- the contracts the contract earnings the insurance all moneys payable in respect of a total loss and all book & other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commercial Vehicle Management Limited
    Transactions
    • 22 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment
    Créé le 09 août 1996
    Livré le 20 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of an agreement numbered 41/187/23/500082 and/or this assignment
    Brèves mentions
    All monies due and to become due to the company under sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nws 7 Limited
    Transactions
    • 20 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment
    Créé le 09 août 1996
    Livré le 20 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of an agreement numbered 41/187/23/500082 and / or this assignment
    Brèves mentions
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nws 7 Limited
    Transactions
    • 20 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge on sub-hires
    Créé le 29 févr. 1996
    Livré le 08 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Existing sub-leases. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Asset Finance Limited
    Transactions
    • 08 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment by way of security and charge of sub-lease
    Créé le 28 févr. 1996
    Livré le 20 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge and the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    All of the present and future right title and interest in and to the charged property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sanwa Business Credit (UK) Limited
    Transactions
    • 20 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Master agreement
    Créé le 08 févr. 1996
    Livré le 13 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this master agreement
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in the sub-hire agreements described in the supplementary schedules from time to time entered into pursuant to the master agreement and in all ancillary contracts relating thereto ans all (if any) the rights of the company to acquire title in the goods forming the subject matter thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Leasing Limited
    Transactions
    • 13 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A supplemental deed creating fixed charge
    Créé le 31 juil. 1995
    Livré le 01 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire agreements or under any interim finance documents, hire agreements and any other agreements pursuant to the terms of a charge dated 28TH february 1995
    Brèves mentions
    All rights title benefits and interests of the company whether present future actual contingent proprietary contractual or otherwise under or arising out of or in respect of the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Humberclyde Industrial Finance Limited
    Transactions
    • 01 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Account assignment
    Créé le 26 juil. 1995
    Livré le 28 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease agreements (as defined in the assignment)
    Brèves mentions
    All monies from time to time credited to and for the time being standing to the credit of the cash collateral account together with all interest from time to time accrued thereon.
    Personnes ayant droit
    • Nws 1 Limited and Nws 7 Limited
    Transactions
    • 28 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment
    Créé le 26 juil. 1995
    Livré le 28 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of an agreement and/or this assignment
    Brèves mentions
    Assignment by way of security of:- 1. all monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements, as set out in the schedule attached to the form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nws 7 Limited
    Transactions
    • 28 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over sub-hire agreements
    Créé le 28 févr. 1995
    Livré le 01 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the hire agreeements or under any interim finance document,sub-hire security agreement any other agreement or on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest present and actual contingent or otherwise arising out of the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Humberclyde Industrial Finance Limited
    Transactions
    • 01 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment
    Créé le 31 janv. 1995
    Livré le 07 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of an agreement and this assignment
    Brèves mentions
    All moneys due under the sub-hire agreements the benefit of all guarantees indemnities and securities.
    Personnes ayant droit
    • Nws 1 Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment
    Créé le 31 janv. 1995
    Livré le 07 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 23RD january 1995 and the assignment
    Brèves mentions
    All moneys credited to and standing to the credit of the cash collateral account being account no 66080827 and called o & k orenstein & koppel limited -nws.
    Personnes ayant droit
    • Nws 1 Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 31 déc. 1994
    Livré le 13 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys right title and interest in and to all sub hire agreements including the right to receive the sub hire debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • International Nederlanden Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 13 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment
    Créé le 01 déc. 1994
    Livré le 10 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a leasing agreement of even date
    Brèves mentions
    Sub-leases/hiring agreements and the moneys payable thereunder and all its rights title and interest in or to the contracts,the contract earnings,the insurances,all moneys payable in respect of a total loss and all book and other debts due owing payable or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Lease Plan UK Limited
    Transactions
    • 10 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment by way of security and charge of sub-leases
    Créé le 28 janv. 1994
    Livré le 16 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the acquisition documents and the security documents and this deed (as defined therein)
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest fixed and floating charges over all the property pursuant to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • At&T Capital Limited
    Transactions
    • 16 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 21 sept. 1993
    Livré le 06 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys rights title & interest in & to all sub hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Internationale Nederlanden Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 06 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 30 juil. 1993
    Livré le 13 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys right title and interest in and to all the sub-hire agreements and the right to receive the sub-hire debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • International Nederlanden Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 13 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 11 juin 1993
    Livré le 17 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys title right and interest in and to the sub-hire agreements.
    Personnes ayant droit
    • International Nederlanden Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 17 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 18 déc. 1992
    Livré le 21 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys right title and interest in and to all sub-hire agreements and the right to receive the sub-hire debts.
    Personnes ayant droit
    • International Nederlanden Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 21 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 11 déc. 1992
    Livré le 21 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys right title and interest in and to all the sub-hire agreements and the right to receive the sub-hire debts.
    Personnes ayant droit
    • International Nederlanden Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 21 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 30 avr. 1992
    Livré le 15 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys right title and interest in and to the sub hire agreements including the right to receive the sub hire debts please see doc M20C for details.
    Personnes ayant droit
    • Nmb Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 15 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 09 avr. 1992
    Livré le 30 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All tthe companys right title and interest in and to the sub hire agreements and the right to receive the sub hire debtsplease see doc M128C for details.
    Personnes ayant droit
    • Nmb Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 30 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 05 févr. 1992
    Livré le 07 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All of the company's rights title and interest (please see doc 395 tc ref M317C for full details).
    Personnes ayant droit
    • Nmb Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 03 févr. 1992
    Livré le 05 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys title right and interest in and to all the sub hire agreements including the right to receive the sub hire debts.
    Personnes ayant droit
    • Nmb Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 05 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 03 févr. 1992
    Livré le 05 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys title right and interest in and to all the sub hire agreements including the right to receive the sub hire debts.
    Personnes ayant droit
    • Nmb Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 05 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    EASTFIELD NO.30 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 août 2013Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Graham Stuart Wolloff
    Elwell Watchorn & Saxton
    2 Axon
    PE2 6LR Commerce Road
    Lynchwood Peterborough
    practitioner
    Elwell Watchorn & Saxton
    2 Axon
    PE2 6LR Commerce Road
    Lynchwood Peterborough

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0