MI HUB LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMI HUB LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00454264
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MI HUB LIMITED ?

    • fabrication de vêtements de travail (14120) / Industries manufacturières

    Où se situe MI HUB LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    Derbyshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MI HUB LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MWUK LIMITED17 mars 201117 mars 2011
    DIMENSIONS CLOTHING LIMITED01 mai 200801 mai 2008
    JOHNSON CLOTHING LIMITED17 janv. 200617 janv. 2006
    C. C. M. LIMITED08 mai 198508 mai 1985
    C.C.M. RAVEN LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981
    C.C.M. (LANCASHIRE) LIMITED19 mai 194819 mai 1948

    Quels sont les derniers comptes de MI HUB LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 juil. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 avr. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au03 août 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MI HUB LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 juil. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 août 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 juil. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour MI HUB LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    legacy

    4 pagesRP01SH01

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2025 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 03 août 2024

    38 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 29 juil. 2023

    41 pagesAA

    Inscription de la charge 004542640014, créée le 28 nov. 2023

    67 pagesMR01

    Changement d'adresse du siège social de 3 Long Acres Willow Farm Castle Donington Derbyshire DE74 2UG à 3 Long Acre Willow Farm Business Park Castle Donington Derbyshire DE74 2UG le 16 nov. 2023

    1 pagesAD01

    Modification des détails de Measured Identity Hub Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 nov. 2023

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Hayley Jayne Brooks le 16 nov. 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrzej Rafal Ostrowski le 16 nov. 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Anthony Ellis le 16 nov. 2023

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Philip Anthony Ellis en tant qu'administrateur le 24 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 juil. 2022

    43 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kirk Mark Ehrlich en tant que directeur le 29 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2021

    42 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrzej Rafal Ostrowski en tant qu'administrateur le 03 mai 2022

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 17 déc. 2021 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Morgan Edward Atherton en tant que directeur le 30 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Martin John Lyne en tant que directeur le 31 juil. 2021

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Hayley Jayne Brooks le 12 févr. 2021

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 01 août 2020

    41 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MI HUB LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROOKS, Hayley Jayne
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    United KingdomBritish261710040002
    ELLIS, Philip Anthony
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish126227120001
    OSTROWSKI, Andrzej Rafal
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    United KingdomBritish195252290003
    CARELESS, Robert
    43 Newey Road
    Hall Green
    B28 0JQ Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    43 Newey Road
    Hall Green
    B28 0JQ Birmingham
    West Midlands
    British652260001
    CONLON, Michael
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Secrétaire
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    British153966160001
    HOLMES, Gary William
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    Secrétaire
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    British93975060001
    HOLMES, Gary William
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    Secrétaire
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    British93975060001
    LONGFELLOW, Edwin Charles
    5 Upton Grange
    WA8 9ZA Widnes
    Cheshire
    Secrétaire
    5 Upton Grange
    WA8 9ZA Widnes
    Cheshire
    British41674840002
    MONAGHAN, Yvonne May
    5 Pikes Bridge Fold
    Eccleston
    WA10 5AZ St Helens
    Merseyside
    Secrétaire
    5 Pikes Bridge Fold
    Eccleston
    WA10 5AZ St Helens
    Merseyside
    British7934540002
    PEARSON, Graham
    15 Clover Drive
    Pickmere
    WA16 0WF Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    15 Clover Drive
    Pickmere
    WA16 0WF Knutsford
    Cheshire
    British95884040001
    PEARSON, Richard Barrett
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    British121732790001
    RHODES, Archibald Alexander
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Secrétaire
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    206680560001
    ATHERTON, Morgan Edward
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United KingdomBritish247398160001
    BARNEY, Stephen George
    The Dower House
    77 Brook Street
    LE12 6TT Wymeswold Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    The Dower House
    77 Brook Street
    LE12 6TT Wymeswold Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish73277610001
    BROOME, Raymond
    309 Sandy Lane
    Droylsden
    M43 7JU Manchester
    Administrateur
    309 Sandy Lane
    Droylsden
    M43 7JU Manchester
    British36826020001
    BROWN, Keith Peter
    3 Hanover Drive
    Wigmore
    ME8 0RF Gillingham
    Kent
    Administrateur
    3 Hanover Drive
    Wigmore
    ME8 0RF Gillingham
    Kent
    British17541780002
    CALANDRA, Jack
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican250501440001
    CALANDRA, Jack, Director
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican250501770001
    CARELESS, Robert
    43 Newey Road
    Hall Green
    B28 0JQ Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    43 Newey Road
    Hall Green
    B28 0JQ Birmingham
    West Midlands
    British652260001
    COLLIS, Gary Andrew
    5 Whittle Green
    Woodplumpton
    PR4 0WG Preston
    Lancashire
    Administrateur
    5 Whittle Green
    Woodplumpton
    PR4 0WG Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish62361800003
    CONLON, Michael
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    UsaAmerican191085330001
    DAVIS, Neill
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    UsaUnited States153966520002
    EDWAB, David
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican153964010001
    EHRLICH, Kirk Mark
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    EnglandBritish120514920001
    EWERT, Douglas
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican153963360001
    GAWLER, David
    76 Park Road
    TW12 1HP Hampton Hill
    Middlesex
    Administrateur
    76 Park Road
    TW12 1HP Hampton Hill
    Middlesex
    United KingdomSouth African167282630001
    GRAHAM, Stuart William
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United KingdomBritish125975700004
    HAWKINS, Stephen Kenneth
    1 Cae Glas
    Sychdyn, Nr Mold
    CH7 6FD Mold
    Flintshire
    Administrateur
    1 Cae Glas
    Sychdyn, Nr Mold
    CH7 6FD Mold
    Flintshire
    WalesBritish118780710001
    HOLMES, Gary William
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    Administrateur
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    British93975060001
    HUGHES, Simon Ralph
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United KingdomBritish121914600001
    INCHLEY, Simon Nicholas
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United KingdomBritish64345880007
    JACKSON, John Ellis
    Ellerslie Coronation Road
    SL5 9LQ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Ellerslie Coronation Road
    SL5 9LQ Ascot
    Berkshire
    British2219540001
    KIMMINS, Jon
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    UsaAmerican191164530001
    LOCHERY, Anthony Francis
    85 Ravelston Dykes
    EH12 6EZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    85 Ravelston Dykes
    EH12 6EZ Edinburgh
    Midlothian
    EnglandBritish18996670003
    LYNE, Martin John
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    EnglandBritish164287470001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MI HUB LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Measured Identity Hub Limited
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    16 août 2019
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies For England And Wales
    Numéro d'enregistrement11414518
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Ensco 645 Limited
    Willow Farm
    Castle Donington
    3 Long Acre
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Willow Farm
    Castle Donington
    3 Long Acre
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleModel Articles Regulations 2008
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0