MI HUB LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MI HUB LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00454264 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MI HUB LIMITED ?
| Adresse du siège social | 3 Long Acre Willow Farm Business Park DE74 2UG Castle Donington Derbyshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MI HUB LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 juil. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 avr. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 03 août 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MI HUB LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 juil. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 août 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 juil. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MI HUB LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 4 pages | RP01SH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 03 août 2024 | 38 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 29 juil. 2023 | 41 pages | AA | ||||||||||||||
Inscription de la charge 004542640014, créée le 28 nov. 2023 | 67 pages | MR01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3 Long Acres Willow Farm Castle Donington Derbyshire DE74 2UG à 3 Long Acre Willow Farm Business Park Castle Donington Derbyshire DE74 2UG le 16 nov. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Measured Identity Hub Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 nov. 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Hayley Jayne Brooks le 16 nov. 2023 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrzej Rafal Ostrowski le 16 nov. 2023 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Anthony Ellis le 16 nov. 2023 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Philip Anthony Ellis en tant qu'administrateur le 24 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juil. 2022 | 43 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Kirk Mark Ehrlich en tant que directeur le 29 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2021 | 42 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Andrzej Rafal Ostrowski en tant qu'administrateur le 03 mai 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 déc. 2021 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Morgan Edward Atherton en tant que directeur le 30 sept. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Martin John Lyne en tant que directeur le 31 juil. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Hayley Jayne Brooks le 12 févr. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 01 août 2020 | 41 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de MI HUB LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKS, Hayley Jayne | Administrateur | Long Acre Willow Farm Business Park DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire England | United Kingdom | British | 261710040002 | |||||
| ELLIS, Philip Anthony | Administrateur | Long Acre Willow Farm Business Park DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire England | England | British | 126227120001 | |||||
| OSTROWSKI, Andrzej Rafal | Administrateur | Long Acre Willow Farm Business Park DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire England | United Kingdom | British | 195252290003 | |||||
| CARELESS, Robert | Secrétaire | 43 Newey Road Hall Green B28 0JQ Birmingham West Midlands | British | 652260001 | ||||||
| CONLON, Michael | Secrétaire | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | British | 153966160001 | ||||||
| HOLMES, Gary William | Secrétaire | 48 Badgers Way DT10 1EP Sturminster Newton Dorset | British | 93975060001 | ||||||
| HOLMES, Gary William | Secrétaire | 48 Badgers Way DT10 1EP Sturminster Newton Dorset | British | 93975060001 | ||||||
| LONGFELLOW, Edwin Charles | Secrétaire | 5 Upton Grange WA8 9ZA Widnes Cheshire | British | 41674840002 | ||||||
| MONAGHAN, Yvonne May | Secrétaire | 5 Pikes Bridge Fold Eccleston WA10 5AZ St Helens Merseyside | British | 7934540002 | ||||||
| PEARSON, Graham | Secrétaire | 15 Clover Drive Pickmere WA16 0WF Knutsford Cheshire | British | 95884040001 | ||||||
| PEARSON, Richard Barrett | Secrétaire | 20 Croft Road Edwalton NG12 4BW Nottingham Nottinghamshire | British | 121732790001 | ||||||
| RHODES, Archibald Alexander | Secrétaire | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | 206680560001 | |||||||
| ATHERTON, Morgan Edward | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United Kingdom | British | 247398160001 | |||||
| BARNEY, Stephen George | Administrateur | The Dower House 77 Brook Street LE12 6TT Wymeswold Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 73277610001 | |||||
| BROOME, Raymond | Administrateur | 309 Sandy Lane Droylsden M43 7JU Manchester | British | 36826020001 | ||||||
| BROWN, Keith Peter | Administrateur | 3 Hanover Drive Wigmore ME8 0RF Gillingham Kent | British | 17541780002 | ||||||
| CALANDRA, Jack | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United States | American | 250501440001 | |||||
| CALANDRA, Jack, Director | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United States | American | 250501770001 | |||||
| CARELESS, Robert | Administrateur | 43 Newey Road Hall Green B28 0JQ Birmingham West Midlands | British | 652260001 | ||||||
| COLLIS, Gary Andrew | Administrateur | 5 Whittle Green Woodplumpton PR4 0WG Preston Lancashire | United Kingdom | British | 62361800003 | |||||
| CONLON, Michael | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | Usa | American | 191085330001 | |||||
| DAVIS, Neill | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | Usa | United States | 153966520002 | |||||
| EDWAB, David | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United States | American | 153964010001 | |||||
| EHRLICH, Kirk Mark | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | England | British | 120514920001 | |||||
| EWERT, Douglas | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United States | American | 153963360001 | |||||
| GAWLER, David | Administrateur | 76 Park Road TW12 1HP Hampton Hill Middlesex | United Kingdom | South African | 167282630001 | |||||
| GRAHAM, Stuart William | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United Kingdom | British | 125975700004 | |||||
| HAWKINS, Stephen Kenneth | Administrateur | 1 Cae Glas Sychdyn, Nr Mold CH7 6FD Mold Flintshire | Wales | British | 118780710001 | |||||
| HOLMES, Gary William | Administrateur | 48 Badgers Way DT10 1EP Sturminster Newton Dorset | British | 93975060001 | ||||||
| HUGHES, Simon Ralph | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United Kingdom | British | 121914600001 | |||||
| INCHLEY, Simon Nicholas | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United Kingdom | British | 64345880007 | |||||
| JACKSON, John Ellis | Administrateur | Ellerslie Coronation Road SL5 9LQ Ascot Berkshire | British | 2219540001 | ||||||
| KIMMINS, Jon | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | Usa | American | 191164530001 | |||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Administrateur | 85 Ravelston Dykes EH12 6EZ Edinburgh Midlothian | England | British | 18996670003 | |||||
| LYNE, Martin John | Administrateur | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | England | British | 164287470001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MI HUB LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured Identity Hub Limited | 16 août 2019 | Long Acre Willow Farm Business Park DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ensco 645 Limited | 06 avr. 2016 | Willow Farm Castle Donington 3 Long Acre United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0