ESTUARY ENGINEERING CO.,LIMITED

ESTUARY ENGINEERING CO.,LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéESTUARY ENGINEERING CO.,LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00459500
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ESTUARY ENGINEERING CO.,LIMITED ?

    • fabrication d'autres machines à usage spécial n.c.a. (28990) / Industries manufacturières

    Où se situe ESTUARY ENGINEERING CO.,LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Estuary Engineering Hamlin Way
    Hardwick Narrows Industrial Estate
    PE30 4NG King's Lynn
    Norfolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ESTUARY ENGINEERING CO.,LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour ESTUARY ENGINEERING CO.,LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 19 sept. 2016

    14 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 21 mars 2016

    14 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 24 sept. 2015

    13 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    4 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    23 pages2.17B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    37 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nicholas Watling en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 004595000007, créée le 11 déc. 2014

    26 pagesMR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 août 2014

    État du capital au 05 août 2014

    • Capital: GBP 187,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 juil. 2014

    État du capital après une attribution d'actions au 09 juil. 2014

    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Highway House Rectory Road Great Haseley Oxford Oxon OX44 7JG England

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de * 3 Morston Court Morston Court Cannock Staffordshire WS11 8JB England* le 09 juil. 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Michael Carney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Nicholas Watling en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Eric Lowry en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael Alan Carney en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anthony Jolley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Eric Lowry en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de ESTUARY ENGINEERING CO.,LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CROWSON, Cyril Ernest
    Kerendale
    Long Meadow Brundall
    NR13 5LY Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Kerendale
    Long Meadow Brundall
    NR13 5LY Norwich
    Norfolk
    British1868140001
    GANT, Alwyn Colin
    14 The Warren
    Old Catton
    NR6 7NW Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    14 The Warren
    Old Catton
    NR6 7NW Norwich
    Norfolk
    BritishAccountant1946380001
    LOWRY, Eric Hamilton
    Highway House
    Rectory Road
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Highway House
    Rectory Road
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    Irish4815970002
    MORRISON, David Ernest
    18 Abinger Way
    Eaton
    W24 6WA Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    18 Abinger Way
    Eaton
    W24 6WA Norwich
    Norfolk
    British32904450001
    STEWART, Alan Trevor
    Eglantine White Heath Road
    Bergh Apton
    NR15 1AY Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Eglantine White Heath Road
    Bergh Apton
    NR15 1AY Norwich
    Norfolk
    BritishChartered Accountant23183480002
    CARNEY, Michael Alan
    Morston Court
    Morston Court
    WS11 8JB Cannock
    3
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Morston Court
    Morston Court
    WS11 8JB Cannock
    3
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritishSolicitor178438940001
    CROWSON, Cyril Ernest
    Kerendale
    Long Meadow Brundall
    NR13 5LY Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Kerendale
    Long Meadow Brundall
    NR13 5LY Norwich
    Norfolk
    BritishDirector1868140001
    FRENCH, Malcolm Francis James
    3 Langland
    Gaton Road
    PE30 4TH Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    3 Langland
    Gaton Road
    PE30 4TH Kings Lynn
    Norfolk
    BritishManaging Director20353160001
    FRENCH, Malcolm Francis James
    3 Langland
    Gaton Road
    PE30 4TH Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    3 Langland
    Gaton Road
    PE30 4TH Kings Lynn
    Norfolk
    BritishDirector20353160001
    GANT, Alwyn Colin
    14 The Warren
    Old Catton
    NR6 7NW Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    14 The Warren
    Old Catton
    NR6 7NW Norwich
    Norfolk
    BritishAccountant1946380001
    GREEN, Walter Ian
    Brome Park Farm
    Brome Avenue
    IP23 7HW Eye
    Suffolk
    Administrateur
    Brome Park Farm
    Brome Avenue
    IP23 7HW Eye
    Suffolk
    BritishEngineer/Company Director34834740001
    JOLLEY, Anthony Paul Richard
    4 Marham Close
    West Lynn
    PE34 3NG Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    4 Marham Close
    West Lynn
    PE34 3NG Kings Lynn
    Norfolk
    United KingdomBritishEngineer69790690001
    LOWRY, Eric Hamilton
    Highway House
    Rectory Road
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    Administrateur
    Highway House
    Rectory Road
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    EnglandIrishChairman4815970002
    MORRISON, David Ernest
    18 Abinger Way
    Eaton
    W24 6WA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    18 Abinger Way
    Eaton
    W24 6WA Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Accountant32904450001
    MORROW, Ian, Sir
    Broadacres
    7 Devils Lane
    CB11 4BB Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Broadacres
    7 Devils Lane
    CB11 4BB Saffron Walden
    Essex
    BritishChartered Accountant1890700002
    PAYNE, Richard
    Bale Hall
    Bale
    NR21 0QS Fakenham
    Norfolk
    Administrateur
    Bale Hall
    Bale
    NR21 0QS Fakenham
    Norfolk
    BritishDirector1922960001
    SENIOR, Alan James
    The Old Rectory Hitcham Lane
    SL1 7DU Burnham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Old Rectory Hitcham Lane
    SL1 7DU Burnham
    Buckinghamshire
    BritishConsultant60918780001
    STEWART, Alan Trevor
    Eglantine White Heath Road
    Bergh Apton
    NR15 1AY Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Eglantine White Heath Road
    Bergh Apton
    NR15 1AY Norwich
    Norfolk
    BritishChartered Accountant23183480002
    WAINWRIGHT, James Francis
    72 High Street
    LE15 6AS Oakham
    Leicestershire
    Administrateur
    72 High Street
    LE15 6AS Oakham
    Leicestershire
    BritishConsultant11576220001
    WATLING, Nicholas
    Hamlin Way
    Hardwick Narrows Industrial Estate
    PE30 4NG King's Lynn
    Estuary Engineering
    Norfolk
    England
    Administrateur
    Hamlin Way
    Hardwick Narrows Industrial Estate
    PE30 4NG King's Lynn
    Estuary Engineering
    Norfolk
    England
    EnglandEnglishDirector185380250001
    WRIGHT, Kenneth Ernest
    11 St Marys Close
    Great Plumstead
    NR13 5EY Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    11 St Marys Close
    Great Plumstead
    NR13 5EY Norwich
    Norfolk
    BritishEngineer/Company Director18738660001

    ESTUARY ENGINEERING CO.,LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 11 déc. 2014
    Livré le 15 déc. 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Redd Factors Limited
    Transactions
    • 15 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Legal charge
    Créé le 17 déc. 2012
    Livré le 22 déc. 2012
    En cours
    Montant garanti
    £170,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 22, hardwick narrows industrial estate, hamlin way, king's lynn, norfolk t/no NK380619.
    Personnes ayant droit
    • Glebemain Limited, Hereford Securities Management Sa and James Wainwright
    Transactions
    • 22 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 01 nov. 2008
    Livré le 14 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £60,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Second charge on the property and equipment floating charge over the assets of the company see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hereford Securities and Management Sa, Glebemain Limited and A.P.R. Jolley
    Transactions
    • 14 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 01 oct. 2008
    Livré le 03 oct. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H unit 22 hamlin way, hardwick narrows industrial est, kings lynn together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture deed
    Créé le 13 juil. 1999
    Livré le 22 juil. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts
    Créé le 24 avr. 1997
    Livré le 30 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an invoice discounting agreement (as therein defined) or otherwise
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge (I) all debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the chargee that fail to vest in the chargee and all rights in favour of the company related to such debts and (ii) all other amounts owing and all rights relating to such amounts, floating charge such of the moneys received in respect of amounts referred to in (ii) above as shall stand released from the fixed equitable charge.
    Personnes ayant droit
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 30 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 19 mars 1991
    Livré le 22 mars 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1991Enregistrement d'une charge

    ESTUARY ENGINEERING CO.,LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 sept. 2016Administration ended
    25 mars 2015Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nathan Jones
    Castle Acres
    Everard Way
    LE19 1BY Narborough
    Leicester
    practitioner
    Castle Acres
    Everard Way
    LE19 1BY Narborough
    Leicester
    Christopher Stirland
    Frp Advisory Llp Castle Acres Everard Way
    Narborough
    LE19 1BY Leicester
    practitioner
    Frp Advisory Llp Castle Acres Everard Way
    Narborough
    LE19 1BY Leicester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0