MARR FOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMARR FOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00467148
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MARR FOODS LIMITED ?

    • Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques (10200) / Industries manufacturières
    • Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques (46380) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe MARR FOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MARR FOODS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MARR FROZEN FOODS LIMITED01 oct. 198101 oct. 1981

    Quels sont les derniers comptes de MARR FOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MARR FOODS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MARR FOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 déc. 2015

    6 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW à 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH le 07 mai 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 avr. 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 sept. 2014

    État du capital au 01 sept. 2014

    • Capital: GBP 3,500,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Hamish Forbes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Jenny Nancy Loncaster en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 sept. 2013

    État du capital au 05 sept. 2013

    • Capital: GBP 3,500,000
    SH01

    Satisfaction de la charge 26 en totalité

    6 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 25 en totalité

    5 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2012

    9 pagesAA

    Nomination de Mr Malcolm Herbert Lofts en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Leadbeater en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Hamish Drummond Forbes en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher Britton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    18 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 20/09/2012
    RES13

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2012 au 30 sept. 2012

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    15 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Seventh senior amendment and restatement deed and other company business 11/06/2012
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MARR FOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    PO BOX 16
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Secrétaire
    PO BOX 16
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02249348
    75197930001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Administrateur
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Administrateur
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    EnglandBritish205633180001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Secrétaire
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    British1031110002
    BERRY, Peter Sidney
    18 St Georges Place
    The Mount
    YO2 2DR York
    North Yorkshire
    Administrateur
    18 St Georges Place
    The Mount
    YO2 2DR York
    North Yorkshire
    British48690810001
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Administrateur
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    EnglandBritish1031110002
    CULPIN, Malcolm
    17 High Wheatley
    Ben Rhydding
    LS29 8RX Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    17 High Wheatley
    Ben Rhydding
    LS29 8RX Ilkley
    West Yorkshire
    British37654460001
    DEE, Frank Rigby
    4 West View
    LS29 9JG Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    4 West View
    LS29 9JG Ilkley
    West Yorkshire
    British780440002
    EVANS, Thomas Jeffrey
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    Administrateur
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    EnglandBritish2183390002
    FORBES, Hamish Drummond
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish66295550001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Administrateur
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanish127032620001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    MILLSON, Steven Roland
    1 The Row
    Walesby
    LN8 3UW Market Rasen
    Lincolnshire
    Administrateur
    1 The Row
    Walesby
    LN8 3UW Market Rasen
    Lincolnshire
    British49260600003
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Administrateur
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    RAINES, Gerald Hector
    19 Marlborough Way
    Country Park
    DN35 0TR Cleethorpes
    South Humberside
    Administrateur
    19 Marlborough Way
    Country Park
    DN35 0TR Cleethorpes
    South Humberside
    British44675880002
    VICKERS, David
    89 Northfield
    Swanland
    HU14 3RE Hull
    Administrateur
    89 Northfield
    Swanland
    HU14 3RE Hull
    British2183410001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001

    MARR FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 oct. 2008
    Livré le 01 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 01 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 sept. 2008
    Livré le 04 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 04 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2007
    Livré le 31 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale the Security Agent
    Transactions
    • 31 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 mars 2006
    Livré le 25 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transactions
    • 25 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2005
    Livré le 17 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All material premises being f/h interest in land and buildings on the north side of clive sullivan way, kingston upon hull t/no HS262846; l/h interest in land to the east of havelock street, kingston upon hull, land on the west side of gillett street and land and buildings on the south west side of gillett street; l/h interest in land and buildings on the south side of the scarborough street, kingston upon hull, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transactions
    • 17 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security accession deed
    Créé le 30 juin 2004
    Livré le 10 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    With full title guarantee, both present and future by way of first legal mortgage the property specified in schedule 1 to the accession deed, together with all buildings and fixtures and all the subsidiary shares and investments specified in schedule 2 to the accession deed;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securityagent)
    Transactions
    • 10 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 02 mai 2003
    Livré le 15 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 02 mai 2003
    Livré le 14 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 déc. 1997
    Livré le 09 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land and buildings on the west side of gillett street kingston upon hull.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 mars 1997
    Livré le 04 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the south of scarborough street, kingston upon hull, city of kingston upon hull.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 nov. 1996
    Livré le 18 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 30 oct. 1995
    Livré le 31 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The principal sum of £36,900.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    A first fixed charge over:1 x yamato sdw 323 WH2 multihead machine,serial no:WG950396.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 31 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 janv. 1995
    Livré le 27 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land south of hall street sandwell west midlands. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 sept. 1994
    Livré le 04 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at the south of scarborough street kingston upon hull humberside.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 24 sept. 1994
    Livré le 28 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 5 of a sale agreement dated 24 september 1994
    Brèves mentions
    Floating charge all the stock in trade both present and future wheresoever situated of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ub (Ross Youngs) Limited
    Transactions
    • 28 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 mai 1991
    Livré le 04 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the south side of hermitage way, mansfield, nottinghamshire. Title no nt 247625.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 25 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 mai 1990
    Livré le 18 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the east of havelock street, kingston upon hull, humberside. Title no hs 169178.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 25 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 mai 1990
    Livré le 08 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the east of havelock street, kingston upon hull, humberside, title no hs 169179.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 25 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 14 avr. 1989
    Livré le 28 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from pinegain limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    For full details of property see form 395 ref M219C.
    Personnes ayant droit
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transactions
    • 28 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 janv. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 14 avr. 1989
    Livré le 20 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from pinegain limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    (For full list of properties charged see form 395 ref:M613C and attached schedule a). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 20 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 janv. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 14 avr. 1989
    Livré le 19 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/o rpinegain limited to the chargee under the terms of the secured loan and subscription agreement dated 14.4.89 and this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Andrew Marr International Limited
    Transactions
    • 19 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 05 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 14 avr. 1989
    Livré le 19 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or pinegain limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Andrew Leslie Marr
    Transactions
    • 19 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 05 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture.
    Créé le 14 avr. 1989
    Livré le 26 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company pinegain limited. To the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 25 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 janv. 1985
    Livré le 24 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land on the west side of gillett st.kingston-upon-hull, humberside, togetherwith all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    • 05 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 nov. 1980
    Livré le 22 nov. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all fixtures and fittings, fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transactions
    • 22 nov. 1980Enregistrement d'une charge
    • 05 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MARR FOODS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 mars 2016Dissolved on
    16 avr. 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    practitioner
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0