STURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED

STURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00469160
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe STURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o C/O SCHENCK PROCESS UK LTD
    Unit 6 Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STURTEVANT WELBECK LIMITED31 mai 194931 mai 1949

    Quels sont les derniers comptes de STURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour STURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour STURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 sept. 2015

    État du capital au 18 sept. 2015

    • Capital: GBP 56,200
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 sept. 2014

    État du capital au 18 sept. 2014

    • Capital: GBP 56,200
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Nicholas Jones en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jonathan Dove en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Jonathan Dove en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard Geoffrey Ellis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 sept. 2013

    État du capital au 10 sept. 2013

    • Capital: GBP 56,200
    SH01

    Nomination de Mr Jonathan Mark Dove en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jonathan Mark Dove en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de John Hall en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Hall en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O C/O Clyde Process Limited Unit 6 Carolina Court Lakeside Doncaster South Yorkshire DN4 5RA England* le 03 août 2012

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O C/O Clyde Materials Handling Ltd Unit 6 Carolina Court Lakeside Doncaster South Yorkshire DN4 5RA England* le 05 août 2011

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2011

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Leonard Allen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Nicolas Paul Jones en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de STURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Nicholas
    c/o C/O Schenck Process Uk Ltd
    Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Unit 6
    South Yorkshire
    England
    Secrétaire
    c/o C/O Schenck Process Uk Ltd
    Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Unit 6
    South Yorkshire
    England
    183114600001
    ELLIS, Richard Geoffrey
    c/o C/O Schenck Process Uk Ltd
    Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Unit 6
    South Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Schenck Process Uk Ltd
    Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Unit 6
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector162811770001
    JONES, Nicholas Paul
    c/o C/O Schenck Process Uk Ltd
    Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Unit 6
    South Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Schenck Process Uk Ltd
    Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Unit 6
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector72128780003
    DEACON, Lee John
    13 The Meads
    Coldean
    BN1 9BA Brighton
    East Sussex
    Secrétaire
    13 The Meads
    Coldean
    BN1 9BA Brighton
    East Sussex
    British14149390001
    DOVE, Jonathan Mark
    c/o C/O Schenck Process Uk Ltd
    Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Unit 6
    South Yorkshire
    England
    Secrétaire
    c/o C/O Schenck Process Uk Ltd
    Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Unit 6
    South Yorkshire
    England
    177652960001
    HALL, John
    2 Oak Tree Road
    Bawtry
    DN10 6LD Doncaster
    South Yorkshire
    Secrétaire
    2 Oak Tree Road
    Bawtry
    DN10 6LD Doncaster
    South Yorkshire
    BritishAccountant89122250001
    ALLEN, Leonard David
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Carolina Court
    South Yorkshire
    Administrateur
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Carolina Court
    South Yorkshire
    United KingdomBritishNone149268490001
    COOMBE, Anthony Joseph
    1 Woronzow Road
    NW8 6QB London
    Administrateur
    1 Woronzow Road
    NW8 6QB London
    BritishManaging Director14149400001
    DEACON, Lee John
    13 The Meads
    Coldean
    BN1 9BA Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    13 The Meads
    Coldean
    BN1 9BA Brighton
    East Sussex
    BritishFinance Director14149390001
    DEVINE, Anne
    13 North Gardiner Street
    Hyndland
    G11 5PU Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    13 North Gardiner Street
    Hyndland
    G11 5PU Glasgow
    Strathclyde
    BritishDirector37319910001
    DOVE, Jonathan Mark
    c/o C/O Schenck Process Uk Ltd
    Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Unit 6
    South Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Schenck Process Uk Ltd
    Carolina Court
    Lakeside
    DN4 5RA Doncaster
    Unit 6
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector175304180001
    GRAY, William Osborne
    33 Parkhall Road
    G81 3QS Clydebank
    Strathclyde
    Administrateur
    33 Parkhall Road
    G81 3QS Clydebank
    Strathclyde
    BritishCompany Director552010001
    HALL, John
    2 Oak Tree Road
    Bawtry
    DN10 6LD Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    2 Oak Tree Road
    Bawtry
    DN10 6LD Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishAccountant89122250001
    MCCOLL, James Allan
    Whitworth
    14 Carmunnock Road
    G86 8FZ Busby
    Strathclyde
    Administrateur
    Whitworth
    14 Carmunnock Road
    G86 8FZ Busby
    Strathclyde
    BritishCompany Director62650060001
    SCALES, Anthony James
    7 Ovingdean Close
    Ovingdean
    BN2 7AD Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    7 Ovingdean Close
    Ovingdean
    BN2 7AD Brighton
    East Sussex
    BritishProduction Director14149420001
    SMITH, Derek James
    39 St Andrews Road
    Portslade
    BN41 1DB Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    39 St Andrews Road
    Portslade
    BN41 1DB Brighton
    East Sussex
    BritishWorks Director14149410001
    STEWART, Alexander
    2 St. Edmund's Lane
    Milngavie
    G62 8LT Glasgow
    Administrateur
    2 St. Edmund's Lane
    Milngavie
    G62 8LT Glasgow
    ScotlandScottishAccountant45705400003
    THELWELL, Anthony Roy
    4 Sandby Drive
    Marple Bridge
    SK6 5DP Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    4 Sandby Drive
    Marple Bridge
    SK6 5DP Stockport
    Cheshire
    BritishSales Director14149430001
    THOMSON, William John
    Clorwond Drymen Road
    Balloch
    G83 8HT Alexandria
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Clorwond Drymen Road
    Balloch
    G83 8HT Alexandria
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishCompany Director157620660001

    STURTEVANT ENGINEERING AND MANUFACTURING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 oct. 1996
    Livré le 07 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 07 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 31 oct. 1985
    Livré le 08 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from windpool limited and/or sturtevant engineering company limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 25 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 1985
    Livré le 08 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 08 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 25 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 31 oct. 1983
    Livré le 09 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named there in to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 31 oct. 1983
    Livré le 02 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or windpool limited to the chargee on any accouant whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 02 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    • 08 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0