GEORGE LINES (MERCHANTS) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | GEORGE LINES (MERCHANTS) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00469855 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GEORGE LINES (MERCHANTS) LIMITED ?
Adresse du siège social | Unit 1 Radford Industrial Estate Goodhall Street NW10 6UA London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GEORGE LINES (MERCHANTS) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour GEORGE LINES (MERCHANTS) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 6 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Cessation de la nomination de Timothy David Holton en tant que directeur le 08 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 6 pages | AA | ||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Michael Day le 26 nov. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||
Cessation de la nomination de Rajen Bhupendrabhai Patel en tant que directeur le 16 nov. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||
Cessation de la nomination de Nilesh Rasikbhai Patel en tant que directeur le 16 nov. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||
Nomination de Mr Christopher Michael Day en tant qu'administrateur le 16 nov. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||
Deuxième dépôt pour la notification de Carboclass Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif | 7 pages | RP04PSC02 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 6 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 6 pages | AA | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 3 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2019 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Notification de Carboclass Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 3 pages | PSC02 | ||||||
| ||||||||
Cessation de Shanker Bhupendrabhai Patel en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 1 pages | PSC07 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 5 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016 | 14 pages | AA | ||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 sept. 2017 au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||
Qui sont les dirigeants de GEORGE LINES (MERCHANTS) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY, Christopher Michael | Administrateur | Radford Industrial Estate Goodhall Street NW10 6UA London Unit 1 England | England | British | Director | 239542550004 | ||||
PATEL, Shanker Bhupendrabhai | Administrateur | Radford Industrial Estate Goodhall Street NW10 6UA London Unit 1 England | England | British | Director | 118982730001 | ||||
BONE, Christopher Stephen | Secrétaire | Flat A 34 Hans Road Knightsbridge SW3 1RW London | British | 15146100001 | ||||||
BONE, Judith | Secrétaire | Pinkneys Folly Marlow Road SL6 6PR Pinkneys Green Berkshire | British | 118463300001 | ||||||
BONE, Michael John Stuart | Secrétaire | Stradbroke House Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 15144880001 | ||||||
BONE, Timothy Michael Stuart | Secrétaire | 10 Duke Street SL4 1SA Windsor Berkshire | British | Accountant | 49613080001 | |||||
BONE, Christopher Stephen | Administrateur | Flat A 34 Hans Road Knightsbridge SW3 1RW London | British | Dental Surgeon | 15146100001 | |||||
BONE, Mark Cyril Stuart | Administrateur | Pinkneys Folly Marlow Road SL6 6NR Pinkneys Green Berkshire | England | British | Sales Director | 15146110002 | ||||
BONE, Michael John Stuart | Administrateur | Stradbroke House Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 15144880001 | |||||
HOLTON, Timothy David | Administrateur | Radford Industrial Estate Goodhall Street NW10 6UA London Unit 1 England | England | British | Company Director | 264173690001 | ||||
PATEL, Nilesh Rasikbhai | Administrateur | Radford Industrial Estate Goodhall Street NW10 6UA London Unit 1 England | United Kingdom | British | Company Director | 32541230001 | ||||
PATEL, Rajen Bhupendrabhai | Administrateur | Radford Industrial Estate Goodhall Street NW10 6UA London Unit 1 England | United Kingdom | British | Company Director | 36610600001 | ||||
POSGATE, John Sidney Stapleton | Administrateur | 12 Reynolds Road HP9 2NJ Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | Corporate Financial Adviser | 19599290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GEORGE LINES (MERCHANTS) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Shanker Bhupendrabhai Patel | 06 avr. 2016 | Radford Industrial Estate Goodhall Street NW10 6UA London Unit 1 England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Carboclass Ltd | 06 avr. 2016 | Radford Industrial Estate Goodhall Street NW10 6UA London Unit 1 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
GEORGE LINES (MERCHANTS) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 28 févr. 2008 Livré le 04 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 19 juin 2007 Livré le 03 nov. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and principal debtor to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The depot coln industrial estate old bath road colnbrook slough berkshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 19 juin 2007 Livré le 06 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 15 mars 2007 Livré le 29 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 mai 1984 Livré le 25 mai 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land on the north side of bath road, spelthorne, surrey title no sy 342773. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 mai 1984 Livré le 25 mai 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land lying to the south of colnbrook by pa-pass colnbrook buckinghamshire title no bm 68590. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 28 août 1981 Livré le 10 sept. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land & buildings at 733A old bath road, colnbrook, buckinghamshire title nos sy 342773 part bm 28769. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0