SANDFIELD GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSANDFIELD GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00469969
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SANDFIELD GROUP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SANDFIELD GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SANDFIELD GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HAWES GROUP LIMITED12 avr. 198412 avr. 1984
    K W HAWES (ELECTRICAL) CO.LIMITED22 juin 194922 juin 1949

    Quels sont les derniers comptes de SANDFIELD GROUP LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2016
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2016
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SANDFIELD GROUP LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 déc. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 janv. 2018
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 déc. 2016
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour SANDFIELD GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire de créanciers

    3 pagesREST-CVL

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    3 pagesCOCOMP

    Cessation de la nomination de Rob Hassell en tant que directeur le 31 janv. 2017

    2 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Hld Sandfield Limited le 28 nov. 2016

    1 pagesCH02

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name28 nov. 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de David Ladley en tant que directeur le 11 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Ladley en tant que directeur le 11 oct. 2016

    1 pagesTM01

    État du capital après une attribution d'actions au 06 juil. 2016

    • Capital: GBP 1,001.00
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    16 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2015 au 31 mars 2016

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Rob Hassell en tant qu'administrateur le 18 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2014

    26 pagesAA

    Cessation de la nomination de Keith Lawrence Hawes en tant que directeur le 27 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 févr. 2016

    État du capital au 29 févr. 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Nomination de Mr David Ladley en tant qu'administrateur le 26 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Clive Warren Hawes en tant que directeur le 22 janv. 2016

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de David John Vernon Thorpe en tant que directeur le 20 mars 2015

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 004699690009 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de David John Vernon Thorpe en tant que secrétaire le 21 janv. 2015

    2 pagesTM02

    Nomination de Hld Sandfield Limited en tant qu'administrateur le 21 janv. 2015

    3 pagesAP02

    Qui sont les dirigeants de SANDFIELD GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SANDFIELD HOLDINGS LIMITED
    The Mill Lane
    Glenfield
    LE3 8DX Leicester
    Mill Lane Industrial Estate
    England
    Administrateur
    The Mill Lane
    Glenfield
    LE3 8DX Leicester
    Mill Lane Industrial Estate
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement9386205
    195440060003
    GORE, David William
    2 Herald Way
    Burbage
    LE10 2NX Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    2 Herald Way
    Burbage
    LE10 2NX Leicester
    Leicestershire
    British57875270001
    HAWES, Clive Warren
    11 The Crosspath
    WD7 8HR Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    11 The Crosspath
    WD7 8HR Radlett
    Hertfordshire
    British47477560002
    THORPE, David John Vernon
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    Secrétaire
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    BritishDirector41175150001
    GORE, David William
    2 Herald Way
    Burbage
    LE10 2NX Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    2 Herald Way
    Burbage
    LE10 2NX Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishFinancial Director57875270001
    HASSELL, Rob
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    Administrateur
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    EnglandBritishConsultant204673900001
    HAWES, Clive Warren
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    Administrateur
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    United KingdomBritishCompany Director47477560003
    HAWES, Keith Lawrence
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    Administrateur
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    United KingdomBritishCompany Director1983630001
    HAWES, Kenneth Warren
    Ridgeways Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3QU Borehamwood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Ridgeways Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3QU Borehamwood
    Hertfordshire
    BritishCompany Director1983620001
    HAWES, Nigel Kenneth
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    Administrateur
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    United KingdomBritishCompany Director1983640003
    HAWES, Vera
    Ridgeways Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3QU Borehamwood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Ridgeways Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3QU Borehamwood
    Hertfordshire
    BritishCompany Director1983650001
    JONES, Michael David
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    Administrateur
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    United KingdomBritishChairman60842760003
    LADLEY, David
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    Administrateur
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    EnglandBritishManaging Director121434180003
    RUMENS, Lawrence Henry
    42 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    42 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector70622700001
    THORPE, David John Vernon
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    Administrateur
    Sandfield Close
    Moulton Park Industrial Estate
    NN3 6EU Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector41175150003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SANDFIELD GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Mill Lane
    Glenfield
    LE3 8DX Leicester
    Mill Lane Industrial Estate
    England
    06 avr. 2016
    The Mill Lane
    Glenfield
    LE3 8DX Leicester
    Mill Lane Industrial Estate
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement09386205
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    SANDFIELD GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 août 2014
    Livré le 06 août 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Leumi Abl Limited
    Transactions
    • 06 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 24 juil. 1996
    Livré le 10 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 1324/1326 high road whetstone london t/no MX176364 all buildings and fixtures thereon & A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 07 mars 1994
    Livré le 23 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at sandfield close moulton park northampton the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 févr. 1989
    Livré le 08 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land and buildings on south side of sandfield close moulton park northampton tog with all buildings & fxitures title no nn 62675 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 27 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 1988
    Livré le 22 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including heritable property & assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 27 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 mars 1983
    Livré le 08 avr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the south side of sandfield close, moulton park, industrial estate northampton title no nn 62675.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 mai 1982
    Livré le 08 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H factory site at sandfield close, off redhouse rd moulton park, northampton, northamptonshire title no:- nn 40619.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 18 août 1970
    Livré le 26 août 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1324 & 1326 high road, whetstone, middlesex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 1970Enregistrement d'une charge
    • 23 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Instr of charge
    Créé le 18 févr. 1969
    Livré le 10 mars 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc
    Brèves mentions
    Beresford avenue, wembley, middx title nos mx 285765, 107315, 150468.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1969Enregistrement d'une charge
    • 23 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SANDFIELD GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 sept. 2017Conclusion of winding up
    07 mars 2017Petition date
    08 mai 2017Commencement of winding up
    15 déc. 2017Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Birmingham
    4th Floor Cannon House
    18 Priory Queensway
    B4 6BS Birmingham
    practitioner
    4th Floor Cannon House
    18 Priory Queensway
    B4 6BS Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0