J.W.RAYLOR & COMPANY(ENGINEERS)LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | J.W.RAYLOR & COMPANY(ENGINEERS)LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00481357 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe J.W.RAYLOR & COMPANY(ENGINEERS)LIMITED ?
Adresse du siège social | Harsco House Regent Park 299 Kingston Road KT22 7SG Leatherhead Surrey |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de J.W.RAYLOR & COMPANY(ENGINEERS)LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour J.W.RAYLOR & COMPANY(ENGINEERS)LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Claude Lashmer Whistler le 10 févr. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Janet Ann Macdonald le 10 févr. 2012 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 2 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Brian O'kelly en tant que directeur le 05 déc. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Roger Gregory Hoad en tant que directeur le 01 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Benjamin Stevenson Read en tant qu'administrateur le 01 nov. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roderick Burns en tant que directeur le 03 oct. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Graeme Croft Tilmouth en tant qu'administrateur le 03 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 2 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alexander James Macdonald le 31 mars 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Geoffrey Butler en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Brian O'kelly en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Alexander James Macdonald en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Roderick Burns en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Martin Roger Gregory Hoad en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 1 pages | AA | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 1 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de J.W.RAYLOR & COMPANY(ENGINEERS)LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACDONALD, Janet Ann | Secrétaire | Harsco House Regent Park 299 Kingston Road KT22 7SG Leatherhead Surrey | British | 90261040005 | ||||||
MACDONALD, Alexander James | Administrateur | Harsco House Regent Park 299 Kingston Road KT22 7SG Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 156375760002 | ||||
READ, Benjamin Stevenson, Mr. | Administrateur | Harsco House Regent Park 299 Kingston Road KT22 7SG Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 164331090001 | ||||
TILMOUTH, Graeme Croft | Administrateur | Harsco House Regent Park 299 Kingston Road KT22 7SG Leatherhead Surrey | England | British | Chartered Accountant | 72928860001 | ||||
WHISTLER, Christopher Claude Lashmer | Administrateur | Harsco House Regent Park 299 Kingston Road KT22 7SG Leatherhead Surrey | England | British | Accountant | 72156580001 | ||||
FORSYTHE, Andrew | Secrétaire | Pine Lodge 2b Coral Close LE10 2HB Burbage Hinckley Leicestershire | British | 104718290001 | ||||||
GOULDING, Graham Thomas | Secrétaire | 126 Auckland Road SE19 2RP London | United Kingdom | Vice President & Treasurer | 1671380002 | |||||
RICHARDSON, Elaine | Secrétaire | The Willows Willowside London Colney AL2 1DP St Albans Hertfordshire | British | 36633090001 | ||||||
ROBERTS, Michael Leslie | Secrétaire | The Farthings Tong Road Bishops Wood ST19 9AB Stafford Staffordshire | British | 109970960001 | ||||||
SCULL, Andrew James | Secrétaire | 2 The Granary Brickwall Farm Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford Bedfordshire | British | 53961740001 | ||||||
BARRETT, John William | Administrateur | 6 Blythewood Close Knowle B91 3HL Solihull West Midlands | England | British | Director | 1682390001 | ||||
BURNS, Roderick | Administrateur | Harsco House Regent Park 299 Kingston Road KT22 7SG Leatherhead Surrey | England | British | Accountant & Finance Director | 137501020001 | ||||
BUTLER, Geoffrey Doy Hopson | Administrateur | Home Green Heath House Road Worplesdon Hill GU22 0QU Woking Surrey | England | British | Director | 72512170001 | ||||
FRICKER, Brian William | Administrateur | Flat 2 Seapoint Court 3 Knowsley Road PR9 0HG Southport Merseyside | British | Director | 29097670002 | |||||
HOAD, Martin Roger Gregory | Administrateur | Harsco House Regent Park 299 Kingston Road KT22 7SG Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Director International Treasury | 156364900001 | ||||
O'KELLY, Paul Brian | Administrateur | Harsco House Regent Park 299 Kingston Road KT22 7SG Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 184075280001 | ||||
PATTISON, William | Administrateur | 27 The Grove KT12 2HP Walton On Thames Surrey | British | Engineer | 1682540001 | |||||
ROBERTS, Michael Leslie | Administrateur | The Farthings Tong Road Bishops Wood ST19 9AB Stafford Staffordshire | British | Director | 109970960001 | |||||
SCULL, Andrew James | Administrateur | 2 The Granary Brickwall Farm Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford Bedfordshire | British | Lawyer | 53961740001 | |||||
YAPP, Stephen | Administrateur | 4 The Tovells Off School Lane Ufford IP13 6HF Woodbridge Suffolk | England | British | Director | 42686850001 |
J.W.RAYLOR & COMPANY(ENGINEERS)LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Créé le 01 mai 1984 Livré le 02 mai 1984 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land forming part of the former goods yard at harrietsham station, harrietsham, kent with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 01 mai 1984 Livré le 02 mai 1984 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Portable office accommodation open-sided corrigated iron storage shed together with all additions & alterations accessories replacements and renewals of parts together with the benefit on any obligations and warranties given by any manufacturer or supplier. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 15 mars 1982 Livré le 24 mars 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all of any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant and machinery (see doc M26). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 24 mars 1976 Livré le 13 avr. 1976 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land in central avenue, west molesey, surrey. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment | Créé le 06 sept. 1972 Livré le 22 sept. 1972 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The sum of £200,000 due & owing to the company by audax LTD. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 30 juil. 1955 Livré le 09 août 1955 | En cours | Montant garanti All moneys due etc. | |
Brèves mentions Undertaking, goodwill & all property present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0