ARNDALE PROPERTY TRUST LIMITED(THE)

ARNDALE PROPERTY TRUST LIMITED(THE)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéARNDALE PROPERTY TRUST LIMITED(THE)
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00487590
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ARNDALE PROPERTY TRUST LIMITED(THE) ?

    • (7020) /

    Où se situe ARNDALE PROPERTY TRUST LIMITED(THE) ?

    Adresse du siège social
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ARNDALE PROPERTY TRUST LIMITED(THE) ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au24 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ARNDALE PROPERTY TRUST LIMITED(THE) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 16 Palace Street London SW1E 5JQ le 25 oct. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 13 oct. 2011

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 mai 2011

    État du capital au 25 mai 2011

    • Capital: GBP 3,147,265.25
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de ARNDALE PROPERTY TRUST LIMITED(THE) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COOMBE, Cynthia Mary
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Secrétaire
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    155167820001
    BARNETT, Ian Gregory Howie
    The Firs
    RG17 9PT Inkpen
    Winswood
    United Kingdom
    Administrateur
    The Firs
    RG17 9PT Inkpen
    Winswood
    United Kingdom
    United KingdomBritish11591280001
    KESHIRO, Rashidi Olugbenga
    19 Longfield Avenue
    NW7 2EH London
    Administrateur
    19 Longfield Avenue
    NW7 2EH London
    United KingdomBritish120935530001
    ALLINSON, Bernadette
    Linden Lea
    Hutton Roof
    LA6 2PG Kirkby Lonsdale
    Lancashire
    Secrétaire
    Linden Lea
    Hutton Roof
    LA6 2PG Kirkby Lonsdale
    Lancashire
    Other116264270001
    ASHURST, John Richard
    20 Culverhay
    KT21 1PR Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    20 Culverhay
    KT21 1PR Ashtead
    Surrey
    British31732150003
    BIGNELL, Philip Alwyn
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    Secrétaire
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    British11498530001
    NICHOLSON, David John
    Savannah Villa 7
    PO BOX 28656
    Dubai
    Arabian Ranches
    United Arab Emirates
    Secrétaire
    Savannah Villa 7
    PO BOX 28656
    Dubai
    Arabian Ranches
    United Arab Emirates
    Other129525930001
    WYATT, Edmund Kenneth
    145 Oaklands Avenue
    Oxhey
    WD1 4LH Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    145 Oaklands Avenue
    Oxhey
    WD1 4LH Watford
    Hertfordshire
    British10691680001
    BIGNELL, Philip Alwyn
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    Administrateur
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    United KingdomBritish11498530001
    EDGERLEY, William Thomas
    1 Diamond Terrace
    Greenwich
    SE10 8QN London
    Administrateur
    1 Diamond Terrace
    Greenwich
    SE10 8QN London
    EnglandBritish36091100002
    FERGUSON, Robert George
    The Warren 51 Between Streets
    KT11 1AA Cobham
    Surrey
    Administrateur
    The Warren 51 Between Streets
    KT11 1AA Cobham
    Surrey
    British10691690002
    FLETCHER, Angus Howard
    9 Lees Heights
    Charlbury
    OX7 3EZ Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    9 Lees Heights
    Charlbury
    OX7 3EZ Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish65254010001
    KNIGHT, Raymond Antony
    Furzewood Barden Road
    Speldhurst
    TN3 0LE Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Furzewood Barden Road
    Speldhurst
    TN3 0LE Tunbridge Wells
    Kent
    British2198910001
    PREISKEL, Anthony Alexander
    93 Corringham Road
    NW11 7DL London
    Administrateur
    93 Corringham Road
    NW11 7DL London
    United KingdomBritish36551930001
    SADLER, Christopher Frank
    59a Marney Road
    Battersea
    SW11 5EW London
    Administrateur
    59a Marney Road
    Battersea
    SW11 5EW London
    British36608160001
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Administrateur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritish708770001

    ARNDALE PROPERTY TRUST LIMITED(THE) a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 19 déc. 1988
    Livré le 30 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a trust deed dated 24/12/85 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    A lease of 160 to 204 main street, barrhead title no. REN14298 together with the whole rights, parts, privileges and pertinents.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 30 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental trust deed
    Créé le 07 déc. 1988
    Livré le 13 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,587,800 first mortgage debenture stock 2000 of p & o property holdings limited and all other monies due or to become due to the chargee secured by a trust deed dated 24/12/85 as defined in the deed
    Brèves mentions
    L/H 1-28 arndale square, charnwood avenue, longbenton title no. TY177136 together with all buildings and erections, fixed plant machinery and landlords' fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 13 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 06 déc. 1988
    Livré le 19 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 24/12/85 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    A lease of 160-204 main street, barrhead title no. REN14298.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 19 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental trust deed
    Créé le 13 avr. 1987
    Livré le 16 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from town & city properties limited pursuant to a supplemental trust deed dated 24/12/85 and all other monies secured by the supplemental trust deed
    Brèves mentions
    A cash deposit of £608,290 with the society together with interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 16 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental trust deed
    Créé le 24 mars 1987
    Livré le 30 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from town & city properties limited pursuant to a supplemental trust deed dated 24/12/85
    Brèves mentions
    A cash deposit of £226,040 with the society together with interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 30 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental trust deed
    Créé le 29 sept. 1986
    Livré le 20 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from town and city properties limited to the chargee pursuant to the principal deed dated 24/12/85
    Brèves mentions
    A cash deposit of £861,600 with the society together with interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 20 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental trust deed
    Créé le 16 mai 1986
    Livré le 19 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from town & city properties limited to the chargee pursuant to the principal deed
    Brèves mentions
    All that l/h property containing 1,400 sq. Yards situate at charnwood avenue, longbenton, tyne and wear together with plant machinery fixtures implements and utensils (see doc.M636 for details).
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 19 mai 1986Enregistrement d'une charge
    Standard security registered in scotland on 17/1/86
    Créé le 17 janv. 1986
    Livré le 21 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 24/12/85
    Brèves mentions
    Lease of 160 to 204 main street, barrhead title no. REN14298.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows Fund & Life Assurance Society
    Transactions
    • 21 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Trust deed registered pursuant to an order of court
    Créé le 24 déc. 1985
    Livré le 13 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,587,800 first mortgage debenture stock 2000 of town & city properties limited and all other monies intended to be secured by the trust deed
    Brèves mentions
    L/H arndale house, halewood avenue and kirkwood drive, newcastle upon tyne, tyne & wear (see doc. For the other properties) together with all buildings and erections and fixed plant and machinery and landlords' fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 13 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Trust deed
    Créé le 24 déc. 1985
    Livré le 10 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £2,750,000 first mortgage debenture stock 1997 of town & city properties limited and all other monies intended to be secured by the trust deed dated 25/11/77 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    L/H 62-70 westgate and 2-8 john street, bradford, west yorkshire. F/h 33-35 victoria square, bolton, greater manchester title no. GM192499 together with all buildings and erections and fixed plant and machinery and landlords' fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 10 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 23 déc. 1985
    Livré le 11 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 24/12/85 (and any amending or supplemental deeds) and the charge
    Brèves mentions
    A lease of 160 to 204 main street, barrhead title no. REN14298.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows' Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 11 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 1985
    Livré le 02 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,350,000
    Brèves mentions
    Land on the east side of station road, cross gates, leeds together with the covered mall shops and all other buildings and car parks erected thereon or on parts thereof k/a the arndale shopping centre, cross gates, leeds.
    Personnes ayant droit
    • Sun Life Assurance Society PLC
    Transactions
    • 02 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    • 11 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 déc. 1983
    Acquis le 22 nov. 1985
    Livré le 26 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,000,000 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    19/43 (odd) town street and 3/5 (odd) hall road, armley, leeds title no. WYK258726.
    Personnes ayant droit
    • Pension Fund Securities Limited
    Transactions
    • 26 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 24 mars 1983
    Livré le 29 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,000,000 due from town & city properties PLC to the chargee under the terms of the principal security
    Brèves mentions
    F/H 24/28 trafford way, doncaster (see doc. M613).
    Personnes ayant droit
    • Pension Funds Securities Limited
    Transactions
    • 29 mars 1983Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 03 sept. 1982
    Livré le 10 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a the arndale centre, wandsworth title no. SGL43766. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Investment Bank
    Transactions
    • 10 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1982
    Livré le 02 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or town & city properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 21-41 (odd) doncaster road, bolton upon dearne, south yorkshire title no. YK2781.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank Limited
    Transactions
    • 02 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    Supplemental trust deed
    Créé le 24 mars 1982
    Livré le 30 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing £5,587,800 first mortgage debenture stock 2000 of the company and all other monies intended to be secured by the trust deed dated 15/7/77 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    F/H 21-41 (odd) doncaster road, goldthorpe, barnsley, S. yorks.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Widows Fund and Life Assurance Society
    Transactions
    • 30 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Deed of release and substitution
    Créé le 19 mars 1982
    Livré le 24 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,400,000 7% first mortgage debenture stock and £1,600,000 8 1/2% first mortgage debenture stock of the company supplemental to the trust deed
    Brèves mentions
    F/H 38 whitworth street and 46 sackville street, manchester title no. LA198462.
    Personnes ayant droit
    • Commercial Union Assurance Company PLC
    Transactions
    • 24 mars 1982Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of variation
    Créé le 12 mars 1982
    Livré le 24 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,000,000 due from town & city properties limited to the chargee supplemental to the principal deed dated 26/11/69 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    Various properties (see doc. M605).
    Personnes ayant droit
    • Pension Funds Securities LTD.
    Transactions
    • 24 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Supplemental legal charge
    Créé le 12 mars 1982
    Livré le 18 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 1/7/66
    Brèves mentions
    L/H property situate in east laith gate and netherhall road, doncaster, south yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Pension Funds Securities Limited
    Transactions
    • 18 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 1982
    Livré le 08 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £275,333 supplemental to a legal charge dated 3/4/68
    Brèves mentions
    The supermarket extension, parkwood precinct, spennymoor, county durham.
    Personnes ayant droit
    • Pension Funds Securities Limited
    Transactions
    • 08 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 07 oct. 1981
    Livré le 23 oct. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or town & city properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 15/29 (odd) broadway, accrington, lancashire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank Limited
    Transactions
    • 23 oct. 1981Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of substitution and charge
    Créé le 30 sept. 1981
    Livré le 01 oct. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,012,096.51
    Brèves mentions
    L/H 15/29 (odd) broadway and 3 cornhill, accrington, lancaster.
    Personnes ayant droit
    • Royal Liver Trustees Limited
    Transactions
    • 01 oct. 1981Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 24 juin 1981
    Livré le 25 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing £1,400,000 7% first mortgage debenture stock 1994 of the company secured by the principal deed dated 31/8/65 and the supplemental trust deed dated 30/11/65 and £1,600,000 8 1/2% first mortgage debenture stock 1994 of the company secured by a supplemental trust deed dated 30/11/73 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    £865,000.
    Personnes ayant droit
    • Commercial Union Assurance Company Limited
    Transactions
    • 25 juin 1981Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 1980
    Livré le 16 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 28/3/80
    Brèves mentions
    The arndale centre, wandsworth, greater london title no. SGL43766.
    Personnes ayant droit
    • N.M. Rothschild & Sons Limited
    Transactions
    • 16 avr. 1980Enregistrement d'une charge

    ARNDALE PROPERTY TRUST LIMITED(THE) a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    2
    DateType
    28 août 2012Dissolved on
    13 oct. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0