LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE)
Vue d'ensemble
Nom de la société | LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00490255 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?
Adresse du siège social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 02 sept. 2022
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Gavin Bergin en tant que directeur le 17 août 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles John Middleton en tant que directeur le 31 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Nick Taunt en tant qu'administrateur le 18 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bruce Michael James en tant que directeur le 31 déc. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Gavin Bergin en tant qu'administrateur le 29 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019 | 15 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 206 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
MCNUFF, Jonathan Charles | Administrateur | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 205624050001 | ||||||||
TAUNT, Nick | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 275050860001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Secrétaire | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||||||
EKPO, Ndiana | Secrétaire | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secrétaire | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Administrateur | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Administrateur | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Chartered Accountant | 32809050044 | ||||||||
BERGIN, Gavin | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 251327820001 | ||||||||
BERRY, David Charles | Administrateur | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 166550001 | |||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Administrateur | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Administrateur | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Administrateur | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
GUNSTON, Michael Ian | Administrateur | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 3079890002 | ||||||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Administrateur | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||||||
JAMES, Bruce Michael | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Head Of Secretariat | 226746900001 | ||||||||
JONES, Andrew Marc | Administrateur | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
KALMAN, Stephen Lionel | Administrateur | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | Chartered Surveyor | 1188110001 | ||||||||
METLISS, Cyril | Administrateur | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||||||
MIDDLETON, Charles John | Administrateur | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Tax Executive | 79841030002 | ||||||||
RITBLAT, John, Sir | Administrateur | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | Chairman And Managing Director | 41694870001 | ||||||||
RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Administrateur | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | Company Director | 35758050004 | ||||||||
ROBERTS, Graham Charles | Administrateur | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | Chartered Accountant | 79807180002 | ||||||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Administrateur | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 63986410004 | ||||||||
SMITH, Stephen Paul | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Director | 148183670001 | ||||||||
VANDEVIVERE, Jean-Marc | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | French | Company Director | 170947050001 | ||||||||
WEBB, Nigel Mark | Administrateur | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Chartered Surveyor | 58059360001 | ||||||||
WESTON SMITH, John Harry | Administrateur | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | Chartered Secretary | 13547380001 | ||||||||
WILSON, Alan James | Administrateur | 30 Broxbourne Road BR6 0AY Orpington Kent | England | British | Chartered Accountant | 3078220001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Land Superstores (Non Securitised) Number 2 Limited | 31 déc. 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 27 févr. 1987 Livré le 13 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the british land company PLC to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge | |
Brèves mentions F/H property k/a 416A and 416/430 (even numbers inclusive) bitterne road bitterne southampton t/no hp 40330. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 02 oct. 1986 Livré le 16 oct. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the british land company PLC to the chargee on any account whatsoever and from the company under the provisions of the charge. | |
Brèves mentions All that f/h property k/a 2A, 6 to 18 (even nos.) st. Peter's square. 1 to 11 (odd nos) oxford street. 18 dickinson street and land on the north side of george street know k/a elizabeth house st. Peters square T.N. la 120100. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental trust deed & deeds supplemental thereto (see doc M73) | Créé le 21 mars 1978 Acquis le 21 mars 1978 Livré le 25 mai 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti £5,000 | |
Brèves mentions F/H cator house, 57/67 (odd nos) fratton road, portsmouth, hamps. Title no HP309301 together with all buidlings & erections, fixtures & fittings fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 18 juil. 1975 Acquis le 06 déc. 1976 Livré le 28 févr. 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti £3,615,000 | |
Brèves mentions 1) f/h land abutting on exchange passage east. Exchange street east. Tithebarn street. Chapel street, rumford street, and exchange passage west, liverpool. Together with office premises and other buildings erected thereon and known as exchange buildings derby house & sefton house. 2) all other (if any) the lands & buildings vested in the co by the liverpool exchange acts 1859 to 1937 or any of them or otherwise and now belonging to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of variation of covenant | Créé le 08 juin 1973 Acquis le 06 déc. 1976 Livré le 02 févr. 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti £2,108,455 | |
Brèves mentions 1) f/h land abutting on exchange passage east, exchange st. East, tithebarn st., Chapel st., Romford st., & exchange passage west, liverpool together with with office premises & other buidings erected thereon & k/as exchange buildings, derby house & sefton house. 2) all other (if any) the lands & buildings vested in the co. By the liverpool exchange acts 1859 to 1937 or any of them or otherwise & now belonging to the co. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 04 mai 1956 Livré le 08 mai 1956 | Totalement satisfaite | Montant garanti £32,000 | |
Brèves mentions Part of leasehold property known as granville arcade brixton, london. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0