LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE)

LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE)
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00490255
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PERRYDALE LIMITED05 janv. 195105 janv. 1951

    Quels sont les derniers comptes de LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 02 sept. 2022

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Gavin Bergin en tant que directeur le 17 août 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Charles John Middleton en tant que directeur le 31 mars 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Nick Taunt en tant qu'administrateur le 18 mars 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bruce Michael James en tant que directeur le 31 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Gavin Bergin en tant qu'administrateur le 29 mars 2021

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019

    15 pagesAA

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    206 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement8992198
    187856670001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    TAUNT, Nick
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant275050860001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary251327820001
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Secretariat226746900001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor1188110001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Administrateur
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Administrateur
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director148183670001
    VANDEVIVERE, Jean-Marc
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchCompany Director170947050001
    WEBB, Nigel Mark
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Administrateur
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001
    WILSON, Alan James
    30 Broxbourne Road
    BR6 0AY Orpington
    Kent
    Administrateur
    30 Broxbourne Road
    BR6 0AY Orpington
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant3078220001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    British Land Superstores (Non Securitised) Number 2 Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    31 déc. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement06514283
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    LIVERPOOL EXCHANGE COMPANY LIMITED(THE) a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 27 févr. 1987
    Livré le 13 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the british land company PLC to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 416A and 416/430 (even numbers inclusive) bitterne road bitterne southampton t/no hp 40330.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 23 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 oct. 1986
    Livré le 16 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the british land company PLC to the chargee on any account whatsoever and from the company under the provisions of the charge.
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a 2A, 6 to 18 (even nos.) st. Peter's square. 1 to 11 (odd nos) oxford street. 18 dickinson street and land on the north side of george street know k/a elizabeth house st. Peters square T.N. la 120100.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 08 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental trust deed & deeds supplemental thereto (see doc M73)
    Créé le 21 mars 1978
    Acquis le 21 mars 1978
    Livré le 25 mai 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000
    Brèves mentions
    F/H cator house, 57/67 (odd nos) fratton road, portsmouth, hamps. Title no HP309301 together with all buidlings & erections, fixtures & fittings fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transactions
    • 25 mai 1978Enregistrement d'une charge
    • 08 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 18 juil. 1975
    Acquis le 06 déc. 1976
    Livré le 28 févr. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,615,000
    Brèves mentions
    1) f/h land abutting on exchange passage east. Exchange street east. Tithebarn street. Chapel street, rumford street, and exchange passage west, liverpool. Together with office premises and other buildings erected thereon and known as exchange buildings derby house & sefton house. 2) all other (if any) the lands & buildings vested in the co by the liverpool exchange acts 1859 to 1937 or any of them or otherwise and now belonging to the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds International (France) LTD
    Transactions
    • 28 févr. 1977Enregistrement d'une charge
    • 08 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of variation of covenant
    Créé le 08 juin 1973
    Acquis le 06 déc. 1976
    Livré le 02 févr. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £2,108,455
    Brèves mentions
    1) f/h land abutting on exchange passage east, exchange st. East, tithebarn st., Chapel st., Romford st., & exchange passage west, liverpool together with with office premises & other buidings erected thereon & k/as exchange buildings, derby house & sefton house. 2) all other (if any) the lands & buildings vested in the co. By the liverpool exchange acts 1859 to 1937 or any of them or otherwise & now belonging to the co.
    Personnes ayant droit
    • Legal and General Assurance Society LTD.
    Transactions
    • 02 févr. 1977Enregistrement d'une charge
    • 08 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 04 mai 1956
    Livré le 08 mai 1956
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £32,000
    Brèves mentions
    Part of leasehold property known as granville arcade brixton, london.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Royal Liver Friendly Society
    Transactions
    • 08 mai 1956Enregistrement d'une charge
    • 08 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0