HYGRADE FOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHYGRADE FOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00493296
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HYGRADE FOODS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HYGRADE FOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Seton House
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HYGRADE FOODS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HYGRADE MEATS LIMITED28 mars 195128 mars 1951

    Quels sont les derniers comptes de HYGRADE FOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour HYGRADE FOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    5 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 13 nov. 2017

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium a/c be cancelled 19/10/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    16 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Christopher Malcolm Terry en tant que secrétaire le 29 juin 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Helen Margaret Glennie en tant qu'administrateur le 29 juin 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Stephen Ronald William Francis en tant qu'administrateur le 29 juin 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christopher Thomas en tant que directeur le 29 juin 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Malcolm Terry en tant que directeur le 29 juin 2017

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2016 au 31 mars 2017

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 07 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Christopher Malcolm Terry en tant que secrétaire le 09 mars 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Herluf Jensen en tant que directeur le 09 mars 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Herluf Jensen en tant que secrétaire le 09 mars 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Christopher Malcolm Terry en tant qu'administrateur le 09 mars 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 févr. 2016

    État du capital au 08 févr. 2016

    • Capital: GBP 154,600
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 sept. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 févr. 2015

    État du capital au 09 févr. 2015

    • Capital: GBP 154,600
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HYGRADE FOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritish205102630001
    GLENNIE, Helen Margaret
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritish217903040001
    BIGWOOD, Penelope Ann
    Charts Edge Hosey Hill
    TN16 1PL Westerham
    Kent
    Secrétaire
    Charts Edge Hosey Hill
    TN16 1PL Westerham
    Kent
    British3795860001
    JENSEN, Herluf
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Secrétaire
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Danish96281690001
    PLYTE, Mark Edward
    The Rides
    Langtoft
    PE6 9LR Peterborough
    14
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    The Rides
    Langtoft
    PE6 9LR Peterborough
    14
    Cambridgeshire
    British133669910001
    TERRY, Christopher Malcolm
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Secrétaire
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    206505240001
    TREMBATH, David John
    Cherry Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NJ Saltash
    Cornwall
    Secrétaire
    Cherry Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NJ Saltash
    Cornwall
    British68807490001
    BACKLER, Raymond John, Dr
    2 The Moorings
    Conyer
    ME9 9HQ Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    2 The Moorings
    Conyer
    ME9 9HQ Sittingbourne
    Kent
    EnglandBritish25213850001
    BIGWOOD, Bernard John
    106 College Road
    Dulwich
    SE21 7HW London
    Administrateur
    106 College Road
    Dulwich
    SE21 7HW London
    British23302040001
    BIGWOOD, Hilda Mary
    106 College Road
    Dulwich
    SE21 7HW London
    Administrateur
    106 College Road
    Dulwich
    SE21 7HW London
    British23302050001
    BIGWOOD, John
    Charts Edge Hosey Hill
    TN16 1PL Westerham
    Kent
    Administrateur
    Charts Edge Hosey Hill
    TN16 1PL Westerham
    Kent
    United KingdomBritish3795870001
    BIGWOOD, John
    Charts Edge Hosey Hill
    TN16 1PL Westerham
    Kent
    Administrateur
    Charts Edge Hosey Hill
    TN16 1PL Westerham
    Kent
    United KingdomBritish3795870001
    BIGWOOD, Penelope Ann
    Charts Edge Hosey Hill
    TN16 1PL Westerham
    Kent
    Administrateur
    Charts Edge Hosey Hill
    TN16 1PL Westerham
    Kent
    United KingdomBritish3795860001
    CONN, George Roger
    11 Old Barn Road
    Leybourne
    ME19 5HQ West Malling
    Kent
    Administrateur
    11 Old Barn Road
    Leybourne
    ME19 5HQ West Malling
    Kent
    British39656210001
    EADES, Ronald Sean William
    Tall Timbers Horton Close
    Boulters Lock
    Maidenhead
    Berks
    Administrateur
    Tall Timbers Horton Close
    Boulters Lock
    Maidenhead
    Berks
    British24049670001
    ENEVOLDSEN, Flemming Nyenstad
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    DenmarkDanish156168570001
    FINLEY, Gerald Wilkin
    Beacon Hurst
    Church Road
    TN6 1BN Crowborough
    East Sussex
    Administrateur
    Beacon Hurst
    Church Road
    TN6 1BN Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritish9534560001
    FINNEY, Peter Stamatis
    30 Nursery Gardens
    TA20 1HH Chard
    Somerset
    Administrateur
    30 Nursery Gardens
    TA20 1HH Chard
    Somerset
    British64150300001
    HAMMOND, Neil John
    Portcullis House Badminton Road
    Acton Turville
    GL9 1HE Badminton
    Avon
    Administrateur
    Portcullis House Badminton Road
    Acton Turville
    GL9 1HE Badminton
    Avon
    British54132030002
    JAKOBSEN, Carsten Svejgaard
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandDanish165874230001
    JENSEN, Herluf
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandDanish96281690001
    KERR, Robert Bruce
    1 Conway Drive
    Broadmayne
    DT2 8EF Dorchester
    Dorset
    Administrateur
    1 Conway Drive
    Broadmayne
    DT2 8EF Dorchester
    Dorset
    British41996420002
    KERR, Robert Bruce
    3 Perth Road
    BR3 2PP Beckenham
    Kent
    Administrateur
    3 Perth Road
    BR3 2PP Beckenham
    Kent
    British41996420001
    MELIA, Graham Peter
    Park House West Street
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Park House West Street
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    British60295310001
    MURRELLS, Steven Geoffrey
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritish156162510001
    O`FLYNN, Terence Michael
    Wyneshore House White Street
    West Lavington
    SN10 4LW Devizes
    Wiltshire
    Administrateur
    Wyneshore House White Street
    West Lavington
    SN10 4LW Devizes
    Wiltshire
    British45520900001
    ROACH, Charles Graham
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandEnglish11070150001
    SMITH, Geoffrey
    Chlver House 87 Lyes Green
    Corsley
    BA12 7PA Warminster
    Wiltshire
    Administrateur
    Chlver House 87 Lyes Green
    Corsley
    BA12 7PA Warminster
    Wiltshire
    British39656300001
    TERRY, Christopher Malcolm, Mr.
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritish60746700002
    THOMAS, Christopher
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritish63844650001
    TRURAN, David Colchester
    Birches Wilderness Road
    BR7 5EZ Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Birches Wilderness Road
    BR7 5EZ Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritish141416950001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HYGRADE FOODS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Tulip Limited
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    England
    06 avr. 2016
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement608077
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HYGRADE FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 28 mars 2002
    Livré le 06 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property listed below together with all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery, 8A leafield industrial estate leafield way corsham wiltshire t/no.WT155985, land and buildings on the east side of leafield way corsham wiltshire t/no.WT152296 & the data centre leafield way corsham wiltshire t/no.WT155258. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Oscar Mayer Limited
    Transactions
    • 06 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 1994
    Livré le 11 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £750,000 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All that land and buildings on east side of haymerle road and north side of latona road peckham london SE t/no.sgl 183699. all that land lying to the north of laytona road peckham t/no. SGL164163. All that land and buildings k/a latona tannery latona road peckham t/no.38902. All that land and buildings on the north side of bianca road and part of the sites of the surrey canal and rodsley ple peckham t/no.sgl 148450 including all fixtures fittings.
    Personnes ayant droit
    • Derek Walter Thomas
    • Penelope Ann Bigwoodas Trustees of the Latona Pension Fund
    • John Bigwood
    Transactions
    • 11 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Instr of charge
    Créé le 15 nov. 1962
    Livré le 26 nov. 1962
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc
    Brèves mentions
    Latona tannery, latona road, peckham, london.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 26 nov. 1962Enregistrement d'une charge
    • 04 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Instr of charge
    Créé le 10 févr. 1954
    Livré le 16 févr. 1954
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc
    Brèves mentions
    381 albany road, camberwell title no 178778.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 16 févr. 1954Enregistrement d'une charge
    • 04 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0