HYGRADE FOODS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HYGRADE FOODS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00493296 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HYGRADE FOODS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Seton House Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HYGRADE FOODS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour HYGRADE FOODS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 13 nov. 2017
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 16 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Malcolm Terry en tant que secrétaire le 29 juin 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Mrs Helen Margaret Glennie en tant qu'administrateur le 29 juin 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Stephen Ronald William Francis en tant qu'administrateur le 29 juin 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Thomas en tant que directeur le 29 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Malcolm Terry en tant que directeur le 29 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2016 au 31 mars 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
D éclaration de confirmation établie le 07 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Christopher Malcolm Terry en tant que secrétaire le 09 mars 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Herluf Jensen en tant que directeur le 09 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Herluf Jensen en tant que secrétaire le 09 mars 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Christopher Malcolm Terry en tant qu'administrateur le 09 mars 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 sept. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de HYGRADE FOODS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIS, Stephen Ronald William | Administrateur | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | England | British | 205102630001 | |||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Administrateur | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | England | British | 217903040001 | |||||
| BIGWOOD, Penelope Ann | Secrétaire | Charts Edge Hosey Hill TN16 1PL Westerham Kent | British | 3795860001 | ||||||
| JENSEN, Herluf | Secrétaire | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | Danish | 96281690001 | ||||||
| PLYTE, Mark Edward | Secrétaire | The Rides Langtoft PE6 9LR Peterborough 14 Cambridgeshire | British | 133669910001 | ||||||
| TERRY, Christopher Malcolm | Secrétaire | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | 206505240001 | |||||||
| TREMBATH, David John | Secrétaire | Cherry Cottage Botus Fleming PL12 6NJ Saltash Cornwall | British | 68807490001 | ||||||
| BACKLER, Raymond John, Dr | Administrateur | 2 The Moorings Conyer ME9 9HQ Sittingbourne Kent | England | British | 25213850001 | |||||
| BIGWOOD, Bernard John | Administrateur | 106 College Road Dulwich SE21 7HW London | British | 23302040001 | ||||||
| BIGWOOD, Hilda Mary | Administrateur | 106 College Road Dulwich SE21 7HW London | British | 23302050001 | ||||||
| BIGWOOD, John | Administrateur | Charts Edge Hosey Hill TN16 1PL Westerham Kent | United Kingdom | British | 3795870001 | |||||
| BIGWOOD, John | Administrateur | Charts Edge Hosey Hill TN16 1PL Westerham Kent | United Kingdom | British | 3795870001 | |||||
| BIGWOOD, Penelope Ann | Administrateur | Charts Edge Hosey Hill TN16 1PL Westerham Kent | United Kingdom | British | 3795860001 | |||||
| CONN, George Roger | Administrateur | 11 Old Barn Road Leybourne ME19 5HQ West Malling Kent | British | 39656210001 | ||||||
| EADES, Ronald Sean William | Administrateur | Tall Timbers Horton Close Boulters Lock Maidenhead Berks | British | 24049670001 | ||||||
| ENEVOLDSEN, Flemming Nyenstad | Administrateur | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | Denmark | Danish | 156168570001 | |||||
| FINLEY, Gerald Wilkin | Administrateur | Beacon Hurst Church Road TN6 1BN Crowborough East Sussex | England | British | 9534560001 | |||||
| FINNEY, Peter Stamatis | Administrateur | 30 Nursery Gardens TA20 1HH Chard Somerset | British | 64150300001 | ||||||
| HAMMOND, Neil John | Administrateur | Portcullis House Badminton Road Acton Turville GL9 1HE Badminton Avon | British | 54132030002 | ||||||
| JAKOBSEN, Carsten Svejgaard | Administrateur | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | England | Danish | 165874230001 | |||||
| JENSEN, Herluf | Administrateur | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | England | Danish | 96281690001 | |||||
| KERR, Robert Bruce | Administrateur | 1 Conway Drive Broadmayne DT2 8EF Dorchester Dorset | British | 41996420002 | ||||||
| KERR, Robert Bruce | Administrateur | 3 Perth Road BR3 2PP Beckenham Kent | British | 41996420001 | ||||||
| MELIA, Graham Peter | Administrateur | Park House West Street Great Somerford SN15 5EH Chippenham Wiltshire | British | 60295310001 | ||||||
| MURRELLS, Steven Geoffrey | Administrateur | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | England | British | 156162510001 | |||||
| O`FLYNN, Terence Michael | Administrateur | Wyneshore House White Street West Lavington SN10 4LW Devizes Wiltshire | British | 45520900001 | ||||||
| ROACH, Charles Graham | Administrateur | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | England | English | 11070150001 | |||||
| SMITH, Geoffrey | Administrateur | Chlver House 87 Lyes Green Corsley BA12 7PA Warminster Wiltshire | British | 39656300001 | ||||||
| TERRY, Christopher Malcolm, Mr. | Administrateur | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | England | British | 60746700002 | |||||
| THOMAS, Christopher | Administrateur | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House | England | British | 63844650001 | |||||
| TRURAN, David Colchester | Administrateur | Birches Wilderness Road BR7 5EZ Chislehurst Kent | United Kingdom | British | 141416950001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HYGRADE FOODS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulip Limited | 06 avr. 2016 | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Seton House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
HYGRADE FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Créé le 28 mars 2002 Livré le 06 avr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/H property listed below together with all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery, 8A leafield industrial estate leafield way corsham wiltshire t/no.WT155985, land and buildings on the east side of leafield way corsham wiltshire t/no.WT152296 & the data centre leafield way corsham wiltshire t/no.WT155258. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 31 janv. 1994 Livré le 11 févr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti £750,000 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions All that land and buildings on east side of haymerle road and north side of latona road peckham london SE t/no.sgl 183699. all that land lying to the north of laytona road peckham t/no. SGL164163. All that land and buildings k/a latona tannery latona road peckham t/no.38902. All that land and buildings on the north side of bianca road and part of the sites of the surrey canal and rodsley ple peckham t/no.sgl 148450 including all fixtures fittings. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Instr of charge | Créé le 15 nov. 1962 Livré le 26 nov. 1962 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due etc | |
Brèves mentions Latona tannery, latona road, peckham, london. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Instr of charge | Créé le 10 févr. 1954 Livré le 16 févr. 1954 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due etc | |
Brèves mentions 381 albany road, camberwell title no 178778. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0