SIDNEY C BANKS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSIDNEY C BANKS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00495831
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SIDNEY C BANKS LIMITED ?

    • Mouture de céréales (10611) / Industries manufacturières

    Où se situe SIDNEY C BANKS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    500 Larkshall Road
    Highams Park
    E4 9HH London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SIDNEY C BANKS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour SIDNEY C BANKS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 avr. 2012

    3 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Comptes annuels établis au 31 mai 2011

    11 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Knowle Hill Park Fairmile Lane Cobham Surrey KT11 2PD le 01 nov. 2011

    1 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 oct. 2011

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 oct. 2011

    État du capital au 12 oct. 2011

    • Capital: GBP 2,412,276.25
    SH01

    Nomination de Christopher Nigel Wade en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Dudley Tuppin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2010

    11 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mai 2009

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robin David Thurston le 14 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Dudley Michael Tuppin le 05 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2008

    10 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mai 2007

    10 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mai 2006

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de SIDNEY C BANKS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THURSTON, Robin David
    Leigh House
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    Leigh House
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    British579830002
    THURSTON, Robin David
    Leigh House
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Leigh House
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    EnglandBritishSolicitor579830002
    WADE, Christopher Nigel
    Larkshall Road
    Highams Park
    E4 9HH London
    500
    Administrateur
    Larkshall Road
    Highams Park
    E4 9HH London
    500
    EnglandBritishFinancial Controller Uk & Ireland155613630001
    THOMSON, Colin Newman
    16 Rutland Gardens
    SG19 1JG Sandy
    Bedfordshire
    Secrétaire
    16 Rutland Gardens
    SG19 1JG Sandy
    Bedfordshire
    British36211260001
    ADAMS, Michael James
    Enmill Cottage
    Pitt
    SO22 5QR Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Enmill Cottage
    Pitt
    SO22 5QR Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishExport Director71786450002
    AITCHISON, Kenneth Mark
    Wrays Cottage Wrays Yard
    Nocton
    LN4 2BG Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    Wrays Cottage Wrays Yard
    Nocton
    LN4 2BG Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritishBusiness Unit Leader121313510001
    ALLISON, Stuart Conyers
    Hambleton
    Wellcreek Road
    PE14 8PE Outwell
    Norfolk
    Administrateur
    Hambleton
    Wellcreek Road
    PE14 8PE Outwell
    Norfolk
    United KingdomBritishFertilizer Director14745230001
    BANKS, Michael Charles
    Manor Farm
    Waresley
    SG19 3BX Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    Manor Farm
    Waresley
    SG19 3BX Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritishAgricultural Merchant2418970001
    BANKS, Michael Charles
    Manor Farm
    Waresley
    SG19 3BX Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    Manor Farm
    Waresley
    SG19 3BX Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritishAgricultural Merchant2418970001
    BANKS, Richard Lewin
    Chestnut House
    Mill Lane
    SG19 1NH Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    Chestnut House
    Mill Lane
    SG19 1NH Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritishAgricultural Merchant1724090001
    BURR, John Perry Underwood
    Green Acres Cleat Hill
    Ravensden
    MK41 8AN Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    Green Acres Cleat Hill
    Ravensden
    MK41 8AN Bedford
    Bedfordshire
    BritishNon Executive Director31334010001
    DE BRAAL, Peter
    Homelands 33 Elveley Drive
    West Ella
    HU10 7RT Hull
    Administrateur
    Homelands 33 Elveley Drive
    West Ella
    HU10 7RT Hull
    United KingdomDutchAccountant58740570001
    HOLBEN, Robert Leslie
    34 Fulton Crescent
    CM23 5DA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    34 Fulton Crescent
    CM23 5DA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director Of A Cereal & Pulse Mill18187220001
    INGLE, John Harry
    The Old Vicarage
    Skendleby
    PE23 4QA Spilsby
    Linconshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Skendleby
    PE23 4QA Spilsby
    Linconshire
    United KingdomBritishGrain Trader86586740001
    MITCHELL INNES, Alistair Campbell
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director1386650001
    ODAM, Joseph
    Haynes Farm Thorney Road
    Eye
    PE6 7UA Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Haynes Farm Thorney Road
    Eye
    PE6 7UA Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishNon Executive Director2419000001
    PARRINGTON, Stewart
    12 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    Administrateur
    12 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    BritishSales Director39528640001
    PATEMAN, Neil
    Mead Cottage Chapel Yard
    Bedford Road, Pertenhall
    MK44 2AN Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    Mead Cottage Chapel Yard
    Bedford Road, Pertenhall
    MK44 2AN Bedford
    Bedfordshire
    BritishSeed Director71786500001
    ROWLANDS, John Lewis
    The Elms
    Lucas Lane Ashwell
    SG7 5LN Baldock
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Elms
    Lucas Lane Ashwell
    SG7 5LN Baldock
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director2950030001
    SILLS, Timothy Michael
    Church End
    Tempsford
    SG19 2AW Sandy
    Beds
    Administrateur
    Church End
    Tempsford
    SG19 2AW Sandy
    Beds
    EnglandBritishSolicitor3826710001
    THOMPSON, John William
    4 Walsingham Drive
    Corby Glen
    NG33 4TA Grantham
    Lincolnshire
    Administrateur
    4 Walsingham Drive
    Corby Glen
    NG33 4TA Grantham
    Lincolnshire
    BritishAccountant81105810002
    TUPPIN, Dudley Michael
    Knowle Hill Park
    Fairmile Lane
    KT11 2PD Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Knowle Hill Park
    Fairmile Lane
    KT11 2PD Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishUk Tax Manager55462810002
    WAKEHAM, Michael George
    The Old Vicarage
    Coldham
    PE14 0L2 Wisbech
    Cambs
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Coldham
    PE14 0L2 Wisbech
    Cambs
    BritishCrop Protection Specialist13407620001
    WHITLOCK, Richard Thomas
    Mill End
    Potton Road Wrestlingworth
    SG19 2EZ Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    Mill End
    Potton Road Wrestlingworth
    SG19 2EZ Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritishGrain Trader149453680001
    WOLFF, Stephen Andrew
    57 Needingworth Road
    St Ives
    PE17 4JT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    57 Needingworth Road
    St Ives
    PE17 4JT Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishCrop Protection Director2950080001

    SIDNEY C BANKS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge
    Créé le 08 mars 2001
    Livré le 28 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of fist fixed charge all book debts and other debts now and from titme to time due or owing to the company. The company shall pay into the company's account with the bank all moneys which it may receive in respect of the book debts and other debts charged under the deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge over stock
    Créé le 08 mars 2001
    Livré le 28 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The stock in trade of the company of every description whatever and wherever in the world, present and future, including each or any item of such stock in trade.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of pledge,hypothecation,charge and assignment
    Créé le 01 déc. 1997
    Livré le 16 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letter
    Brèves mentions
    All negotiable instruments of any description all bills of lading sea waybills warrants all other documents of title the benefit of all policies and certificated of insurance all produce and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SIDNEY C BANKS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 juil. 2012Dissolved on
    26 oct. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Anthony John Sanderson
    500 Larkshall Road
    Highams Park
    E4 9HH London
    practitioner
    500 Larkshall Road
    Highams Park
    E4 9HH London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0