MARKETFORCE (U.K.) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MARKETFORCE (U.K.) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00499150 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MARKETFORCE (U.K.) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Quay House The Ambury BA1 1UA Bath England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MARKETFORCE (U.K.) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MARKETFORCE (U.K.) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 juil. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 23 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 juil. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MARKETFORCE (U.K.) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2024 | 3 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Andrew John Thomas en tant que directeur le 21 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2023 | 3 pages | AA | ||
Nomination de Mr Andrew John Thomas en tant qu'administrateur le 01 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Penelope Anne Ladkin-Brand en tant que directeur le 01 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Oliver James Foster en tant que directeur le 01 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Adrian John Hughes en tant que directeur le 28 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr David John Bateson en tant qu'administrateur le 31 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr David John Bateson en tant que secrétaire le 30 mai 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mr Oliver James Foster en tant qu'administrateur le 30 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2022 | 3 pages | AA | ||
Nomination de Robert William Tompkins en tant qu'administrateur le 18 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de Ti Media Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juil. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||
Notification de Future Holdings 2002 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juil. 2022 | 2 pages | PSC02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Penelope Anne Ladkin-Brand en tant qu'administrateur le 01 nov. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2021 | 3 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Rachel Bernadette Addison en tant que directeur le 31 oct. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2020 | 3 pages | AA | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 3 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Marcus Alvin Rich en tant que directeur le 26 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de MARKETFORCE (U.K.) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATESON, David John | Secrétaire | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | 309658810001 | |||||||
| BATESON, David John | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 309682790001 | |||||
| TOMPKINS, Robert William | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 303888570001 | |||||
| GORE, John Francis | Secrétaire | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Secrétaire | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Secrétaire | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| REDPATH, John | Secrétaire | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Secrétaire | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| FORMPART (NO 2) LIMITED | Secrétaire | 6 Chesterfield Gardens W1A 1EJ London | 1327670003 | |||||||
| ADDISON, Rachel Bernadette | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | United Kingdom | British | 250816460001 | |||||
| ALEY, William Robert | Administrateur | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ASHLEY, Allan | Administrateur | 23 Wisbech Way Hordle SO41 0YQ Lymington Hampshire | British | 41081350002 | ||||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Administrateur | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Administrateur | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Administrateur | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Administrateur | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Administrateur | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| CALLAGHAN, Sara - Jane | Administrateur | 67 New Road SL5 8PZ Ascot Berkshire | British | 60080200001 | ||||||
| CULLEN, John Edward | Administrateur | 9 The Paddocks CM8 2DR Witham Essex | British | 40833580001 | ||||||
| D'EMIC, Susana Alves | Administrateur | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United States | American | 265525580001 | |||||
| DAVIDSON, Nigel James | Administrateur | Luton Cottage The Street Selling ME13 9RQ Faversham Kent | British | 18237320001 | ||||||
| DIXON, Leslie | Administrateur | Belmont House Tonbridge Road Mereworth ME18 5JE Maidstone Kent | United Kingdom | British | 830710002 | |||||
| EVANS, Richard John | Administrateur | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Administrateur | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 | |||||
| FLAVELL, David Alan | Administrateur | 32 Heatherdene Road SM6 0TB Wallington Surrey | British | 40558400001 | ||||||
| FLOCKHART, Neil | Administrateur | 50 Claygate Road Ealing W13 9XG London | United Kingdom | British | 75666300001 | |||||
| FOSTER, Oliver James | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 280151610001 | |||||
| GORE, John Francis | Administrateur | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 352680001 | |||||
| GREEN, Alan Roger | Administrateur | 1 Waverley Drive South Wonston SO21 3EF Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 46528930001 | |||||
| GREENE, David Alexander | Administrateur | 8 Holmwood Gardens N3 3NS London | England | British | 60014270001 | |||||
| HIRST, Stephen | Administrateur | 14 Goodyers Avenue WD7 8BA Radlett Hertfordshire | England | British | 110030870002 | |||||
| HUGHES, Adrian John | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | United Kingdom | British | 117233090001 | |||||
| JACKSON, Terence | Administrateur | 9 Curtis Croft Shenley Brook End MK5 7ET Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | 68206890001 | |||||
| LADKIN-BRAND, Penelope Anne | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 288978380002 | |||||
| LUCAS, Christina Nora | Administrateur | Briar Cottage River Road Taplow SL6 0BG Maidenhead Berkshire | British | 95457330002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MARKETFORCE (U.K.) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Holdings 2002 Limited | 01 juil. 2022 | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Sapphire Topco Limited | 15 mars 2018 | Marsh Wall E14 9AP London 161 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ti Media Limited | 06 avr. 2016 | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Time Inc. | 06 avr. 2016 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street 19801 Wilmington C/O The Corporation Trust Company De United States | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0