WILLIAM CAPLE & COMPANY LIMITED

WILLIAM CAPLE & COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWILLIAM CAPLE & COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00501084
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WILLIAM CAPLE & COMPANY LIMITED ?

    • (2222) /

    Où se situe WILLIAM CAPLE & COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO LLP
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WILLIAM CAPLE & COMPANY LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 oct. 2011
    Date d'échéance des prochains comptes31 juil. 2012
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour WILLIAM CAPLE & COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 janv. 2017

    14 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    14 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 mai 2016

    13 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 mai 2015

    21 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 mai 2014

    16 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 mai 2013

    20 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de * Marrons Solicitors 1 Meridian South Meridian Business Park Leicester Leicestershire LE19 1WY* le 22 juin 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    7 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 09 mai 2012

    LRESEX

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kevin Arthur Herbert le 04 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 août 2011

    État du capital au 17 août 2011

    • Capital: GBP 46,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2010

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Marrons Consultancies Limited le 17 août 2010

    1 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2009

    23 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages225

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2008

    23 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2007

    21 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de WILLIAM CAPLE & COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARRONS CONSULTANCIES LIMITED
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Leicestershire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01708508
    65475060002
    HERBERT, Kevin Arthur
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    Administrateur
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    EnglandBritishAccountant167011610001
    WHITESIDE, Robert
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    Administrateur
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director81547240001
    COX, Thomas Raymond
    20 Hawthorne Avenue
    Birstall
    LE4 4HJ Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    20 Hawthorne Avenue
    Birstall
    LE4 4HJ Leicester
    Leicestershire
    British15487340001
    GAYNOR, Peter Martin
    Manor Farm
    Smisby
    LE65 2TA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Secrétaire
    Manor Farm
    Smisby
    LE65 2TA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Irish34365940001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Secrétaire
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrishChartered Accountant96288470001
    SLOCOMBE, Philip Leslie
    Ambro Hill
    Isley Walton
    DE74 2RN Derby
    Leicestershire
    Secrétaire
    Ambro Hill
    Isley Walton
    DE74 2RN Derby
    Leicestershire
    British93774730001
    CAPLE, Robert Graham
    21 Holmfield Road
    LE2 1SD Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    21 Holmfield Road
    LE2 1SD Leicester
    Leicestershire
    BritishPrinter15487350001
    CAVE, Philip Norman
    Challow Road
    OX12 9DN Wantage
    Rose Cottage
    Oxfordshire
    Administrateur
    Challow Road
    OX12 9DN Wantage
    Rose Cottage
    Oxfordshire
    BritishCompany Director4543010001
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    Administrateur
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director51120160001
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    Administrateur
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishPrinter51120160001
    COX, Thomas Raymond
    20 Hawthorne Avenue
    Birstall
    LE4 4HJ Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    20 Hawthorne Avenue
    Birstall
    LE4 4HJ Leicester
    Leicestershire
    BritishAccountant15487340001
    CREAN, Patrick James
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    Administrateur
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    IrelandIrishAccountant54812330001
    EVERARD, Clinton Edwin
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director99667360001
    GRIFFIN, Nigel James
    7 Mill Close
    Borrowash
    DE72 3GU Derby
    Administrateur
    7 Mill Close
    Borrowash
    DE72 3GU Derby
    BritishCompany Director43577720001
    HAMBIDGE, Alan
    Brewery Cottage
    Popes Hill
    RG20 5SJ Kingsclere Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Brewery Cottage
    Popes Hill
    RG20 5SJ Kingsclere Newbury
    Berkshire
    BritishDirector56893400001
    LOANE, Beaufort Nelson
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    Administrateur
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    IrishAccountant78428900001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant96288470001
    O TIGHEARNAIGH, Cormac
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Administrateur
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant84690240001
    OCONNOR, James Oliver
    Flat 1 85 Clarendon Park Road
    LE2 3AH Leicester
    Administrateur
    Flat 1 85 Clarendon Park Road
    LE2 3AH Leicester
    IrishCompany Director43577760001
    PEAKE, Michael George
    232 Lower Hillmorton Road
    CV21 4AF Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    232 Lower Hillmorton Road
    CV21 4AF Rugby
    Warwickshire
    BritishCompany Director15487370001
    PEAKE, Michael George
    232 Lower Hillmorton Road
    CV21 4AF Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    232 Lower Hillmorton Road
    CV21 4AF Rugby
    Warwickshire
    BritishWorks Director15487370001
    SALMONS, Peter James
    1 Appleby Close
    Redhill Grange
    NN9 5YN Wellingborough
    Northamptonshire
    Administrateur
    1 Appleby Close
    Redhill Grange
    NN9 5YN Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishSales Director39684280001
    SIMMENS, Leslie
    The Grange
    Thistleton
    LE15 7RE Oakham Rutland
    Leics
    Administrateur
    The Grange
    Thistleton
    LE15 7RE Oakham Rutland
    Leics
    BritishCompany Director15487360001
    WILLIAMS, Colin Frederick
    3 Glenville Avenue
    Glenfield
    LE3 8BE Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    3 Glenville Avenue
    Glenfield
    LE3 8BE Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishPrinter15487390001

    WILLIAM CAPLE & COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 30 août 2000
    Livré le 11 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) under the banking documents,the mezzanine loan agreement and/or the senior note documents (all as defined)
    Brèves mentions
    Freehold land and buildings at moreledge st,nichols st,midland street and burton street,leicester; t/nos LT88969,LT9176,LT64969,LT32583,LT19436,LT7772,LT26083 and LT11652. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transactions
    • 11 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 14 july 2000
    Créé le 30 août 2000
    Livré le 08 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (as defined) under the banking documents, the mezzanine loan agreement and/or the senior note documents (all as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transactions
    • 08 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 avr. 1996
    Livré le 09 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks Plcin It's Capacity as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 09 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 06 juin 1995
    Livré le 13 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 13 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 19 juil. 1993
    Livré le 23 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all that f/h property being morledge street leicester with all fittings fixtures and fixed or heavy plant and machinery thereon t/nos LT9176 LT7772 LT11652 LT19436 LT32583 LT64969 LT88969 and LT26063. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V. Dublin Branch
    Transactions
    • 23 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 juil. 1993
    Livré le 23 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage over the f/h property k/a moreledge street t/nos LT9176 LT7772 LT11652 LT19436 LT32%83 LT64969 LT88969 and LT26063 and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 avr. 1975
    Livré le 12 avr. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings or north side of midlands street, leicester.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 1975Enregistrement d'une charge
    • 17 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Instrument of charge
    Créé le 28 janv. 1970
    Livré le 13 févr. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    11 + 11.5 mcreedge street, 1,3,5,7,9, burton street, leicester, 2 midland st, leicester.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 1970Enregistrement d'une charge
    • 17 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Inst of charge
    Créé le 03 mai 1962
    Livré le 24 mai 1962
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc
    Brèves mentions
    Factory in burton street leicester (see doc 24 for details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 1962Enregistrement d'une charge
    • 17 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WILLIAM CAPLE & COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 mai 2012Commencement of winding up
    18 avr. 2017Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark James Shaw
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0