EUROHIKE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEUROHIKE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00502385
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EUROHIKE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe EUROHIKE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o KPMG LLP
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EUROHIKE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    R.& A.MILLETT(SHOPS)LIMITED15 déc. 195115 déc. 1951

    Quels sont les derniers comptes de EUROHIKE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 févr. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour EUROHIKE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 14 déc. 2012

    21 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 02 janv. 2013

    21 pages2.35B

    Résultat de la réunion des créanciers

    28 pages2.23B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 juil. 2012

    18 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    30 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    25 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B/2.15B

    8 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de 440-450 Cob Drive Swan Valley Northampton Northamtonshire NN4 9BB le 24 janv. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination de Marcello Lombardo en tant que directeur le 16 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Dominic Joseph Lavelle en tant qu'administrateur le 21 nov. 2011

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 oct. 2011

    État du capital au 03 oct. 2011

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 févr. 2011

    4 pagesAA

    Nomination de Ms Julia Reynolds en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Hitt en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Derrick Beacham en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 févr. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard John Hitt le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Mark Derrick Beacham le 01 oct. 2009

    3 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Marcello Lombardo le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de EUROHIKE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEACHAM, Mark Derrick
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    Secrétaire
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    British135313320001
    BEACHAM, Mark Derrick
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    United KingdomBritish160095260001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    United KingdomBritish137285750001
    REYNOLDS, Julia
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    EnglandBritish127468460001
    FOOT, Peter John Lewis
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    British51176110002
    HALL, Vikki
    28 Burman Drive
    Coleshill
    B46 3NB Birmingham
    Secrétaire
    28 Burman Drive
    Coleshill
    B46 3NB Birmingham
    British82602670001
    HEATHER, John Langdale
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    British33307810001
    O'KEEFFE, Mark John
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    Secrétaire
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    British57880430001
    PILLAY, Paul Vijayasingam
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Secrétaire
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Other79416150001
    SIMKINS, Paul Charles
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    Secrétaire
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    British37115350001
    SEARS SPORTS AND LEISUREWEAR PLC
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    Secrétaire
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    16600870001
    ASTLEY, Brian Martin
    25 Marjorie Grove
    SW11 5SH London
    Administrateur
    25 Marjorie Grove
    SW11 5SH London
    British75795040001
    CHAMBERLAIN, Adrian
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    British117106730001
    CROSLAND, Roy Nicholson
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    Administrateur
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    British30882970002
    FALLON, John Edward
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    Administrateur
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    British52124910001
    FLEMING, Keith
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish112723440002
    FOOT, Peter John Lewis
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    British51176110002
    HARDY, Russell Stephen Mons
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish45844210003
    HARTLEY, Peter Christopher
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    Administrateur
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    United KingdomBritish96458190001
    HITT, Richard John
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamtonshire
    Administrateur
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamtonshire
    United KingdomBritish127468180001
    JONES, Anthony David
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    Administrateur
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    British41640680002
    LOASBY, Andrew
    11 Nene Close
    NN8 5WB Wellingborough
    Northamptonshire
    Administrateur
    11 Nene Close
    NN8 5WB Wellingborough
    Northamptonshire
    British48081840001
    LOMBARDO, Marcello
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamtonshire
    Administrateur
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamtonshire
    EnglandBritish135699240001
    MALONE, Desmond Philip
    1 Morpeth
    B77 1JF Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    1 Morpeth
    B77 1JF Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritish87170450001
    MAYWOOD, Terry Osborn
    Longston House
    School Lane Islip
    NN14 3LQ Kettering
    Northamptonshire
    Administrateur
    Longston House
    School Lane Islip
    NN14 3LQ Kettering
    Northamptonshire
    British39631730004
    MEEHAN, Andrew David
    Southview Church Lane
    Lighthorne
    CV35 0AT Warwick
    Administrateur
    Southview Church Lane
    Lighthorne
    CV35 0AT Warwick
    EnglandBritish62737150001
    SHEATH, Christopher Gordon
    Avonlea
    Hop Gardens, Whiteparish
    SP5 2SS Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Avonlea
    Hop Gardens, Whiteparish
    SP5 2SS Salisbury
    Wiltshire
    British69543550002
    STAINES, Michael John
    4 Fleetwind Drive
    NN4 0ST Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    4 Fleetwind Drive
    NN4 0ST Northampton
    Northamptonshire
    British16626330001
    VICKERS, Alan Christopher
    The Ashes 8 Cross Hedge
    Rothley
    LE7 7RR Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    The Ashes 8 Cross Hedge
    Rothley
    LE7 7RR Leicester
    Leicestershire
    British1971520001

    EUROHIKE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 04 mars 1996
    Livré le 13 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities and obligations due or to become due from the company and any group company to the chargees pursuant to the terms of the hedging arrangements and the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 13 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 05 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 08 juil. 1986
    Livré le 10 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 10,12,14,16 car street, ipswich and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 06 juin 1986
    Livré le 10 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold 17-18 high street, colchester and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 12 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 mai 1986
    Livré le 19 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises known as unit 49 arndale centre manchester and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 09 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 mai 1986
    Livré le 30 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property known as 24 market square, northampton and/or proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 09 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 févr. 1986
    Livré le 27 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    29 linthorpe road middlesborough cleveland and/or the proceeds of sale thereof, together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 31 janv. 1986
    Livré le 04 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 35 union street, birmingham and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 17 janv. 1986
    Livré le 23 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 105 market jew street, penzance, cornwall, t/no cl 22334 and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 01 nov. 1985
    Livré le 04 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 24 cricklade street, cirencester and/or proceeds of thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 01 nov. 1985
    Livré le 07 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H shop unit 1, 66/82 the broadway west ealing london and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 01 nov. 1985
    Livré le 07 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 193 high st, bromley kent, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 01 nov. 1985
    Livré le 07 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 21 friary st, guildford surrey, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 12 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 nov. 1985
    Livré le 07 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 50, 52 & 54 high street and 53, 54 surrey street, croydon and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 27 août 1985
    Livré le 29 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 6 market street, york and/or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 août 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 16 août 1985
    Livré le 19 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 49 market street crewe and/or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 12 août 1985
    Livré le 14 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 53 sedney street cambridge and/or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 07 août 1985
    Livré le 09 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 146 high street, erdington and/or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 07 août 1985
    Livré le 09 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 82/84 mersey way stockport and/or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 07 août 1985
    Livré le 14 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 16 new street, huddersfield and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 16 juil. 1985
    Livré le 18 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H. 25 the mall shopping centre. Burnley and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 29 juin 1985
    Livré le 10 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lh 86/88 high street, watford and the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 29 juin 1985
    Livré le 10 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lh 16 market place and 5 dolphin lane and the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 25 juin 1985
    Livré le 27 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lh 71 london road north lowestoft, suffolk and the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 juin 1985Enregistrement d'une charge
    • 09 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 juin 1985
    Livré le 27 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lh 26 st. Andrews street, cambridge and the proceeds.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 juin 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 17 juin 1985
    Livré le 20 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 28-30 strait bargate, boston and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 1985Enregistrement d'une charge

    EUROHIKE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 janv. 2013Administration ended
    09 janv. 2012Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0