J.T. BROADHURST & SONS LIMITED

J.T. BROADHURST & SONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJ.T. BROADHURST & SONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00507041
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de J.T. BROADHURST & SONS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe J.T. BROADHURST & SONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sirius House, Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de J.T. BROADHURST & SONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour J.T. BROADHURST & SONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mars 2016

    État du capital au 08 mars 2016

    • Capital: GBP 1,800
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 mars 2015

    État du capital au 13 mars 2015

    • Capital: GBP 1,800
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 mars 2014

    État du capital au 10 mars 2014

    • Capital: GBP 1,800
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de J.T. BROADHURST & SONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TINSLEY, Christopher John
    Sirius House, Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    Sirius House, Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Cheshire
    163072720001
    SHEPPARD, Christopher Phillip
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    EnglandBritishCompany Director151399580001
    STINSON, Neil Andrew
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant163072150001
    ARMER, Peter Thomas
    16 Heysham Avenue
    Heysham
    LA3 2DH Morecambe
    Lancashire
    Secrétaire
    16 Heysham Avenue
    Heysham
    LA3 2DH Morecambe
    Lancashire
    British71912780003
    CALLAGHAN, Peter John
    Penn Oast Manor Lane
    Hollingbourne
    ME17 1UN Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    Penn Oast Manor Lane
    Hollingbourne
    ME17 1UN Maidstone
    Kent
    British25043970001
    HUGHES, Michael Blake
    209 Newcastle Road
    ST15 8LF Stone
    Staffordshire
    Secrétaire
    209 Newcastle Road
    ST15 8LF Stone
    Staffordshire
    BritishAccountant77731090003
    INGALL, David James
    31 Marlborough Avenue
    SK8 7AP Cheadle Hulme
    Cheshire
    Secrétaire
    31 Marlborough Avenue
    SK8 7AP Cheadle Hulme
    Cheshire
    BritishSecretary50988810002
    MAHER, Michael John
    7 Cae Eithin
    Lixwm
    CH8 8NB Holywell
    Clwyd
    Secrétaire
    7 Cae Eithin
    Lixwm
    CH8 8NB Holywell
    Clwyd
    BritishCompany Secretary110531730001
    SHEPPARD, Phillip Robert
    15 Broadhalgh Avenue
    Bamford
    OL11 5LW Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    15 Broadhalgh Avenue
    Bamford
    OL11 5LW Rochdale
    Lancashire
    British6443270001
    STINSON, Neil Andrew
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    British130992930001
    WARREN, Nicholas
    15 Chaddock Lane
    Boothstown
    M28 1DB Worsley
    Secrétaire
    15 Chaddock Lane
    Boothstown
    M28 1DB Worsley
    British79704130002
    WARREN, Nick
    88 Derbyshire Lane
    Stretford
    M32 8DR Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    88 Derbyshire Lane
    Stretford
    M32 8DR Manchester
    Lancashire
    BritishAccountant69209510001
    ILES, Colin David
    75 1 Myrtle Ave
    Edgewater
    New Jersey 07020
    Usa
    Administrateur
    75 1 Myrtle Ave
    Edgewater
    New Jersey 07020
    Usa
    BritishDirector48986000008
    SHEPPARD, Phillip Robert
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector6443270001
    SHEPPARD, Robin
    15 Chepstow Close
    Bamford
    OL11 5TR Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    15 Chepstow Close
    Bamford
    OL11 5TR Rochdale
    Lancashire
    BritishDirector6443290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur J.T. BROADHURST & SONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Delta Crescent
    Westbrook
    WA5 7NS Warrington
    Sirius House
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05721604
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    J.T. BROADHURST & SONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 03 mai 2000
    Livré le 16 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by any chargor (including the company) to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly and severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise)(all terms as defined)
    Brèves mentions
    Legal mortgage all real property in england and wales (including that described in the schedule to the 395) belonging to it at the date of the debenture; fixed equitable charge all other real property belonging to it at the date of the debenture and all real property acquired by it thereafter; and fixed charge,all its present and future: (I) book debts;(ii) bank accounts;(iii) investments;(iv) insurances; (v) uncalled capital and goodwill; (vi) intellectual property; (vii) plant and machinery.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 16 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 juil. 1997
    Livré le 14 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as land at spon lane locks, west bromwich west midlands title number WM512199.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 déc. 1994
    Livré le 28 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at kelvin way grice street and spon lane locks west bromwich west midlands t/n-WM455790.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 déc. 1994
    Livré le 28 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at kelvin way grice street and spon lane locks west bromwich west midlands t/n-WA412858.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 29 nov. 1994
    Livré le 14 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 1994
    Livré le 13 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at kelvin way, grice street and spon lane locks west bromwich west midlands t/n-WM540 WM332057.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second fixed and floating charge
    Créé le 29 nov. 1994
    Livré le 08 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from nobledrift limited to the chargee pursuant to clause 3.5.1 of a share sale agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert Cooper"the Parties"
    Transactions
    • 08 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 05 juin 1992
    Livré le 10 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company ; and all patents patent applications inventions trade marks trade names registered designs coyrights know how and other intellectual property rights and all licences and ancillary rights and benefits including all royalties fees and other income deriving from the same both present and future of the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 oct. 1989
    Livré le 19 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property situate at kelvin way, west bromwich, west midlands (see 395 for details).
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 19 oct. 1989Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 déc. 1988
    Livré le 07 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H & l/h property k/a kelvin way, west bromwich, west midlands.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1989Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 22 déc. 1988
    Livré le 07 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges and undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1989Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 avr. 1988
    Livré le 27 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the west of arice street west bromwich west midlands t/n wm 332057.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 24 juin 1987
    Livré le 03 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the south side of spon lane locks, sandwell west midlands.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 16 nov. 1965
    Livré le 23 nov. 1965
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc.
    Brèves mentions
    23/29 (odd nos) pritchett street,aston,birmingham 6.works.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 nov. 1965Enregistrement d'une charge
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0