MINET LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMINET LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00513938
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MINET LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MINET LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Devonshire Square
    London
    EC2M 4PL
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MINET LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    J.H.MINET & CO.LIMITED05 déc. 195205 déc. 1952

    Quels sont les derniers comptes de MINET LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour MINET LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA
    RB4MI5GH

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Paul Francis Clayden en tant que directeur le 21 sept. 2012

    1 pagesTM01
    X1JOOBQG

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A1HX3XBE

    État du capital au 17 sept. 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19
    A1HHQWJU

    legacy

    1 pagesSH20
    Q1HHGOP5

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    Q1HHGOOX

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 14/09/2012
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    X1EE4D1D

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    15 pagesAA
    A5PLPXX8

    Nomination de Paul Arthur Hogwood en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    XG7R6WKX

    Cessation de la nomination de Yvonne Fisher en tant que directeur

    1 pagesTM01
    XFJCQWJC

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    X6KMVVSR

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    2 pagesAD04
    AEH97P6G

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    AV048M8B

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    16 pagesAA
    AW4KOM59

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    2 pagesAD03
    A1P6PLR7

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02
    A1P6OLR6

    Nomination de Yvonne Jane Fisher en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    AGDFQKWO

    Nomination de Stephen Dudley Gale en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    AGDG4KW3

    Cessation de la nomination de Edward Cruttwell en tant que directeur

    2 pagesTM01
    AJCMJKRL

    Cessation de la nomination de Michael Heap en tant que directeur

    2 pagesTM01
    AQQG3IMD

    legacy

    6 pages363a
    P88JACDN

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    15 pagesAA
    AVMGIBEE

    Qui sont les dirigeants de MINET LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COSEC 2000 LIMITED
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Secrétaire
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    64208180001
    GALE, Stephen Dudley
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United KingdomBritishTax Accountant152013590001
    HOGWOOD, Paul Arthur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary7453920004
    ALLAM, Richard John
    Rose Cottage Tower Hill
    Offham
    ME19 5NH West Malling
    Kent
    Secrétaire
    Rose Cottage Tower Hill
    Offham
    ME19 5NH West Malling
    Kent
    British13466180001
    ASPINALL, Nicholas
    45 Southdean Gardens
    Wimbledon
    SW19 6NT London
    Secrétaire
    45 Southdean Gardens
    Wimbledon
    SW19 6NT London
    BritishSolicitor29662910003
    BEGLEY, John Patrick
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Administrateur
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    BritishAccountant110985340001
    CHRISTIE, Peter Steele
    36 Lonsdale Square
    Islington
    N1 1EW London
    Administrateur
    36 Lonsdale Square
    Islington
    N1 1EW London
    BritishInsurance Broker65068940003
    CLAYDEN, Paul Francis
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United KingdomBritishAccountant138098080001
    COTTERILL, Paul
    4 Banckside
    Hartley
    DA3 7RD Longfield
    Kent
    Administrateur
    4 Banckside
    Hartley
    DA3 7RD Longfield
    Kent
    BritishInsurance Broker5479100001
    CRUTTWELL, Edward Robert Charles
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    BritishExecutive Director Finance And34367480002
    CRUTTWELL, Edward Robert Charles
    Skurrays
    Petteridge Lane
    TN12 7LT Matfield
    Kent
    Administrateur
    Skurrays
    Petteridge Lane
    TN12 7LT Matfield
    Kent
    BritishDirector/Admin Services34367480001
    DESAI, Vinodrai Kikubhai
    Treetops
    299 Beulah Hill
    SE19 3UZ Upper Norwood
    London
    Administrateur
    Treetops
    299 Beulah Hill
    SE19 3UZ Upper Norwood
    London
    EnglandBritishFinance Executive34312730001
    DIXEY, Charles Richard
    Upper Shelspit Farm
    MK18 2DY Thornborough
    Bucks
    Administrateur
    Upper Shelspit Farm
    MK18 2DY Thornborough
    Bucks
    BritishInsurance Broker50281920001
    FISHER, Yvonne Jane
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    England
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    England
    EnglandBritishCompany Secretary152086390001
    GILBERT, Stephen Harry
    Whitedown South Hanningfield Road
    South Hanningfield
    CM3 8HJ Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Whitedown South Hanningfield Road
    South Hanningfield
    CM3 8HJ Chelmsford
    Essex
    BritishInsurance Broker25975470002
    GILBERT, Stephen Harry
    Whitedown South Hanningfield Road
    South Hanningfield
    CM3 8HJ Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Whitedown South Hanningfield Road
    South Hanningfield
    CM3 8HJ Chelmsford
    Essex
    BritishInsurance Broker25975470002
    HATTON, Robert William
    29 Forden Avenue
    Westmount
    H37 Montreal
    Quebec
    Administrateur
    29 Forden Avenue
    Westmount
    H37 Montreal
    Quebec
    CanadianInsurance Broker9411480001
    HAYES, Bryan Joseph
    1 Abbotts Court Thackeray Street
    W8 4AL London
    Administrateur
    1 Abbotts Court Thackeray Street
    W8 4AL London
    IrishLloyds Insurance Broker49014750001
    HEAP, Michael Conrad
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    BritishUk Financial Controller93892910002
    HILL, John Lawrence
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Administrateur
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    BritishChmn Management Services663680003
    HILL, John Lawrence
    Bramley Farm House
    Romford Road Pembury
    TN2 4BA Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Bramley Farm House
    Romford Road Pembury
    TN2 4BA Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChmn-Management Services663680001
    HOPE, Duncan Patrick Nicholson
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Administrateur
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    BritishSolicitor110985300001
    MACGREGOR, Alpin Findanus
    79 Stockwell Park Road
    SW9 0DB London
    Administrateur
    79 Stockwell Park Road
    SW9 0DB London
    United KingdomBritishChartered Accountant45926520001
    MCGRISKIN, James Reilly
    4 Thomas Place
    W8 5UG London
    Administrateur
    4 Thomas Place
    W8 5UG London
    BritishInsurance Broker52234580001
    MURRAY, Richard Henry
    54 Bedford Gardens
    Kensington
    W8 7EH London
    Administrateur
    54 Bedford Gardens
    Kensington
    W8 7EH London
    AmericanInsurance Broker40103250001
    ORAM, William John
    8 Devonshire Square
    EC4M 2PL London
    Administrateur
    8 Devonshire Square
    EC4M 2PL London
    United KingdomOtherChartered Accountant98212820001
    PARMENTER, Michael Peter
    65 Woodlands Road
    SS5 4PY Hockley
    Essex
    Administrateur
    65 Woodlands Road
    SS5 4PY Hockley
    Essex
    BritishOperations Director58496290002
    QUICK, Stephen John
    27 St Marys Road
    Wimbledon
    SW19 7BT London
    Administrateur
    27 St Marys Road
    Wimbledon
    SW19 7BT London
    BritishInsurance Broker44268960001
    REID, Michael Montgomery
    5 The Coppice Bitchet Green
    Seal
    TN15 0NB Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    5 The Coppice Bitchet Green
    Seal
    TN15 0NB Sevenoaks
    Kent
    BritishChief Operating Officer Servic62555650001
    ROBERTS, Julian Victor Frow
    27 Fairway
    Merrow
    GU1 2XJ Guildford
    Surrey
    Administrateur
    27 Fairway
    Merrow
    GU1 2XJ Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director57259630001
    ROSSOR, Michael Keith
    72 Links Way
    Eden Park
    BR3 3DQ Beckenham
    Kent
    Administrateur
    72 Links Way
    Eden Park
    BR3 3DQ Beckenham
    Kent
    BritishChartered Accountant55457000001
    WALL, David Neil
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Administrateur
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    BritishChartered Accountant25408090002
    WALL, David Neil
    Wythburn
    3 Park Avenue
    AL1 4PB St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Wythburn
    3 Park Avenue
    AL1 4PB St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant25408090001

    MINET LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of variation made between minet limited and lloyd's containing a second floating charge and modifying the security and trust deed dated 19TH september 1989 between the parties aforesaid both deeds being pursuant to the lloyd's brokers byelaw (no 5 of 1988) (the byelaw)
    Créé le 04 juin 1997
    Livré le 12 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security and trust deed dated 19TH september 1989 and the deed of variation
    Brèves mentions
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets (as defined in the byelaw). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's as Trustee for Approved Banks (As Defined)
    Transactions
    • 12 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security & trust deed.
    Créé le 19 sept. 1989
    Livré le 26 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of all debts and obligations for the time being due, owing or incurred, whether actually or contingently, by the company to lloyd's in respect of insurance transactions.
    Brèves mentions
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyd's brokers byelaw (no.5 Of 1988) (for full details see doc M43C).
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's
    Transactions
    • 26 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 24 févr. 1983
    Livré le 04 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All the company's right, title interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account at the date of the trust deed, & in the monies & investments at the date of the trust deed standing to the credit of or held in other iba accounts of the company or from time to time after such date received by the company from any source (see doc M83).
    Personnes ayant droit
    • The Corporation of Lloyd's
    Transactions
    • 04 mars 1983Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 21 juin 1976
    Livré le 30 juin 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    66, prescot street, tower hamlets, london E1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • International Westminster Bank LTD And
    • County Bank LTD
    Transactions
    • 30 juin 1976Enregistrement d'une charge
    • 01 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 juin 1976
    Livré le 30 juin 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    84/100 leman street, tower hamlets, london E1.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • International Westminster Bank LTD And
    • County Bank LTD.
    Transactions
    • 30 juin 1976Enregistrement d'une charge
    • 01 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0