WOLSELEY HAWORTH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWOLSELEY HAWORTH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00514573
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WOLSELEY HAWORTH LIMITED ?

    • Agents de commerce de bois et de matériaux de construction (46130) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe WOLSELEY HAWORTH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    Warwickshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WOLSELEY HAWORTH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MURDOCK HAWORTH LIMITED27 avr. 200527 avr. 2005
    W.B.HAWORTH LIMITED24 déc. 195224 déc. 1952

    Quels sont les derniers comptes de WOLSELEY HAWORTH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour WOLSELEY HAWORTH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2018

    17 pagesAA

    Modification des détails de Wolseley Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 déc. 2018

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées de l'administrateur Wolseley Uk Directors Limited le 03 déc. 2018

    1 pagesCH02

    Changement d'adresse du siège social de The Wolseley Center Harrison Way Leamington Spa CV31 3HH United Kingdom à 2 Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill Warwick Warwickshire CV34 6DY le 03 déc. 2018

    1 pagesAD01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 29 juin 2018

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Vanessa French en tant que secrétaire le 31 mai 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Katherine Mary Mccormick en tant que secrétaire le 31 mai 2018

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Simon Gray en tant qu'administrateur le 01 mars 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Louise Hancox en tant que directeur le 02 mars 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2017

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2016

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Marc Arthur Ronchetti en tant que directeur le 29 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Dr Elizabeth Louise Hancox en tant qu'administrateur le 08 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de WOLSELEY HAWORTH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCCORMICK, Katherine Mary
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    247125340001
    GRAY, Simon
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant243497760001
    WOLSELEY UK DIRECTORS LIMITED
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement09104902
    190186170001
    FARRELLY, Alan G
    12a Rock Court
    Blackrock
    Dundalk
    Louth
    Northern Ireland
    Secrétaire
    12a Rock Court
    Blackrock
    Dundalk
    Louth
    Northern Ireland
    IrishAccountant142941940001
    FRENCH, Vanessa
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    Secrétaire
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    179444610001
    MIDDLEMISS, Graham
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    British100701940002
    MURDOCK, Malachy
    Grinan Lough Road
    Warrenpoint
    Co Down
    Secrétaire
    Grinan Lough Road
    Warrenpoint
    Co Down
    IrishDirector73676560001
    PRESTON, Michael Lee
    40 Grove Road
    L45 3HN Wallasey
    Merseyside
    Secrétaire
    40 Grove Road
    L45 3HN Wallasey
    Merseyside
    British8372400001
    ASHMORE, Stephen, Mr.
    Wolseley Centre
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Wolseley Centre
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director232880380001
    FARRELLY, Alan G
    12a Rock Court
    Blackrock
    Dundalk
    Louth
    Northern Ireland
    Administrateur
    12a Rock Court
    Blackrock
    Dundalk
    Louth
    Northern Ireland
    IrelandIrishAccountant142941940001
    HANCOX, Elizabeth Louise, Dr
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    Administrateur
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant210216760001
    HARDING, Derek John
    Wolseley Centre
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Wolseley Centre
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritishAccountant152377500001
    JONES, Keith Harold Davenport
    Wolseley Centre
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Wolseley Centre
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector95915810001
    LENZ, Barbara Eleanor
    14 Bellfield Crescent
    L45 9JR Wallasey
    Merseyside
    Administrateur
    14 Bellfield Crescent
    L45 9JR Wallasey
    Merseyside
    BritishSecretary8372420001
    LENZ, Werner Emil
    14 Bellfield Crescent
    L45 9JR Wallasey
    Merseyside
    Administrateur
    14 Bellfield Crescent
    L45 9JR Wallasey
    Merseyside
    BritishBuilders Merchant8372410001
    MIDDLEMISS, Graham
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishSolicitor100701940002
    MURDOCK, Ciaran
    38 Donaghaguy Road
    Burren
    BT34 3PR Warrenpoint
    County Down
    Northern Ireland
    Administrateur
    38 Donaghaguy Road
    Burren
    BT34 3PR Warrenpoint
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrishBusinessman107959210004
    MURDOCK, Kevin
    20 Levallyreagh Road
    Rostrevor
    BT34 3DW Newry
    County Down
    Administrateur
    20 Levallyreagh Road
    Rostrevor
    BT34 3DW Newry
    County Down
    Northern IrelandIrishBusinessman68779220001
    MURDOCK, Malachy
    Grinan Lough Road
    Warrenpoint
    Co Down
    Administrateur
    Grinan Lough Road
    Warrenpoint
    Co Down
    IrishDirector73676560001
    NEVILLE, Matthew James
    9 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    9 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director85093360003
    PRESTON, Katherine
    40 Grove Road
    L45 3HN Wallasey
    Merseyside
    Administrateur
    40 Grove Road
    L45 3HN Wallasey
    Merseyside
    BritishAccountant36550980001
    PRESTON, Michael Lee
    40 Grove Road
    L45 3HN Wallasey
    Merseyside
    Administrateur
    40 Grove Road
    L45 3HN Wallasey
    Merseyside
    BritishBuilders Merchant8372400001
    PRIDEAUX, Anthony John
    The Spinney 48 Moreton Road
    Upton
    L49 4NS Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    The Spinney 48 Moreton Road
    Upton
    L49 4NS Wirral
    Merseyside
    BritishBuilders Morchant32455950002
    RONCHETTI, Marc Arthur
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    Administrateur
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director247980780001
    SIBLEY, Nigel James
    Steeple View
    Gibbins Lane
    RG42 6AP Warfield
    Berkshire
    Administrateur
    Steeple View
    Gibbins Lane
    RG42 6AP Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director148222500001
    TILLOTSON, Ian
    The Ashes
    16 Hughes Hill
    CV35 7AS Shrewley
    Warwickshire
    Administrateur
    The Ashes
    16 Hughes Hill
    CV35 7AS Shrewley
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector109050510001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WOLSELEY HAWORTH LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00636445
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WOLSELEY HAWORTH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 16 mai 2005
    Livré le 27 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as W.B. haworth limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 27 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the f/h property k/a land on the west side of cross lane, wallasey, wirral, merseyside, t/n MS359789. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 avr. 2001
    Livré le 19 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 19 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 20 juin 1997
    Livré le 05 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the west side of cross lane wallasey merseyside t/no: MS359789. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 05 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 1997
    Livré le 06 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 sept. 1993
    Livré le 01 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 sept. 1993
    Livré le 01 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situate on the westerly side of cross lane wallasey wirral merseyside containing 1.25 acres or thereabouts t/n's MS3815 and MS3816 and the proceeds of sale thereof an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 déc. 1985
    Livré le 16 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land situate & formerly the site of nos 9/11 agnes grove wallasey, merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 02 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 déc. 1985
    Livré le 16 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 12/14 withens lane, wallasey merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 02 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0