CAMEC (CREDIT) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAMEC (CREDIT) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00516085
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAMEC (CREDIT) LIMITED ?

    • Activités de jeux de hasard et de paris (92000) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe CAMEC (CREDIT) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    KPMG LLP
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAMEC (CREDIT) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MECCA BOOKMAKERS (CREDIT) LIMITED19 janv. 198819 janv. 1988
    WM. MCKEOWN & CO. LIMITED13 févr. 195313 févr. 1953

    Quels sont les derniers comptes de CAMEC (CREDIT) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour CAMEC (CREDIT) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Greenside House 50 Station Road Wood Green London N22 7TP le 17 avr. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 mars 2012

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 janv. 2012

    État du capital au 20 janv. 2012

    • Capital: GBP 654
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr Neil Cooper en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Lane en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 30 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 01 janv. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 26 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    5 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    Qui sont les dirigeants de CAMEC (CREDIT) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    READ, Dennis
    Greenside House
    50 Station Road Wood Green
    N22 7TP London
    Secrétaire
    Greenside House
    50 Station Road Wood Green
    N22 7TP London
    British125938390001
    COOPER, Neil
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector151902940001
    STEELE, Anthony David
    Greenside House
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Administrateur
    Greenside House
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    United KingdomBritishChartered Surveyor193930220001
    ANDERSON, Sarah
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Secrétaire
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    British100326820003
    BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    Secrétaire
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    British63851130001
    HOGAN, Kevin Matthew Joseph Christopher
    Willow House
    121 Upper Hoyland Road
    S74 9NL Hoyland
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Willow House
    121 Upper Hoyland Road
    S74 9NL Hoyland
    South Yorkshire
    British4502520001
    MACQUEEN, Andrea Louise
    10 Eglington Road
    Chingford
    E4 7AN London
    Secrétaire
    10 Eglington Road
    Chingford
    E4 7AN London
    British98483080001
    MOTT, Matthew John Spencer
    25 Princess Court
    105 Hornsey Lane Highgate
    N6 5XD London
    Secrétaire
    25 Princess Court
    105 Hornsey Lane Highgate
    N6 5XD London
    BritishCompany Secretary19710010002
    BROWN, John Michael
    Milford Court Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    Administrateur
    Milford Court Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    BritishCompany Director889800001
    HAYGARTH, William Leslie
    9 Hillside
    Burghfield Common
    RG7 3BQ Reading
    Berkshire
    Administrateur
    9 Hillside
    Burghfield Common
    RG7 3BQ Reading
    Berkshire
    BritishDirector11592110002
    LAMBERT, Robert
    Red Roof
    Tithe Barn Lane, Bardsey
    LS17 9DX Wetherby
    Administrateur
    Red Roof
    Tithe Barn Lane, Bardsey
    LS17 9DX Wetherby
    United KingdomBritishChartered Accountant153968320001
    LANE, Simon Paul
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Administrateur
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    BritishDirector117893540001
    MCGUIGAN, Liam John
    9 Park Drive
    Thorntonhall
    G74 5AS Glasgow
    Administrateur
    9 Park Drive
    Thorntonhall
    G74 5AS Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director62685050001
    NORRIS, Michael William
    9 Highthorne Court
    Shadwell
    LS17 8NW Leeds
    Administrateur
    9 Highthorne Court
    Shadwell
    LS17 8NW Leeds
    BritishCompany Director71004120002
    OLIVE, Stephen Gerard
    4 High Park Road
    Kew
    TW9 4BH Richmond
    Surrey
    Administrateur
    4 High Park Road
    Kew
    TW9 4BH Richmond
    Surrey
    BritishDirector38206770002
    SINGER, Thomas Daniel
    27 Observatory Road
    SW14 7QB East Sheen
    London
    Administrateur
    27 Observatory Road
    SW14 7QB East Sheen
    London
    BritishCompany Director63386730002
    SPEARING, Ian John
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Administrateur
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    BritishDirector34180750003
    WASANI, Shailen
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Administrateur
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    BritishAccountant102956140003

    CAMEC (CREDIT) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 15 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of this deed,the facility or the charge (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The William Hill Group Limited
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • William Hill Organization Limited
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank Plcaries(As Defined)as Agent and Trustee for Itself and the Benefici
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The William Hill Group Limited
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental charge
    Créé le 30 mars 1992
    Livré le 03 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of clause 2 of the deed asdefined in this charge
    Brèves mentions
    See form 395 ref M203 for full details. All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of guarantee and charge
    Créé le 21 déc. 1989
    Livré le 10 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all freehold and leasehold property and rights. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of guarantee and charge
    Créé le 21 déc. 1989
    Livré le 10 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all freehold and leasehold property and rights. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limitedas Defined)(As Trustee for Itself and for the Other Banks,
    Transactions
    • 10 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CAMEC (CREDIT) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 oct. 2012Dissolved on
    30 mars 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0