UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED

UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéUNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société 00516140
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?

    • Activités des organisations religieuses (94910) / Autres activités de services

    Où se situe UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    305 Ballards Lane
    N12 8GB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au04 juil. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation18 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au04 juil. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023

    2 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Tristan Howard Nagler en tant qu'administrateur le 17 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Simon Anthony Mitchell en tant qu'administrateur le 17 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Barry Clive Shaw en tant que directeur le 17 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Howard Eric Eder en tant que directeur le 17 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Jacqueline Malca Zinkin le 16 déc. 2021

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    2 pagesAA

    Nomination de Mrs Rachel Irma Hartog en tant qu'administrateur le 19 juil. 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Dr Nicola Abigail Rosenfelder en tant qu'administrateur le 22 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Jacqueline Malca Zinkin en tant qu'administrateur le 22 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Leonie Lewis en tant que directeur le 22 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Doreen Sandra Samuels en tant que directeur le 22 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Nomination de Mr Saul David Taylor en tant qu'administrateur le 02 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FREI, Saul David
    109 Princes Park Avenue
    NW11 0JS London
    Secrétaire
    109 Princes Park Avenue
    NW11 0JS London
    British,Solicitor96453010001
    GOLDSTEIN, Michael Howard
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    EnglandBritishChartered Accountant235899600001
    HARTOG, Rachel Irma
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    EnglandBritishCompany Managing Director181143840001
    LEMER, Claire
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    EnglandBritishDoctor147283010002
    LUDER, Fleurise Peurl
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    EnglandBritishCommercial Director238606200001
    MITCHELL, Simon Anthony
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    EnglandBritishChief Operating Officer310717760001
    NAGLER, Tristan Howard
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    United KingdomBritishCompany Director186180190002
    NISNER, Maxwell John
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    EnglandBritishChartered Accountant141299840001
    ROSENFELDER, Nicola Abigail, Dr
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    EnglandBritishConsultant Clinical Oncologist208018880001
    TAYLOR, Saul David
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    United KingdomBritishInvestment Manager238632260001
    ZINKIN, Jacqueline Malca
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    EnglandBritishAcademic, Retired261015630002
    BRAES, David
    10 Beechey Close
    Copthorne
    RH10 3LS Crawley
    West Sussex
    Secrétaire
    10 Beechey Close
    Copthorne
    RH10 3LS Crawley
    West Sussex
    British55072470001
    LEW, Jonathan Michael
    Flat 41 Eyre Court
    3-21 Finchley Road
    NW8 9TU London
    Secrétaire
    Flat 41 Eyre Court
    3-21 Finchley Road
    NW8 9TU London
    British47199820001
    LIGHTMAN, Susan
    22 Conway Road
    N14 7BA London
    Secrétaire
    22 Conway Road
    N14 7BA London
    BritishSolicitor100369000001
    LYONS, Barry Hugh
    14 Heathfielde
    Lyttelton Road
    NW11 6LT London
    Secrétaire
    14 Heathfielde
    Lyttelton Road
    NW11 6LT London
    British5498000001
    ANSELL, Anthony
    39 Crespigny Road
    Hendon
    NW4 3DU London
    Administrateur
    39 Crespigny Road
    Hendon
    NW4 3DU London
    BritishSolicitor31338370002
    BARNETT, Keith Philip
    27 Bancroft Avenue
    N2 0AR London
    Administrateur
    27 Bancroft Avenue
    N2 0AR London
    United KingdomBritishSolicitor97027530001
    BERMAN, Brian Anthony
    2 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    2 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    British IsraeliChartered Accountant5498010001
    COHEN, Malcolm Geoffrey, Dr
    Rose Lodge 1b Southway
    N20 8EB London
    Administrateur
    Rose Lodge 1b Southway
    N20 8EB London
    United KingdomBritishCompany Director60701120001
    COWEN, Anthony
    Six Lord Chancellor Walk
    KT2 7HG Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    Six Lord Chancellor Walk
    KT2 7HG Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishSolicitor109673090001
    CRAMER, David Marc
    1a Lyndhurst Gardens
    Finchley
    N3 1TA London
    Administrateur
    1a Lyndhurst Gardens
    Finchley
    N3 1TA London
    BritishChartered Accountant16404120005
    DEVRIES, Maurice
    52 Arundel Mansions
    Arundel Terrace Barnes
    SW13 9DS London
    Administrateur
    52 Arundel Mansions
    Arundel Terrace Barnes
    SW13 9DS London
    BritishSolicitor29364510001
    EDER, Andrew Howard Eric, Professor
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    EnglandBritishDentist238590400001
    ELSTEIN, Leslie Charles
    64 Uphill Road
    NW7 4QE London
    Administrateur
    64 Uphill Road
    NW7 4QE London
    BritishInformation Systems Manager31338380001
    FENTON, Stephen Richard Nigel
    Summerland Old Hall Drive
    HA5 4SW Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    Summerland Old Hall Drive
    HA5 4SW Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountant142367960001
    FISHER, Jonathan Simon
    Cherry Acre 2 Courtland Drive
    IG7 6PN Chigwell
    Essex
    Administrateur
    Cherry Acre 2 Courtland Drive
    IG7 6PN Chigwell
    Essex
    United KingdomBritishBarrister55506740001
    FORMAN, Stephen John
    51 Barham Avenue
    WD6 3PW Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    51 Barham Avenue
    WD6 3PW Elstree
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant28942040001
    FROSH, Sidney
    50 Lodge Close
    Canons Drive
    HA8 7RL Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    50 Lodge Close
    Canons Drive
    HA8 7RL Edgware
    Middlesex
    BritishManufacturer48879530001
    GOLDMAN, Stephen
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    EnglandBritishFinancial Adviser182169880001
    GOLDMEIER, Michael
    104 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4PA London
    Administrateur
    104 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4PA London
    EnglandBritishSolicitor44176570001
    GRANT, Alan
    2 Meadway
    Southgate
    N14 6NY London
    Administrateur
    2 Meadway
    Southgate
    N14 6NY London
    BritishSolicitor59522050001
    GROSS, Michael Martin Hugo
    155 Regents Park Road
    NW1 8BB London
    Administrateur
    155 Regents Park Road
    NW1 8BB London
    BritishProperty Director36069210001
    HARTNELL, Geoffrey Dennis
    Summerbreeze
    California Lane
    WD23 1EP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    Summerbreeze
    California Lane
    WD23 1EP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishIndependant Financial Advisor142099440001
    HOCHHAUSER, Simon, Dr
    The Lady Cottage
    Oak Hill Park
    NW3 7LG London
    Administrateur
    The Lady Cottage
    Oak Hill Park
    NW3 7LG London
    EnglandBritishManaging Director73154750003
    JACOBS, Jeremy Samuel
    34 Uxbridge Road
    HA7 3LQ Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    34 Uxbridge Road
    HA7 3LQ Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant48259330002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    United Synagogue
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    England
    19 sept. 2016
    Ballards Lane
    N12 8GB London
    305
    England
    Non
    Forme juridiqueRegistered Charity
    Pays d'enregistrementUnited Kingdon
    Autorité légaleCharities Act
    Lieu d'enregistrementCharities Act
    Numéro d'enregistrement242552
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 01 nov. 2004
    Livré le 03 nov. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    85 hamilton terrace london. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 03 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Third party legal charge
    Créé le 02 avr. 2004
    Livré le 20 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    85 hamiton terrace london NW8 9RH. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The central synagogue great portland street and 36,38 40 and 42 hallam street marylebone t/no 187746 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    90, marsh road pinner middlesex t/no mx 245410 and the proceeds of sale therof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    94, marsh road pinner middlesex t/no ngl 678102 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Woburn house upper woburn place euston london wc 1H t/no 435593 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    51 shirehall park golders green hendon london nw 4 t/no MX418406 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a golders green synagogue dunston road lndon NW11 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    Al monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a ilford synagogue 24/26 beehive ilford essex and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    88 marsh road pinner middlesex t/no NGL270411 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Cecil park garages cecil park pinner middlesex t/no MX441042 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due form the company and/or united synagogue on any account whatsoever
    Brèves mentions
    92 marsh road pinner middlesex t/no MX350049 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Cecil house cecil park pinner middlesex t/no MX298692 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1993
    Livré le 17 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Pinner synagogue marsh road pinner middlesex t/no NGL345090 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 20 août 1990
    Livré le 05 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000 under the terms of the charge
    Brèves mentions
    41 the ridgeway, hendon, london N.W.11.
    Personnes ayant droit
    • Spiritdale Limited.
    • Van-Tone Electronics Limited
    Transactions
    • 05 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 07 juin 1964
    Livré le 09 juin 1964
    En cours
    Montant garanti
    All monies due, etc.
    Brèves mentions
    24-32 (even) great cumberland place, 38 seymour st., And 13/16 quebec mews, st. Marylebone. London.
    Personnes ayant droit
    • Westminster Bank LTD.
    Transactions
    • 09 juin 1964Enregistrement d'une charge
    Charge of registered land
    Créé le 08 avr. 1963
    Livré le 23 avr. 1963
    En cours
    Montant garanti
    All monies due, etc.
    Brèves mentions
    24-32 (evens) great cumberland place, 38 leyman st., & 13-16 quebec mews.
    Personnes ayant droit
    • Westminster Bank LTD.
    Transactions
    • 23 avr. 1963Enregistrement d'une charge
    Deed of variation
    Créé le 26 févr. 1963
    Livré le 19 mars 1963
    En cours
    Montant garanti
    For varying the terms of a charge dated 26.10.33 and further charges supplemental thereto.
    Brèves mentions
    Woburn house, upper woburn place, london W.C.1.
    Personnes ayant droit
    • The Jewish Memorial Council
    Transactions
    • 19 mars 1963Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 21 juin 1960
    Livré le 30 juin 1960
    En cours
    Montant garanti
    All monies due etc.
    Brèves mentions
    24 to 32 (cons) great cumberland place, 38 seymour street, and 13 to 16 (cons) quebec mews st. Marylebone, london, together with the building erected thereon. Also all the companys estate interest on the agreements set out on the schedule thereto. See doc 23 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Westminster Bank LTD.
    Transactions
    • 30 juin 1960Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0