UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
Numéro de société | 00516140 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?
Adresse du siège social | 305 Ballards Lane N12 8GB London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 juil. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 18 juil. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 juil. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 2 pages | AA | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Tristan Howard Nagler en tant qu'administrateur le 17 juil. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Simon Anthony Mitchell en tant qu'administrateur le 17 juil. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Barry Clive Shaw en tant que directeur le 17 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Howard Eric Eder en tant que directeur le 17 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Jacqueline Malca Zinkin le 16 déc. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 2 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Rachel Irma Hartog en tant qu'administrateur le 19 juil. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Dr Nicola Abigail Rosenfelder en tant qu'administrateur le 22 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mrs Jacqueline Malca Zinkin en tant qu'administrateur le 22 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Leonie Lewis en tant que directeur le 22 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Doreen Sandra Samuels en tant que directeur le 22 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||
Nomination de Mr Saul David Taylor en tant qu'administrateur le 02 oct. 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREI, Saul David | Secrétaire | 109 Princes Park Avenue NW11 0JS London | British, | Solicitor | 96453010001 | |||||
GOLDSTEIN, Michael Howard | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | England | British | Chartered Accountant | 235899600001 | ||||
HARTOG, Rachel Irma | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | England | British | Company Managing Director | 181143840001 | ||||
LEMER, Claire | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | England | British | Doctor | 147283010002 | ||||
LUDER, Fleurise Peurl | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | England | British | Commercial Director | 238606200001 | ||||
MITCHELL, Simon Anthony | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | England | British | Chief Operating Officer | 310717760001 | ||||
NAGLER, Tristan Howard | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | United Kingdom | British | Company Director | 186180190002 | ||||
NISNER, Maxwell John | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | England | British | Chartered Accountant | 141299840001 | ||||
ROSENFELDER, Nicola Abigail, Dr | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | England | British | Consultant Clinical Oncologist | 208018880001 | ||||
TAYLOR, Saul David | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | United Kingdom | British | Investment Manager | 238632260001 | ||||
ZINKIN, Jacqueline Malca | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | England | British | Academic, Retired | 261015630002 | ||||
BRAES, David | Secrétaire | 10 Beechey Close Copthorne RH10 3LS Crawley West Sussex | British | 55072470001 | ||||||
LEW, Jonathan Michael | Secrétaire | Flat 41 Eyre Court 3-21 Finchley Road NW8 9TU London | British | 47199820001 | ||||||
LIGHTMAN, Susan | Secrétaire | 22 Conway Road N14 7BA London | British | Solicitor | 100369000001 | |||||
LYONS, Barry Hugh | Secrétaire | 14 Heathfielde Lyttelton Road NW11 6LT London | British | 5498000001 | ||||||
ANSELL, Anthony | Administrateur | 39 Crespigny Road Hendon NW4 3DU London | British | Solicitor | 31338370002 | |||||
BARNETT, Keith Philip | Administrateur | 27 Bancroft Avenue N2 0AR London | United Kingdom | British | Solicitor | 97027530001 | ||||
BERMAN, Brian Anthony | Administrateur | 2 Dorset Drive HA8 7NT Edgware Middlesex | British Israeli | Chartered Accountant | 5498010001 | |||||
COHEN, Malcolm Geoffrey, Dr | Administrateur | Rose Lodge 1b Southway N20 8EB London | United Kingdom | British | Company Director | 60701120001 | ||||
COWEN, Anthony | Administrateur | Six Lord Chancellor Walk KT2 7HG Kingston Upon Thames Surrey | England | British | Solicitor | 109673090001 | ||||
CRAMER, David Marc | Administrateur | 1a Lyndhurst Gardens Finchley N3 1TA London | British | Chartered Accountant | 16404120005 | |||||
DEVRIES, Maurice | Administrateur | 52 Arundel Mansions Arundel Terrace Barnes SW13 9DS London | British | Solicitor | 29364510001 | |||||
EDER, Andrew Howard Eric, Professor | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | England | British | Dentist | 238590400001 | ||||
ELSTEIN, Leslie Charles | Administrateur | 64 Uphill Road NW7 4QE London | British | Information Systems Manager | 31338380001 | |||||
FENTON, Stephen Richard Nigel | Administrateur | Summerland Old Hall Drive HA5 4SW Pinner Middlesex | England | British | Chartered Accountant | 142367960001 | ||||
FISHER, Jonathan Simon | Administrateur | Cherry Acre 2 Courtland Drive IG7 6PN Chigwell Essex | United Kingdom | British | Barrister | 55506740001 | ||||
FORMAN, Stephen John | Administrateur | 51 Barham Avenue WD6 3PW Elstree Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 28942040001 | ||||
FROSH, Sidney | Administrateur | 50 Lodge Close Canons Drive HA8 7RL Edgware Middlesex | British | Manufacturer | 48879530001 | |||||
GOLDMAN, Stephen | Administrateur | Ballards Lane N12 8GB London 305 | England | British | Financial Adviser | 182169880001 | ||||
GOLDMEIER, Michael | Administrateur | 104 Marsh Lane Mill Hill NW7 4PA London | England | British | Solicitor | 44176570001 | ||||
GRANT, Alan | Administrateur | 2 Meadway Southgate N14 6NY London | British | Solicitor | 59522050001 | |||||
GROSS, Michael Martin Hugo | Administrateur | 155 Regents Park Road NW1 8BB London | British | Property Director | 36069210001 | |||||
HARTNELL, Geoffrey Dennis | Administrateur | Summerbreeze California Lane WD23 1EP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | Independant Financial Advisor | 142099440001 | ||||
HOCHHAUSER, Simon, Dr | Administrateur | The Lady Cottage Oak Hill Park NW3 7LG London | England | British | Managing Director | 73154750003 | ||||
JACOBS, Jeremy Samuel | Administrateur | 34 Uxbridge Road HA7 3LQ Stanmore Middlesex | England | British | Accountant | 48259330002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Synagogue | 19 sept. 2016 | Ballards Lane N12 8GB London 305 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
UNITED SYNAGOGUE TRUSTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Créé le 01 nov. 2004 Livré le 03 nov. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 85 hamilton terrace london. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Third party legal charge | Créé le 02 avr. 2004 Livré le 20 avr. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 85 hamiton terrace london NW8 9RH. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The central synagogue great portland street and 36,38 40 and 42 hallam street marylebone t/no 187746 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 90, marsh road pinner middlesex t/no mx 245410 and the proceeds of sale therof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 94, marsh road pinner middlesex t/no ngl 678102 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Woburn house upper woburn place euston london wc 1H t/no 435593 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 51 shirehall park golders green hendon london nw 4 t/no MX418406 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/a golders green synagogue dunston road lndon NW11 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti Al monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/a ilford synagogue 24/26 beehive ilford essex and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 88 marsh road pinner middlesex t/no NGL270411 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Cecil park garages cecil park pinner middlesex t/no MX441042 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due form the company and/or united synagogue on any account whatsoever | |
Brèves mentions 92 marsh road pinner middlesex t/no MX350049 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Cecil house cecil park pinner middlesex t/no MX298692 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 févr. 1993 Livré le 17 févr. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or united synagogue to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Pinner synagogue marsh road pinner middlesex t/no NGL345090 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 20 août 1990 Livré le 05 sept. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti £50,000 under the terms of the charge | |
Brèves mentions 41 the ridgeway, hendon, london N.W.11. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 07 juin 1964 Livré le 09 juin 1964 | En cours | Montant garanti All monies due, etc. | |
Brèves mentions 24-32 (even) great cumberland place, 38 seymour st., And 13/16 quebec mews, st. Marylebone. London. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of registered land | Créé le 08 avr. 1963 Livré le 23 avr. 1963 | En cours | Montant garanti All monies due, etc. | |
Brèves mentions 24-32 (evens) great cumberland place, 38 leyman st., & 13-16 quebec mews. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of variation | Créé le 26 févr. 1963 Livré le 19 mars 1963 | En cours | Montant garanti For varying the terms of a charge dated 26.10.33 and further charges supplemental thereto. | |
Brèves mentions Woburn house, upper woburn place, london W.C.1. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 21 juin 1960 Livré le 30 juin 1960 | En cours | Montant garanti All monies due etc. | |
Brèves mentions 24 to 32 (cons) great cumberland place, 38 seymour street, and 13 to 16 (cons) quebec mews st. Marylebone, london, together with the building erected thereon. Also all the companys estate interest on the agreements set out on the schedule thereto. See doc 23 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0